PRESTOPLAN LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | PRESTOPLAN LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Activa |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 03521811 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de PRESTOPLAN LIMITED?
- fabricación de otros productos de carpintería y ebanistería para la construcción (16230) / Industrias manufactureras
¿Dónde se encuentra PRESTOPLAN LIMITED?
| Dirección de la sede social | Gate House Turnpike Road HP12 3NR High Wycombe Buckinghamshire |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de PRESTOPLAN LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| PRESTOPLAN PURPOSE BUILT LIMITED | 15 jun 1998 | 15 jun 1998 |
| DMWSL 226 LIMITED | 04 mar 1998 | 04 mar 1998 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de PRESTOPLAN LIMITED?
| Vencido | No |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 31 dic 2025 |
| Próximas cuentas vencen el | 30 sept 2026 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2024 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para PRESTOPLAN LIMITED?
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 03 abr 2027 |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación vence | 17 abr 2027 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 03 abr 2026 |
| Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para PRESTOPLAN LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Declaración de confirmación presentada el 03 abr 2026 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Nombramiento de Sara Hollowell como director el 01 oct 2025 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Jennifer Canty como director el 30 sept 2025 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de Jennifer Canty como secretario el 30 sept 2025 | 1 páginas | TM02 | ||
Nombramiento de Sara Hollowell como secretario el 01 oct 2025 | 2 páginas | AP03 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2024 | 15 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 03 abr 2025 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cese del nombramiento de Michael Andrew Lonnon como director el 09 dic 2024 | 1 páginas | TM01 | ||
Nombramiento de Miss Katherine Elizabeth Hindmarsh como director el 09 dic 2024 | 2 páginas | AP01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2023 | 16 páginas | AA | ||
Nombramiento de Jennifer Canty como secretario el 24 abr 2024 | 2 páginas | AP03 | ||
Cese del nombramiento de Omolola Olutomilayo Adedoyin como director el 24 abr 2024 | 1 páginas | TM01 | ||
Nombramiento de Jennifer Canty como director el 24 abr 2024 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Omolola Olutomilayo Adedoyin como secretario el 24 abr 2024 | 1 páginas | TM02 | ||
Declaración de confirmación presentada el 03 abr 2024 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cese del nombramiento de Molly Banham como secretario el 29 nov 2023 | 1 páginas | TM02 | ||
Nombramiento de Mrs Omolola Olutomilayo Adedoyin como secretario el 29 nov 2023 | 2 páginas | AP03 | ||
Nombramiento de Mrs Omolola Olutomilayo Adedoyin como director el 01 sept 2023 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Katherine Elizabeth Hindmarsh como director el 01 sept 2023 | 1 páginas | TM01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2022 | 16 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 03 abr 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2021 | 17 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 03 abr 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2020 | 18 páginas | AA | ||
Los registros se han trasladado a la ubicación de inspección registrada Highdown House Yeoman Way Worthing West Sussex BN99 3HH | 1 páginas | AD03 | ||
¿Quiénes son los directivos de PRESTOPLAN LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOLLOWELL, Sara | Secretario | Turnpike Road HP12 3NR High Wycombe Gate House Buckinghamshire | 340923840001 | |||||||
| HINDMARSH, Katherine Elizabeth | Director | Turnpike Road HP12 3NR High Wycombe Gate House Buckinghamshire United Kingdom | United Kingdom | British | 330353690001 | |||||
| HOLLOWELL, Sara | Director | Turnpike Road HP12 3NR High Wycombe Gate House Buckinghamshire | United Kingdom | British | 200486170001 | |||||
| ADEDOYIN, Omolola Olutomilayo | Secretario | Turnpike Road HP12 3 NR High Wycombe Gate House Bucks United Kingdom | 316494330001 | |||||||
| BANHAM, Molly | Secretario | Turnpike Road HP12 3NR High Wycombe Gate House Buckinghamshire United Kingdom | 263965980001 | |||||||
| CANTY, Jennifer | Secretario | Turnpike Road HP12 3NR High Wycombe Gate House Buckinghamshire | 322303170001 | |||||||
| CARR, Peter Anthony | Secretario | South Luffenham LE15 8NP Rutland Foxfoot House | British | 130306120001 | ||||||
| CLAPHAM, Colin Richard | Secretario | Turnpike Road HP12 3NR High Wycombe Gate House Buckinghamshire United Kingdom | 190569190001 | |||||||
| DE FEO, Caterina | Secretario | 42 The Crescent Hampton In Arden B92 0BP Solihull West Midlands | British | 58246930001 | ||||||
| HASTINGS, Jonathan Philip | Secretario | 7 Hanger Court Hanger Green W5 3ER London | British | 4733610001 | ||||||
| HOYLE, Arthur Philip | Secretario | 26 Forest Road Meols CH47 6AU Wirral Merseyside | British | 27199030002 | ||||||
| JORDAN, James John | Secretario | Grosvenor House 2 Church Lane NN6 6JP Stanford On Avon Northamptonshire | British | 120602100002 | ||||||
| LONNON, Michael Andrew, Mr. | Secretario | Turnpike Road HP12 3NR High Wycombe Gate House Buckinghamshire United Kingdom | British | 34521340004 | ||||||
| NUNN, Carol Jayne | Secretario | 4 Juniper Close NN12 6XP Towcester Northamptonshire | British | 116824870001 | ||||||
| STROBIN, Michael Anthony | Secretario | 8 Crowless Gardens WF14 9NZ Mirfield West Yorkshire | British | 67870630003 | ||||||
| TAHMASEBI, Khosrow | Secretario | The Paddocks 3 Lavender Close CR3 5DW Chaldon Common Surrey | British | 38518070001 | ||||||
| DM COMPANY SERVICES LIMITED | Secretario designado corporativo | 16 Charlotte Square EH2 4DF Edinburgh Midlothian | 900000320001 | |||||||
| ADEDOYIN, Omolola Olutomilayo | Director | Turnpike Road HP12 3 NR High Wycombe Gate House Bucks United Kingdom | England | British | 193735640001 | |||||
| ASHTON, Stephen Thurston | Director | 15 Kenyon Road Standish WN6 0NX Wigan Lancashire | British | 42093290001 | ||||||
| BEDFORD, John Anthony | Director | Bannerleigh Road Leigh Woods BS8 3PF Bristol Hillbrow North Somerset | England | British | 11549320001 | |||||
| CANTY, Jennifer | Director | Turnpike Road HP12 3NR High Wycombe Gate House Buckinghamshire | United Kingdom | British | 322288120001 | |||||
| CAWTHORN, Martin Nigel | Director | 27 Hammond Green Wellesbourne CV35 9EY Warwick | British | 85681380001 | ||||||
| CLAPHAM, Colin Richard | Director | Turnpike Road HP12 3NR High Wycombe Gate House Buckinghamshire United Kingdom | United Kingdom | British | 9684390001 | |||||
| CULLEN, Declan William | Director | Four Oaks Road Walton Summit Centre PR5 8AP Preston 366 United Kingdom | England | British | 125028890001 | |||||
| FARRINGTON, Peter Edmond Thomson | Director | Lydgate House Postbridge PL20 6TJ Yelverton Devon | British | 49188230002 | ||||||
| GAINHAM, John Bernard | Director | Beech Hurst Gardens Post Office Road WV5 7HQ Seisdon 1 Staffordshire England | England | British | 79548340001 | |||||
| HART, David Warne | Director | 20 Prince Rupert Road HR8 2FA Ledbury Herefordshire | British | 9131800002 | ||||||
| HINDMARSH, Katherine Elizabeth | Director | Turnpike Road HP12 3NR High Wycombe Gate House Buckinghamshire United Kingdom | United Kingdom | British | 257671040002 | |||||
| HOYLE, Arthur Philip | Director | 26 Forest Road Meols CH47 6AU Wirral Merseyside | British | 27199030002 | ||||||
| HOYLE, Arthur Philip | Director | 26 Forest Road Meols CH47 6AU Wirral Merseyside | British | 27199030002 | ||||||
| KEY, Philip Robertson | Director | Moor End Road Radwell MK43 7HY Bedford Yielden Cottage Bedfordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 133906560001 | |||||
| LAWTHER, Samuel David | Director | Stow Cottage Spaldwick Road, Stow Longa PE18 0TL Huntingdon Cambridgeshire | British | 41835460012 | ||||||
| LONNON, Michael Andrew, Mr. | Director | Turnpike Road HP12 3NR High Wycombe Gate House Buckinghamshire United Kingdom | United Kingdom | British | 34521340004 | |||||
| LOUGHNANE, Ian Robert | Director | Four Oaks Road Walton Summit Centre PR5 8AP Preston 366 United Kingdom | United Kingdom | British | 162574360001 | |||||
| O'FARRELL, Michael Patrick | Director | 41 Kernow Crescent Fishermead MK6 2LD Milton Keynes Buckinghamshire | Irish | 68359310001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de PRESTOPLAN LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wilson Connolly Holdings Limited | 06 abr 2016 | Turnpike Road HP12 3NR High Wycombe Gate House Buckinghamshire United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0