HELTER SKELTER AGENCY LIMITED

HELTER SKELTER AGENCY LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaHELTER SKELTER AGENCY LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 03522889
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de HELTER SKELTER AGENCY LIMITED?

    • Otras actividades recreativas y de entretenimiento n.c.p. (93290) / Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento

    ¿Dónde se encuentra HELTER SKELTER AGENCY LIMITED?

    Dirección de la sede social
    4 Pancras Square
    N1C 4AG London
    United Kingdom
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de HELTER SKELTER AGENCY LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    WORLD AGENCY LIMITED06 mar 199806 mar 1998

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de HELTER SKELTER AGENCY LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2018

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para HELTER SKELTER AGENCY LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    La acción de exclusión voluntaria ha sido suspendida

    1 páginasSOAS(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    legacy

    1 páginasSH20

    Estado de capital el 20 sept 2019

    • Capital: GBP 1
    3 páginasSH19

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06

    Cese del nombramiento de Boyd Johnston Muir como director el 02 sept 2019

    1 páginasTM01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2018

    7 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 10 mar 2019 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2017

    7 páginasAA

    Los registros se han trasladado a la dirección del domicilio social registrado 4 Pancras Square London N1C 4AG

    1 páginasAD04

    Cambio de datos del director Mr Boyd Johnston Muir el 23 jul 2018

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del secretario Mrs Abolanle Abioye el 23 jul 2018

    1 páginasCH03

    Domicilio social registrado cambiado de 364-366 Kensington High Street London W14 8NS a 4 Pancras Square London N1C 4AG el 23 jul 2018

    1 páginasAD01

    Modification des détails de Universal Srg Group Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 23 jul 2018

    2 páginasPSC05

    Declaración de confirmación presentada el 10 mar 2018 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    Cese del nombramiento de Richard Michael Constant como director el 28 jul 2017

    1 páginasTM01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2016

    7 páginasAA

    Nombramiento de Mr Paramjit Jassal como director el 18 may 2017

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Andrew Brown como director el 31 mar 2017

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr Simon Lloyd Carmel como director el 31 mar 2017

    2 páginasAP01

    Declaración de confirmación presentada el 10 mar 2017 con actualizaciones

    8 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2015

    7 páginasAA

    ¿Quiénes son los directivos de HELTER SKELTER AGENCY LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    ABIOYE, Abolanle
    Pancras Square
    N1C 4AG London
    4
    United Kingdom
    Secretario
    Pancras Square
    N1C 4AG London
    4
    United Kingdom
    British88802330001
    CARMEL, Simon Lloyd
    Pancras Square
    N1C 4AG London
    4
    United Kingdom
    Director
    Pancras Square
    N1C 4AG London
    4
    United Kingdom
    United KingdomBritish172950720001
    JASSAL, Paramjit
    Pancras Square
    N1C 4AG London
    4
    United Kingdom
    Director
    Pancras Square
    N1C 4AG London
    4
    United Kingdom
    United KingdomBritish16770570003
    JOY, Matthew Robert
    2 Chestnut Place
    KT21 2DY Ashtead
    Surrey
    Secretario
    2 Chestnut Place
    KT21 2DY Ashtead
    Surrey
    British115905420001
    METCALFE, Philip John
    5 Alba Court
    Alba Gardens
    NW11 6NP London
    Secretario
    5 Alba Court
    Alba Gardens
    NW11 6NP London
    British59138870001
    STANDING, Sarah Elizabeth Anne
    1 Pilsdon Close
    Inner Park Road Wimbledon
    SW19 6DR London
    Secretario
    1 Pilsdon Close
    Inner Park Road Wimbledon
    SW19 6DR London
    British41378870002
    COMBINED SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    Secretario designado corporativo
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    900000080001
    ASHURST, William Anthony
    Flat 6 Richardsons Mews
    W1T 6BS London
    Middlesex
    Director
    Flat 6 Richardsons Mews
    W1T 6BS London
    Middlesex
    United KingdomBritish123516100001
    BANKS, Emma Louise
    20 Rozel Road
    Clapham
    SW4 0EZ London
    Director
    20 Rozel Road
    Clapham
    SW4 0EZ London
    British40070490001
    BROWN, Andrew
    Kensington High Street
    W14 8NS London
    364-366
    United Kingdom
    Director
    Kensington High Street
    W14 8NS London
    364-366
    United Kingdom
    EnglandBritish163199590001
    CASS, Michael Trevor
    63 Evelyn Drive
    HA5 4RL Pinner
    Middlesex
    Director
    63 Evelyn Drive
    HA5 4RL Pinner
    Middlesex
    British2320620002
    CONSTANT, Richard Michael
    Kensington High Street
    W14 8NS London
    364-366
    United Kingdom
    Director
    Kensington High Street
    W14 8NS London
    364-366
    United Kingdom
    United KingdomBritish43836310003
    DAVIES, Hywel Hadley
    2b Florence Road
    W5 3TX London
    Director
    2b Florence Road
    W5 3TX London
    British13515170001
    FRANKLIN, Paul Robert
    Spurstow House
    Peckforton Hall Lane
    CW6 9TF Spurstow
    Cheshire
    Director
    Spurstow House
    Peckforton Hall Lane
    CW6 9TF Spurstow
    Cheshire
    British110798290001
    GREEK, Michael Daniel
    122 Glengall Road
    NW6 7HH London
    Director
    122 Glengall Road
    NW6 7HH London
    British94819480001
    HUFFAM, Ian Michael
    28 Great Jubilee Wharf
    78-80 Wapping Wall
    E1W 3TH London
    Director
    28 Great Jubilee Wharf
    78-80 Wapping Wall
    E1W 3TH London
    United KingdomBritish75681420002
    JACKSON, John William
    Sedgewick Park
    RH13 6QQ Nuthurst
    West Sussex
    Director
    Sedgewick Park
    RH13 6QQ Nuthurst
    West Sussex
    British13435320001
    METCALFE, Philip John
    5 Alba Court
    Alba Gardens
    NW11 6NP London
    Director
    5 Alba Court
    Alba Gardens
    NW11 6NP London
    British59138870001
    MILLER, Michael David
    High Trees 15a Linksway
    HA6 2XA Northwood
    Middlesex
    Director
    High Trees 15a Linksway
    HA6 2XA Northwood
    Middlesex
    United KingdomBritish44250870002
    MUIR, Boyd Johnston
    Pancras Square
    N1C 4AG London
    4
    United Kingdom
    Director
    Pancras Square
    N1C 4AG London
    4
    United Kingdom
    United StatesBritish172824510001
    NASH, Peter
    Flat F 9 Warwick Square
    SW1V 2AA London
    Director
    Flat F 9 Warwick Square
    SW1V 2AA London
    British75681480003
    TAYLOR, Andrew John
    The Bridge House Bisham Road
    SL7 1RP Marlow
    Buckinghamshire
    Director
    The Bridge House Bisham Road
    SL7 1RP Marlow
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish54448520001
    WALLACE, Paul Frederick
    Westfield House
    Nunnery Lane
    TN11 8HA Penshurst
    Kent
    Director
    Westfield House
    Nunnery Lane
    TN11 8HA Penshurst
    Kent
    EnglandBritish76655520001
    COMBINED NOMINEES LIMITED
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NA London
    Director designado corporativo
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NA London
    900000090001
    COMBINED SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    Director designado corporativo
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    900000080001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de HELTER SKELTER AGENCY LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Pancras Square
    N1C 4AG London
    4
    United Kingdom
    15 nov 2016
    Pancras Square
    N1C 4AG London
    4
    United Kingdom
    No
    Forma jurídicaLimited By Shares
    País de registroUnited Kingdom
    Autoridad legalUnited Kingdom
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro00284340
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.
    Kensington High Street
    W14 8NS London
    364-366
    United Kingdom
    06 abr 2016
    Kensington High Street
    W14 8NS London
    364-366
    United Kingdom
    Forma jurídicaLimited By Shares
    País de registroUnited Kingdom
    Autoridad legalUnited Kingdom
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro01890289
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.

    ¿Tiene HELTER SKELTER AGENCY LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Composite guarantee and debenture
    Creado el 14 jun 2002
    Entregado el 27 jun 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 27 jun 2002Registro de un cargo (395)
    • 16 sept 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Deed of amendment to a composite guarantee and debenture dated 29 october 1998 (the "deed")
    Creado el 11 ago 2000
    Entregado el 30 ago 2000
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All indebtedness liabilities and obligations due owing or incurred to the chargee under the mezzanine documents by any charging company (as defined)
    Breve descripción
    L/H property k/a 45-53 sinclair road, hammersmith, london t/no BGL14049 together with all buildings, fixtures and its fixed plant and machinery at any time thereon.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Abn Amro Causeway Mezzanine Partnership LP
    Transacciones
    • 30 ago 2000Registro de un cargo (395)
    • 10 may 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Deed of amendment to a composite guarantee and debenture dated 29 october 1998
    Creado el 01 jul 1999
    Entregado el 09 jul 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All indebtedness liabilities and obligations due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee pursuant to the terms of the mezzanine documents (as defined)
    Breve descripción
    All its f/h and l/h interest in the properties being the l/h property k/a 45-53 sinclair road,hammersmith,london t/no BGL14049 together with all buildings,fixtures (excluding in the case of l/h property landlord's fixtures but including other trade fixtures and excluding in the case of f/h property and l/h property which is let or sub-let to a third party,tenant's and trade fixtures and fittings of such third party) and its fixed plant and machinery at any time thereon.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • The Abn Amro Causeway Mezzanine Partnership LP
    Transacciones
    • 09 jul 1999Registro de un cargo (395)
    • 10 may 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Creado el 29 oct 1998
    Entregado el 17 nov 1998
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever pursuant to the terms of the mezzanine documents
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Abn Amro Causeway Mezzanine Partnership LP
    Transacciones
    • 17 nov 1998Registro de un cargo (395)
    • 10 may 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 26 oct 1998
    Entregado el 06 nov 1998
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 06 nov 1998Registro de un cargo (395)
    • 16 sept 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 07 sept 1998
    Entregado el 16 sept 1998
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 16 sept 1998Registro de un cargo (395)
    • 31 oct 1998Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0