HCSU26 LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración anual
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaHCSU26 LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 03542901
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de HCSU26 LIMITED?

    • Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales

    ¿Dónde se encuentra HCSU26 LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Chiltern House Garsington Road
    Cowley
    OX4 2PG Oxford
    England
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de HCSU26 LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    SUREPART SVG LIMITED06 abr 200006 abr 2000
    SVG LIMITED29 may 199829 may 1998
    FORAY 1095 LIMITED08 abr 199808 abr 1998

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de HCSU26 LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2012

    ¿Cuál es el estado de la última declaración anual para HCSU26 LIMITED?

    Declaración anual
    Última declaración anual

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para HCSU26 LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Domicilio social registrado cambiado de Unipart House Cowley Oxford OX4 2PG a Chiltern House Garsington Road Cowley Oxford OX4 2PG el 20 ago 2014

    1 páginasAD01

    Cancelación total de la carga 3

    2 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 4

    1 páginasMR04

    Déclaration annuelle établie au 08 abr 2014 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital14 abr 2014

    Estado de capital el 14 abr 2014

    • Capital: GBP 1,500,002
    SH01

    Nombramiento de Mrs Amanda Jane Wyner como director el 31 oct 2013

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Michael Royston Hopper como director el 31 oct 2013

    1 páginasTM01

    Cuentas preparadas hasta el 31 dic 2012

    6 páginasAA

    Certificado de cambio de nombre

    Company name changed surepart svg LIMITED\certificate issued on 10/05/13
    3 páginasCERTNM
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    change-of-name10 may 2013

    Cambio de nombre por resolución

    NM01
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    change-of-name

    Resolución de cambio de nombre de la empresa el 09 may 2013

    RES15

    Déclaration annuelle établie au 08 abr 2013 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01

    Cuentas preparadas hasta el 31 dic 2011

    6 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 08 abr 2012 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01

    Cuentas preparadas hasta el 31 dic 2010

    6 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 08 abr 2011 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01

    Cuentas preparadas hasta el 31 dic 2009

    6 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 08 abr 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01

    Cuentas preparadas hasta el 31 dic 2008

    6 páginasAA

    legacy

    4 páginas363a

    legacy

    1 páginas288b

    Cuentas preparadas hasta el 31 dic 2007

    6 páginasAA

    legacy

    4 páginas363a

    Cuentas preparadas hasta el 31 dic 2006

    6 páginasAA

    legacy

    1 páginas288a

    ¿Quiénes son los directivos de HCSU26 LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    RIMMER, Michael Douglas
    32 Watling Lane
    Dorchester On Thames
    OX10 7JG Wallingford
    Oxfordshire
    Secretario
    32 Watling Lane
    Dorchester On Thames
    OX10 7JG Wallingford
    Oxfordshire
    British48355360001
    DESSAIN, Paul Mark
    10 High Street
    Bodicote
    OX15 4BX Banbury
    Oxfordshire
    Director
    10 High Street
    Bodicote
    OX15 4BX Banbury
    Oxfordshire
    United KingdomBritish17182840001
    MOURGUE, Anthony John
    Brompton Gates
    170 Burley Road
    BH23 8DE Bransgore
    Dorset
    Director
    Brompton Gates
    170 Burley Road
    BH23 8DE Bransgore
    Dorset
    EnglandBritish17182830005
    WYNER, Amanda Jane
    Garsington Road
    Cowley
    OX4 2PG Oxford
    Chiltern House
    England
    Director
    Garsington Road
    Cowley
    OX4 2PG Oxford
    Chiltern House
    England
    EnglandBritish115512420001
    CLARKE, Joanna Lindsey
    10 Gordon Road
    Harborne
    B17 9HB Birmingham
    West Midlands
    Secretario
    10 Gordon Road
    Harborne
    B17 9HB Birmingham
    West Midlands
    British68391410001
    STAMP, Christopher David
    49 Grange Road
    Dorridge
    B93 8QS Solihull
    West Midlands
    Secretario
    49 Grange Road
    Dorridge
    B93 8QS Solihull
    West Midlands
    British44492580001
    CLARKE, Joanna Lindsey
    10 Gordon Road
    Harborne
    B17 9HB Birmingham
    West Midlands
    Director
    10 Gordon Road
    Harborne
    B17 9HB Birmingham
    West Midlands
    British68391410001
    DESSAIN, Paul Mark
    10 High Street
    Bodicote
    OX15 4BX Banbury
    Oxfordshire
    Director
    10 High Street
    Bodicote
    OX15 4BX Banbury
    Oxfordshire
    United KingdomBritish17182840001
    FISHER, Jacqueline
    926 Kingstanding Road
    B44 9NG Birmingham
    West Midlands
    Director designado
    926 Kingstanding Road
    B44 9NG Birmingham
    West Midlands
    British900013260001
    FORMAN, Paul Anthony
    Millfield
    Coln St Aldwyns Post Office
    GL7 5AN Cirencester
    Gloucestershire
    Director
    Millfield
    Coln St Aldwyns Post Office
    GL7 5AN Cirencester
    Gloucestershire
    British59639890001
    GOODEY, Nigel
    7 Yarnells Hill
    OX2 9BD Oxford
    Oxfordshire
    Director
    7 Yarnells Hill
    OX2 9BD Oxford
    Oxfordshire
    ScotlandBritish56600230001
    HEALEY, John Joseph
    38 Elizabeth Jennings Way
    OX2 7BN Oxford
    Oxfordshire
    Director
    38 Elizabeth Jennings Way
    OX2 7BN Oxford
    Oxfordshire
    United KingdomBritish48355090002
    HOPPER, Michael Royston
    Binn End
    Sibford Gower
    OX15 5RQ Banbury
    Oxfordshire
    Director
    Binn End
    Sibford Gower
    OX15 5RQ Banbury
    Oxfordshire
    EnglandBritish17182820001
    ROBERTS, Peter Tregarthen
    The Cottage Waldley
    Doveridge
    DE6 5LR Ashbourne
    Derbyshire
    Director
    The Cottage Waldley
    Doveridge
    DE6 5LR Ashbourne
    Derbyshire
    EnglandBritish55406540001
    SCOTT, Christopher George
    120 Lady Byron Lane
    Knowle
    B93 9BA Solihull
    West Midlands
    Director
    120 Lady Byron Lane
    Knowle
    B93 9BA Solihull
    West Midlands
    EnglandBritish94183390001
    TONKS, Steve
    1 Stable Close
    Finmere
    MK18 4AD Buckingham
    Buckinghamshire
    Director
    1 Stable Close
    Finmere
    MK18 4AD Buckingham
    Buckinghamshire
    British64091350001
    WRAGG, James Philip
    The Old Vicarage
    CV35 0HD Gaydon
    Warwickshire
    Director
    The Old Vicarage
    CV35 0HD Gaydon
    Warwickshire
    British77836880001

    ¿Tiene HCSU26 LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Second floating charge
    Creado el 19 dic 2003
    Entregado el 07 ene 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and each other company named therein to the secured parties or any of them under or pursuant to the asset ancillary agreements and/or the charge
    Breve descripción
    By way of second floating charge its undertaking and all its property assets and rights including its property situated in scotland. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC as Asset Ancillary Trustee for the Secured Parties (The "Asset Ancillary Trustee")
    Transacciones
    • 07 ene 2004Registro de un cargo (395)
    • 20 ago 2014Satisfacción de una carga (MR04)
    Non-vesting debts charge and first floating charge
    Creado el 19 dic 2003
    Entregado el 23 dic 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the secured parties or any of them under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    By way of first fixed charge all those of its present and future debts together with the related rights. By way of first floating charge its undertaking and all its property assets and rights whatsoever and wheresoever both present and future.. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited as Security Agent
    Transacciones
    • 23 dic 2003Registro de un cargo (395)
    • 20 ago 2014Satisfacción de una carga (MR04)
    Floating charge and guarantee
    Creado el 12 abr 2001
    Entregado el 25 abr 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All present and future obligations and liabilities of each obligaor to any lender under each finance document which such obligor is a party and tmi under the isda master agreement dated 18TH october 1999 (all terms as defined)
    Breve descripción
    Floating charge all its assets. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Hsbc Investment Bank PLC as Agent and Trustee for Itself and for Eachlender (The Security Trustee)
    Transacciones
    • 25 abr 2001Registro de un cargo (395)
    • 23 mar 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Floating charge and guarantee
    Creado el 29 sept 1999
    Entregado el 14 oct 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    In favour of the chargee all present and future obligations and liabilities due or to become due from each obligor to any transaction party under each transaction document to which such obligor is a party
    Breve descripción
    By way of a floating charge all its assets except for those contracts, to which it is a party, which by their terms prohibit the creation of a floating charge over or in respect of them.
    Personas con derecho
    • Hsbc Investment Bank PLC (The "Security Trustee")
    Transacciones
    • 14 oct 1999Registro de un cargo (395)
    • 23 mar 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0