WESTONE HOTEL ACQUISITIONS COMPANY

WESTONE HOTEL ACQUISITIONS COMPANY

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaWESTONE HOTEL ACQUISITIONS COMPANY
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad privada sin límite de capital
    Número de empresa 03543429
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de WESTONE HOTEL ACQUISITIONS COMPANY?

    • Actividades de otras sociedades holding n.c.o.p. (64209) / Actividades financieras y de seguros

    ¿Dónde se encuentra WESTONE HOTEL ACQUISITIONS COMPANY?

    Dirección de la sede social
    27 Knightsbridge
    SW1X 7LY London
    United Kingdom
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de WESTONE HOTEL ACQUISITIONS COMPANY?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    BLACKSTONE HOTEL ACQUISITIONS COMPANY03 abr 199803 abr 1998

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de WESTONE HOTEL ACQUISITIONS COMPANY?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2021

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para WESTONE HOTEL ACQUISITIONS COMPANY?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2021

    16 páginasAA

    legacy

    2 páginasSH20

    Estado de capital el 15 jul 2022

    • Capital: GBP 1
    5 páginasSH19

    legacy

    2 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06

    Declaración de confirmación presentada el 03 mar 2022 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cambio de datos del director Mr Jeremy David Cape el 22 nov 2021

    3 páginasCH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2020

    17 páginasAA

    Cambio de datos del director Mr Jeremy David Cape el 05 ago 2021

    2 páginasCH01

    Declaración de confirmación presentada el 03 mar 2021 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    incorporation

    Resolución de adopción de los Artículos de Asociación

    RES01

    Memorándum y Estatutos

    12 páginasMA

    Nombramiento de Mr Jeremy David Cape como director el 25 feb 2021

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr Nasir Pasha como director el 25 feb 2021

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Mahmoud Raafat como director el 25 feb 2021

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Liam Cunningham como director el 25 feb 2021

    1 páginasTM01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2019

    17 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 03 mar 2020 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2018

    21 páginasAA

    Modification des détails de Raglan Real Estate Acquisition Company en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 01 ago 2019

    5 páginasPSC05

    Domicilio social registrado cambiado de C/O Maybourne Hotel Group 41-43 Brook Street Mayfair London W1K 4HJ England a 27 Knightsbridge London SW1X 7LY el 01 ago 2019

    1 páginasAD01

    Declaración de confirmación presentada el 03 mar 2019 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    ¿Quiénes son los directivos de WESTONE HOTEL ACQUISITIONS COMPANY?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    CAPE, Jeremy David
    SW1X 7LY London
    27 Knightsbridge
    United Kingdom
    Director
    SW1X 7LY London
    27 Knightsbridge
    United Kingdom
    QatarBritish,Argentine280421610001
    PASHA, Nasir
    SW1X 7LY London
    27 Knightsbridge
    United Kingdom
    Director
    SW1X 7LY London
    27 Knightsbridge
    United Kingdom
    QatarBritish280348180001
    SOCKER, Marc Nathan
    SW1X 7LY London
    27 Knightsbridge
    United Kingdom
    Director
    SW1X 7LY London
    27 Knightsbridge
    United Kingdom
    United KingdomBritish253588970001
    DOWD, Thomas Patrick
    Tisrara
    Ballyowen Lane
    Lucan
    Co Dublin
    Ireland
    Secretario
    Tisrara
    Ballyowen Lane
    Lucan
    Co Dublin
    Ireland
    Irish93945640001
    EDWARDS, Sara Louise
    6 Mardle Close
    LU1 4EZ Caddington
    Bedfordshire
    Secretario
    6 Mardle Close
    LU1 4EZ Caddington
    Bedfordshire
    British108281650001
    FRANCE, Malcolm Ronald
    34 Tybenham Road
    SW19 3LA London
    Secretario
    34 Tybenham Road
    SW19 3LA London
    British50060390001
    FRANCE, Malcolm Ronald
    34 Tybenham Road
    SW19 3LA London
    Secretario
    34 Tybenham Road
    SW19 3LA London
    British50060390001
    GIBBONS, Clive Anthony
    5 Four Acre Coppice
    RG27 9NF Hook
    Hampshire
    Secretario
    5 Four Acre Coppice
    RG27 9NF Hook
    Hampshire
    British74719200002
    GRAY, Jonathan David
    200 East 72nd Street
    New York
    Ny 10021
    Usa
    Secretario
    200 East 72nd Street
    New York
    Ny 10021
    Usa
    Usa65836770001
    WALKER, Carole
    c/o Maybourne Hotel Group
    Brook Street
    Mayfair
    W1K 4HJ London
    41-43
    England
    Secretario
    c/o Maybourne Hotel Group
    Brook Street
    Mayfair
    W1K 4HJ London
    41-43
    England
    British138522860001
    ALDEN, Stephen Jude
    c/o Maybourne Hotel Group
    Vine Street
    Mayfair
    W1J 0AH London
    1
    England
    Director
    c/o Maybourne Hotel Group
    Vine Street
    Mayfair
    W1J 0AH London
    1
    England
    United KingdomMaltese115411150008
    ALLEN, David Weston
    8 Merton Walk
    Mount Saint Annes
    6 Milltown
    Dublin
    Ireland
    Director
    8 Merton Walk
    Mount Saint Annes
    6 Milltown
    Dublin
    Ireland
    Irish99989350001
    BAKHOS, Fady
    c/o Maybourne Hotel Group
    Brook Street
    Mayfair
    W1K 4HJ London
    41-43
    England
    Director
    c/o Maybourne Hotel Group
    Brook Street
    Mayfair
    W1K 4HJ London
    41-43
    England
    QatarFrench206158260001
    BARRACK JR, Thomas Joseph
    PO BOX 358
    Santa Ynez
    California 93460
    Usa
    Director
    PO BOX 358
    Santa Ynez
    California 93460
    Usa
    American58370240001
    CERIALE, John Victor
    13 Prospect Road
    Westport
    Ct 06880
    Usa
    Director
    13 Prospect Road
    Westport
    Ct 06880
    Usa
    Usa65836740001
    CUNNINGHAM, Liam
    SW1X 7LY London
    27 Knightsbridge
    United Kingdom
    Director
    SW1X 7LY London
    27 Knightsbridge
    United Kingdom
    IrelandIrish198255770001
    DONNELLY, Peter Joseph
    104 Avoca Park
    Blackrock
    Co. Dublin
    Republic Of Ireland
    Director
    104 Avoca Park
    Blackrock
    Co. Dublin
    Republic Of Ireland
    IrelandIrish93945650001
    DOWD, Thomas Patrick
    Tisrara
    Ballyowen Lane
    Lucan
    Co Dublin
    Ireland
    Director
    Tisrara
    Ballyowen Lane
    Lucan
    Co Dublin
    Ireland
    United KingdomIrish93945640001
    EDWARDS, Sara Louise
    6 Mardle Close
    LU1 4EZ Caddington
    Bedfordshire
    Director
    6 Mardle Close
    LU1 4EZ Caddington
    Bedfordshire
    United KingdomBritish108281650001
    FRANCE, Malcolm Ronald
    34 Tybenham Road
    SW19 3LA London
    Director
    34 Tybenham Road
    SW19 3LA London
    United KingdomBritish50060390001
    GIBBONS, Clive Anthony
    5 Four Acre Coppice
    RG27 9NF Hook
    Hampshire
    Director
    5 Four Acre Coppice
    RG27 9NF Hook
    Hampshire
    EnglandBritish74719200002
    GRAY, Jonathan David
    200 East 72nd Street
    New York
    Ny 10021
    Usa
    Director
    200 East 72nd Street
    New York
    Ny 10021
    Usa
    Usa65836770001
    HENNEBRY, Mark Nicholas
    C/O Maybourne Hotels Ltd
    30 Old Burlington Street
    W1S 3AR Mayfair London
    Director
    C/O Maybourne Hotels Ltd
    30 Old Burlington Street
    W1S 3AR Mayfair London
    IrelandIrish128404490001
    KUKRAL, John Zavertnik
    8 Rocky Point Road
    Old Greenwich
    Connecticut
    06870
    Usa
    Director
    8 Rocky Point Road
    Old Greenwich
    Connecticut
    06870
    Usa
    United StatesAmerican167484790001
    MCKENNA, Geraldine Maria Martina
    31 Clancarty Road
    SW6 3AH London
    Director
    31 Clancarty Road
    SW6 3AH London
    United KingdomIrish93995420001
    RAAFAT, Mahmoud
    SW1X 7LY London
    27 Knightsbridge
    United Kingdom
    Director
    SW1X 7LY London
    27 Knightsbridge
    United Kingdom
    QatarEgyptian271030610001
    REYNOLDS, Paul
    30 Bradbourne Street
    SW6 3TE London
    Director
    30 Bradbourne Street
    SW6 3TE London
    EnglandBritish108281880001
    SEELINGER, Lisa Eleonora
    C/O Maybourne Hotels Ltd
    30 Old Burlington Street
    W1S 3AR Mayfair London
    Director
    C/O Maybourne Hotels Ltd
    30 Old Burlington Street
    W1S 3AR Mayfair London
    United KingdomAmerican128749960002
    WALKER, Carole
    c/o Maybourne Hotel Group
    Brook Street
    Mayfair
    W1K 4HJ London
    41-43
    England
    Director
    c/o Maybourne Hotel Group
    Brook Street
    Mayfair
    W1K 4HJ London
    41-43
    England
    EnglandBritish138522860001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de WESTONE HOTEL ACQUISITIONS COMPANY?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Raglan Real Estate Acquisition Company
    Knightsbridge
    SW1X 7LY London
    27
    06 abr 2016
    Knightsbridge
    SW1X 7LY London
    27
    No
    Forma jurídicaPrivate Unlimited Company
    País de registroEngland & Wales
    Autoridad legalEngland & Wales
    Lugar de registroCompanies House, England & Wales
    Número de registro03558968
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.

    ¿Tiene WESTONE HOTEL ACQUISITIONS COMPANY alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    A registered charge
    Creado el 23 ene 2015
    Entregado el 30 ene 2015
    Satisfecho en su totalidad
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Capita Trust Company Limited as Common Security Trustee (As Trustee for Each of the Finance Parties)
    Transacciones
    • 30 ene 2015Registro de una carga (MR01)
    • 11 nov 2015Satisfacción de una carga (MR04)
    Debenture
    Creado el 28 dic 2012
    Entregado el 08 ene 2013
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each debtor to any common secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Capita Trust Company Limited
    Transacciones
    • 08 ene 2013Registro de un cargo (MG01)
    • 11 nov 2015Satisfacción de una carga (MR04)
    Debenture
    Creado el 01 abr 2011
    Entregado el 12 abr 2011
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due to the chargee and each finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Anglo Irish Bank Corporation Limited
    Transacciones
    • 12 abr 2011Registro de un cargo (MG01)
    • 06 feb 2013Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Charge over a bank account
    Creado el 01 abr 2011
    Entregado el 12 abr 2011
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from any obligor to any of the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    The account and the account balance. See image for full details.
    Personas con derecho
    • Anglo Irish Bank Corporation Limited
    Transacciones
    • 12 abr 2011Registro de un cargo (MG01)
    • 06 feb 2013Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Debenture
    Creado el 30 may 2008
    Entregado el 19 jun 2008
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each obligor to the finance parties or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC (The “Security Trustee”)
    Transacciones
    • 19 jun 2008Registro de un cargo (395)
    • 06 feb 2013Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Debenture
    Creado el 30 may 2008
    Entregado el 19 jun 2008
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each obligor to the secured parties or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland (The “Security Trustee”)
    Transacciones
    • 19 jun 2008Registro de un cargo (395)
    • 06 feb 2013Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Account charge
    Creado el 29 jun 2006
    Entregado el 19 jul 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    All of its present and future rights title interest and benefit whatsoever present and future in and to the interest reserve account and the interest reserve account balance. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland (The Security Trustee)
    Transacciones
    • 19 jul 2006Registro de un cargo (395)
    • 06 feb 2013Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Account charge
    Creado el 23 sept 2005
    Entregado el 13 oct 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the secured parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    All rights title interest and benefit in and to the interest reserve account and the interest reserve account balance. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland (The Security Trustee)
    Transacciones
    • 13 oct 2005Registro de un cargo (395)
    • 06 feb 2013Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Debenture
    Creado el 23 sept 2005
    Entregado el 11 oct 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the secured parties or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings and fixtures,. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland (The Security Trustee)
    Transacciones
    • 11 oct 2005Registro de un cargo (395)
    • 10 nov 2005Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad de una carga flotante ha sido liberada (403b)
    • 06 feb 2013Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Debenture
    Creado el 14 may 2004
    Entregado el 03 jun 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the obligors to the secured parties or any of them under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC in Its Capacity as Trustee for the Secured Parties (Thesecurity Trustee)
    Transacciones
    • 03 jun 2004Registro de un cargo (395)
    • 11 oct 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Junior mortgage of shares
    Creado el 05 ene 1999
    Entregado el 15 ene 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All present and future obligations and liabilities due or to become due from the company to the chargee (as security trustee for the finance parties) andto the finance (junior agent) parties (as defined) under each finance document (as defined) to which the company is a party
    Breve descripción
    All the shares; and all related rights accruing to the shares.
    Personas con derecho
    • Bankers Trust Company
    Transacciones
    • 15 ene 1999Registro de un cargo (395)
    • 02 jul 2003Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad de una carga flotante ha sido liberada (403b)
    • 05 ago 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Senior mortgage of shares
    Creado el 05 ene 1999
    Entregado el 15 ene 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All present and future obligations and liabilities due or to become due from the company to the chargee (as security trustee for the finance parties) and to the finance parties (as defined) under each finance document (as defined) to which the company is a party
    Breve descripción
    All the shares; and all related rights accrusing to the shares.
    Personas con derecho
    • Bankers Trust Company
    Transacciones
    • 15 ene 1999Registro de un cargo (395)
    • 02 jul 2003Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad de una carga flotante ha sido liberada (403b)
    • 25 ago 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Deed of amendment and restatement(originally dated 7/4/98)
    Creado el 30 abr 1998
    Entregado el 09 may 1998
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to any finance party under each finance document to which the company is a party
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Bankers Trust Company(As Agent and Trustee for the Finance Parties)
    Transacciones
    • 09 may 1998Registro de un cargo (395)
    • 30 abr 1999Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad de una carga flotante ha sido liberada (403b)
    • 25 ago 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture between the company and merrill lynch international (the security trustee),as amended by the deed of amendment and restatement dated 30/4/98
    Creado el 07 abr 1998
    Entregado el 11 abr 1998
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All present and future obligations and liabilities whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever of the company to any finance party under each finance document to which the company is a party
    Breve descripción
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Merrill Lynch International (The Security Trustee) as Agent and Trustee for the Finance Parties
    Transacciones
    • 11 abr 1998Registro de un cargo (395)
    • 30 abr 1999Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad de una carga flotante ha sido liberada (403b)
    • 10 oct 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0