TOR HOMES

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración anual
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaTOR HOMES
    Estado de la empresaConvertida/Cerrada
    Forma jurídicaConvertida o cerrada
    Número de empresa 03555476
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de TOR HOMES?

    • (7020) /

    ¿Dónde se encuentra TOR HOMES?

    Dirección de la sede social
    Tor House
    St Peters Quay
    TQ9 5SH Totnes
    Devon
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de TOR HOMES?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    SOUTH HAMS HOUSING29 abr 199829 abr 1998

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de TOR HOMES?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 mar 2011

    ¿Cuál es el estado de la última declaración anual para TOR HOMES?

    Declaración anual
    Última declaración anual

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para TOR HOMES?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Certificado de registro de una Sociedad de Socorros Mutuos

    CERTIPS

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resoluciones

    Convert to I & ps 19/10/2011
    RES13

    Misceláneos

    Forms b and z to convert to I & ps
    2 páginasMISC

    legacy

    4 páginasMG02

    Cese del nombramiento de Julian Brazil como director

    1 páginasTM01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2011

    36 páginasAA

    Cese del nombramiento de John Walker como director

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Cllr Tom Holway como director

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr Julian Brazil como director

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Shonaugh Rankin como director

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Francis Hawke como director

    1 páginasTM01

    Déclaration annuelle établie au 17 abr 2011, aucune liste de membres fournie

    13 páginasAR01

    Cambio de datos del director Mrs Eileen Horton el 05 ago 2010

    2 páginasCH01

    Cese del nombramiento de Gareth Bourton como director

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mrs Eileen Horton como director

    2 páginasAP01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2010

    36 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 17 abr 2010, aucune liste de membres fournie

    8 páginasAR01

    Cambio de datos del director Robert Michael Ray Hatfield el 17 abr 2010

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Robert Simons el 17 abr 2010

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Sylvia Frampton el 05 oct 2009

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Councillor Shonaugh Rankin el 17 abr 2010

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Pauline Nanette Seymour el 17 abr 2010

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Gareth Bourton el 17 abr 2010

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Mr Michael Saltern el 17 abr 2010

    2 páginasCH01

    Cese del nombramiento de Dorothy Robertson como director

    2 páginasTM01

    ¿Quiénes son los directivos de TOR HOMES?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    TONKIN, Andrew John
    3 Grenville Court
    Plympton
    PL7 2WL Plymouth
    Secretario
    3 Grenville Court
    Plympton
    PL7 2WL Plymouth
    British62981480003
    CARSON, Bryan Edward
    The Byre
    Easton Bigbury
    TQ7 4AN Kingsbridge
    Devon
    Director
    The Byre
    Easton Bigbury
    TQ7 4AN Kingsbridge
    Devon
    EnglandBritish26222440001
    FACKS-MARTIN, Graham Angus
    Wyndley Hollies Road
    St Stephens
    PL15 8HB Launceston
    Cornwall
    Director
    Wyndley Hollies Road
    St Stephens
    PL15 8HB Launceston
    Cornwall
    United KingdomBritish60701600001
    FRAMPTON, Sylvia
    Yealm Park
    Yealmpton
    PL8 2NR Plymouth
    17
    Devon
    United Kingdom
    Director
    Yealm Park
    Yealmpton
    PL8 2NR Plymouth
    17
    Devon
    United Kingdom
    United KingdomBritish133741060002
    HATFIELD, Robert Michael Ray
    Clyng Mill
    Kingston
    TQ7 4HA Kingsbridge
    Devon
    Director
    Clyng Mill
    Kingston
    TQ7 4HA Kingsbridge
    Devon
    EnglandBritish90771990002
    HOLWAY, Tom, Cllr
    Tor House
    St Peters Quay
    TQ9 5SH Totnes
    Devon
    Director
    Tor House
    St Peters Quay
    TQ9 5SH Totnes
    Devon
    United KingdomBritish161415050001
    HORTON, Eileen
    Tor House
    St Peters Quay
    TQ9 5SH Totnes
    Devon
    Director
    Tor House
    St Peters Quay
    TQ9 5SH Totnes
    Devon
    United KingdomBritish154355510001
    SALTERN, Michael Francis
    98 Cleeve Drive
    PL21 9BS Ivybridge
    Devon
    Director
    98 Cleeve Drive
    PL21 9BS Ivybridge
    Devon
    EnglandBritish123297550001
    SEYMOUR, Pauline Nanette
    8 Trebblepark Walk
    TQ7 1QR Kingsbridge
    South Devon
    Director
    8 Trebblepark Walk
    TQ7 1QR Kingsbridge
    South Devon
    United KingdomBritish58326600001
    SIMONS, Robert Edgar
    11 Meadow View Close
    EX10 9AP Sidmouth
    Devon
    Director
    11 Meadow View Close
    EX10 9AP Sidmouth
    Devon
    EnglandBritish123297400001
    HICKEY, Brian Denis
    7 Staple Orchard
    Dartington
    TQ9 6FJ Totnes
    Devon
    Secretario
    7 Staple Orchard
    Dartington
    TQ9 6FJ Totnes
    Devon
    British58039950003
    AUSTEN, Lance, Cllr
    10 Acland Road
    PL21 9UR Ivybridge
    Devon
    Director
    10 Acland Road
    PL21 9UR Ivybridge
    Devon
    British71140840002
    BEER, Jeffrey Stuart
    Westcombe
    Old Plymouth Road
    TQ7 1AT Kingsbridge
    Devon
    Director
    Westcombe
    Old Plymouth Road
    TQ7 1AT Kingsbridge
    Devon
    British23671330001
    BOURTON, Gareth Mark
    22 Grange Road
    TQ12 5PJ Abbotskerswell
    Devon
    Director
    22 Grange Road
    TQ12 5PJ Abbotskerswell
    Devon
    EnglandBritish214822760001
    BRAZIL, Julian
    Tor House
    St Peters Quay
    TQ9 5SH Totnes
    Devon
    Director
    Tor House
    St Peters Quay
    TQ9 5SH Totnes
    Devon
    United KingdomBritish161409230001
    CALLARD, Patricia Jane
    3 Faulkner Close
    Townstal
    TQ6 9LH Dartmouth
    Devon
    Director
    3 Faulkner Close
    Townstal
    TQ6 9LH Dartmouth
    Devon
    British58326700001
    CARTER, William George
    89 Westonfields
    Bridgetown
    TQ9 5UA Totnes
    Devon
    Director
    89 Westonfields
    Bridgetown
    TQ9 5UA Totnes
    Devon
    British58326780001
    EDWARDS, Araminta
    8 Tuckahoe
    Mill Green
    MK43 8ET Turvey
    Director
    8 Tuckahoe
    Mill Green
    MK43 8ET Turvey
    British54623490002
    FRAYLING, Andrew Michael
    35 Follaton
    Plymouth Road
    TQ9 5ND Totnes
    Devon
    Director
    35 Follaton
    Plymouth Road
    TQ9 5ND Totnes
    Devon
    British55477220001
    GREY, Steve Kenneth
    8 Icy Park
    Aveton Gifford
    TQ7 4LQ Kingsbridge
    Devon
    Director
    8 Icy Park
    Aveton Gifford
    TQ7 4LQ Kingsbridge
    Devon
    British58326640001
    HANNAFORD, Robert Mark
    3 Ferndale
    TQ6 9QU Dartmouth
    Devon
    Director
    3 Ferndale
    TQ6 9QU Dartmouth
    Devon
    British65151210001
    HARVEY, Vera Ann
    2 Cottage
    66 Fore Street
    TQ9 5RX Totnes
    Devon
    Director
    2 Cottage
    66 Fore Street
    TQ9 5RX Totnes
    Devon
    British73400780001
    HAWKE, Francis John
    69 Britannia Avenue
    TQ6 9JZ Dartmouth
    Devon
    Director
    69 Britannia Avenue
    TQ6 9JZ Dartmouth
    Devon
    United KingdomBritish123745760001
    HERRING, Michael Charles Leonard
    7 Mead Drive
    Thurlestone
    TQ7 3TA Kingsbridge
    Devon
    Director
    7 Mead Drive
    Thurlestone
    TQ7 3TA Kingsbridge
    Devon
    EnglandBritish47182020004
    HITCHINS, Patrick William
    The Beeches Bickleigh Down Road
    Roborough
    PL6 7AD Plymouth
    Devon
    Director
    The Beeches Bickleigh Down Road
    Roborough
    PL6 7AD Plymouth
    Devon
    BritainBritish3321150001
    LONGRIGG, Ian
    Broadridge House
    Tideford Cornworthy
    TQ9 7HL Totnes
    Devon
    Director
    Broadridge House
    Tideford Cornworthy
    TQ9 7HL Totnes
    Devon
    British66648990002
    LOWE, Brian
    124 Fore Street
    TQ7 1AW Kingsbridge
    Devon
    Director
    124 Fore Street
    TQ7 1AW Kingsbridge
    Devon
    United KingdomBritish13906370002
    MAWBY, Niku
    Thornleigh
    107 Lodge Road
    B93 0HG Solihull
    West Midlands
    Director
    Thornleigh
    107 Lodge Road
    B93 0HG Solihull
    West Midlands
    EnglandBritish82432440001
    MORLEY, Chris, Dr
    Mill House Yealmbridge
    Yealmpton
    PL8 2EQ Plymouth
    Devon
    Director
    Mill House Yealmbridge
    Yealmpton
    PL8 2EQ Plymouth
    Devon
    British58039940001
    PEARCE, Joanna Rosemary
    73 Yealm Park
    Yealmpton
    PL8 2NS Plymouth
    Devon
    Director
    73 Yealm Park
    Yealmpton
    PL8 2NS Plymouth
    Devon
    British58776150002
    PEARSE, Brian Gerald, Sir
    The Old Granary Upton
    South Milton
    TQ7 3JF Kingsbridge
    Devon
    Director
    The Old Granary Upton
    South Milton
    TQ7 3JF Kingsbridge
    Devon
    British48316650002
    PRENDERGRAST, Bothea
    1 Ashwood
    Courtenay Park
    TQ10 9PH South Brent
    Devon
    Director
    1 Ashwood
    Courtenay Park
    TQ10 9PH South Brent
    Devon
    British64368040001
    PROCTOR, Keith Tredwen
    Ferry House
    Duncannon Stoke Gabriel
    TQ9 6QY Totnes
    Devon
    Director
    Ferry House
    Duncannon Stoke Gabriel
    TQ9 6QY Totnes
    Devon
    United KingdomBritish79022700001
    RANKIN, Shonaugh, Councillor
    The Retreat 2 Clarence Place
    South Milton
    TQ7 3JQ Kingsbridge
    Devon
    Director
    The Retreat 2 Clarence Place
    South Milton
    TQ7 3JQ Kingsbridge
    Devon
    United KingdomBritish91932640001
    ROBERTSON, Dorothy Helen
    Hyne Town
    TQ6 0RT Strete
    27
    Devon
    Director
    Hyne Town
    TQ6 0RT Strete
    27
    Devon
    British133873950001

    ¿Tiene TOR HOMES alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Fixed charge
    Creado el 15 ago 2008
    Entregado el 22 ago 2008
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each obligor to the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Property 1-11 (inc) the yeolands and other land stoke gabriel t/no DN101903, 2 faulkner close dartmouth DN1028975 and land at the green newton ferrers t/no DN411611 (for further details of properties charged please refer to form 395) together with all buildings and fixtures all plant and machinery the insurances see image for full details.
    Personas con derecho
    • Prudential Trustee Company Limited as Security Trustee for the Beneficiaries
    Transacciones
    • 22 ago 2008Registro de un cargo (395)
    Deed of assignment relating to council sale agreements dated 22 march 1999 and
    Creado el 22 jul 2008
    Entregado el 26 jul 2008
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each obligor to all beneficiaries and all other monies due or to become due from an obligor to the security trustee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Right title and interest from time to time in to and under each of the council sale agreements and any amount becoming payable to it pursuant thereto. See image for full details.
    Personas con derecho
    • Devon and Cornwall Treasury Limited
    Transacciones
    • 26 jul 2008Registro de un cargo (395)
    • 28 jul 2008
    Supplemental legal charge
    Creado el 03 dic 2004
    Entregado el 21 dic 2004
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to each finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    F/H 13 princes road east torquay t/no DN72527, f/h 150 hele road torquay t/no DN134667, f/h 39 luscombe road paignton t/no DN128752 for details of further properties charged please refer to form 395 plant and machinery, insurances, licences consents and authorisations, covenants under leasing documents, all agreements. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Prudential Trustee Company Limited
    Transacciones
    • 21 dic 2004Registro de un cargo (395)
    Supplemental legal charge
    Creado el 27 dic 2000
    Entregado el 05 ene 2001
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    £77,000,000. due from the company to the chargee
    Breve descripción
    The f/h and l/h property k/a 17 deer park ivybridge t/n DN175326 13 victory road dartmouth t/n DN307015 9 brook view follaton totnes t/n DN426360. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Prudential Trustee Company Limited
    Transacciones
    • 05 ene 2001Registro de un cargo (395)
    Charge on cash
    Creado el 22 mar 1999
    Entregado el 08 abr 1999
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the finance documents (as defined)
    Breve descripción
    All moneys standing to the credit of each of the proceeds accounts and the debts thereby. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Prudential Trustee Company Limited,as Agent and Trustee of the Security Constituted Under Thedeed for Itself and the Lenders (As Defined)
    Transacciones
    • 08 abr 1999Registro de un cargo (395)
    Debenture
    Creado el 22 mar 1999
    Entregado el 08 abr 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the finance documents (as defined) and under the issuer loan agreement (as defined)
    Breve descripción
    All secured liabilities over land/premises known as lifeline house,station rd,totnes,devon; DN290121; all buildings/fixtures thereon and proceeds of sale thereof; all plant machinery and benefit of insurances,consents,etc.various other properties listed. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Prudential Trustee Company Limited,as Agent and Trustee of the Security Constituted by the Deedfor Itself and the Lenders (As Defined)
    Transacciones
    • 08 abr 1999Registro de un cargo (395)
    • 20 oct 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0