FLEXIBLE SUPPORT OPTIONS (UK DOMICILIARY) LIMITED

FLEXIBLE SUPPORT OPTIONS (UK DOMICILIARY) LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaFLEXIBLE SUPPORT OPTIONS (UK DOMICILIARY) LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 03558925
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de FLEXIBLE SUPPORT OPTIONS (UK DOMICILIARY) LIMITED?

    • (9999) /

    ¿Dónde se encuentra FLEXIBLE SUPPORT OPTIONS (UK DOMICILIARY) LIMITED?

    Dirección de la sede social
    84a High Street
    CM12 9BT Billericay
    Essex
    United Kingdom
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de FLEXIBLE SUPPORT OPTIONS (UK DOMICILIARY) LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    ACTIVE CARE (DOMICILIARY) LIMITED06 may 199806 may 1998

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de FLEXIBLE SUPPORT OPTIONS (UK DOMICILIARY) LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 oct 2010

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para FLEXIBLE SUPPORT OPTIONS (UK DOMICILIARY) LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación obligatoria

    1 páginasGAZ2

    Nombramiento de Mr David John Loftus como director el 31 jul 2012

    2 páginasAP01

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación obligatoria

    1 páginasGAZ1

    Cese del nombramiento de Ian James White como director el 31 jul 2012

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Ian White como secretario el 31 jul 2012

    1 páginasTM02

    legacy

    3 páginasMG02

    Nombramiento de Ms Christine Cameron como director el 02 mar 2012

    2 páginasAP01

    Exercice comptable précédent raccourci du 31 oct 2012 au 02 mar 2012

    1 páginasAA01

    Cese del nombramiento de Michael Davide como director el 02 mar 2012

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Baldev Singh Ladhar como director el 02 mar 2012

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Armajit Singh Ladhar como director el 02 mar 2012

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Armajit Singh Ladhar como secretario el 02 mar 2012

    1 páginasTM02

    Nombramiento de Mr Ian White como secretario el 02 mar 2012

    2 páginasAP03

    Nombramiento de Mr Ian James White como director el 02 mar 2012

    2 páginasAP01

    Domicilio social registrado cambiado de 15-16 Stockholm Close Tyne Tunnel Trading Estate North Shields Tyne &Wear NE29 7SF el 26 mar 2012

    1 páginasAD01

    Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 oct 2010

    7 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 10 may 2011 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital21 jun 2011

    Estado de capital el 21 jun 2011

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 oct 2009

    9 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 10 may 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01

    Cambio de datos del director Michael Davide el 10 may 2010

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Baldev Singh Ladhar el 10 may 2010

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Armajit Singh Ladhar el 10 may 2010

    2 páginasCH01

    Renuncia del auditor

    1 páginasAUD

    legacy

    3 páginasMG02

    legacy

    3 páginasMG02

    ¿Quiénes son los directivos de FLEXIBLE SUPPORT OPTIONS (UK DOMICILIARY) LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    CAMERON, Christine Isabel
    High Street
    CM12 9BT Billericay
    84a
    Essex
    United Kingdom
    Director
    High Street
    CM12 9BT Billericay
    84a
    Essex
    United Kingdom
    United KingdomBritish167809310001
    LOFTUS, David John
    High Street
    CM12 9BT Billericay
    84a
    Essex
    United Kingdom
    Director
    High Street
    CM12 9BT Billericay
    84a
    Essex
    United Kingdom
    EnglandBritish34443080001
    DAVISON, Kevin
    5 Riversdale Close
    Millrace Park Blackhall Mill
    NE17 7LW Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Secretario
    5 Riversdale Close
    Millrace Park Blackhall Mill
    NE17 7LW Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    British58542350001
    DAVISON, Robert Walter
    48 Kepier Chare
    NE40 4UR Crawcrook
    Tyne & Wear
    Secretario
    48 Kepier Chare
    NE40 4UR Crawcrook
    Tyne & Wear
    British58542470001
    LADHAR, Armajit Singh
    103 The Avenue
    Wallsend
    NE28 6SD Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Secretario
    103 The Avenue
    Wallsend
    NE28 6SD Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Indian82918910002
    WHITE, Ian
    High Street
    CM12 9BT Billericay
    84a
    Essex
    United Kingdom
    Secretario
    High Street
    CM12 9BT Billericay
    84a
    Essex
    United Kingdom
    167830840001
    DMCS SECRETARIES LIMITED
    7 Leonard Street
    EC2A 4AQ London
    Secretario designado corporativo
    7 Leonard Street
    EC2A 4AQ London
    900006030001
    CAIN, Leslie
    3 Ainderby Road
    Throckley
    NE15 9DQ Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Director
    3 Ainderby Road
    Throckley
    NE15 9DQ Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    British100933450001
    DAVIDE, Michael
    67 Links Avenue
    NE26 1TF Whitley Bay
    Tyne & Wear
    Director
    67 Links Avenue
    NE26 1TF Whitley Bay
    Tyne & Wear
    EnglandBritish108531230001
    DAVISON, Caroline
    5 Riversdale Close
    Millrace Park Blackhall Mill
    NE17 7LW Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Director
    5 Riversdale Close
    Millrace Park Blackhall Mill
    NE17 7LW Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    British72942620001
    DAVISON, Kevin
    5 Riversdale Close
    Millrace Park Blackhall Mill
    NE17 7LW Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Director
    5 Riversdale Close
    Millrace Park Blackhall Mill
    NE17 7LW Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    British58542350001
    DAVISON, Robert Walter
    48 Kepier Chare
    NE40 4UR Crawcrook
    Tyne & Wear
    Director
    48 Kepier Chare
    NE40 4UR Crawcrook
    Tyne & Wear
    British58542470001
    LADHAR, Armajit Singh
    103 The Avenue
    Wallsend
    NE28 6SD Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Director
    103 The Avenue
    Wallsend
    NE28 6SD Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    EnglandIndian82918910002
    LADHAR, Baldev Singh
    103 The Avenue
    Wallsend
    NE28 6SD Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Director
    103 The Avenue
    Wallsend
    NE28 6SD Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    EnglandBritish92390260001
    WHITE, Ian James
    High Street
    CM12 9BT Billericay
    84a
    Essex
    United Kingdom
    Director
    High Street
    CM12 9BT Billericay
    84a
    Essex
    United Kingdom
    EnglandBritish133383410003
    DMCS DIRECTORS LIMITED
    7 Leonard Street
    EC2A 4AQ London
    Director designado corporativo
    7 Leonard Street
    EC2A 4AQ London
    900004430001

    ¿Tiene FLEXIBLE SUPPORT OPTIONS (UK DOMICILIARY) LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Debenture
    Creado el 31 jul 2009
    Entregado el 12 ago 2009
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personas con derecho
    • The Co-Operative Bank P.L.C.
    Transacciones
    • 12 ago 2009Registro de un cargo (395)
    • 27 mar 2012Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Mortgage debenture
    Creado el 26 ago 2004
    Entregado el 03 sept 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Aib Group (UK) PLC
    Transacciones
    • 03 sept 2004Registro de un cargo (395)
    • 17 oct 2009Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Legal mortgage
    Creado el 26 ago 2004
    Entregado el 03 sept 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/H property k/a land and buildings on the north east side of struthers road high spen t/no TY369642. By way of specific charge the goodwill and connection of the business or businesses and also by way of floating security all moveable plant machinery implements furniture equipment stock-in-trade work in progress and other chattels.
    Personas con derecho
    • Aib Group (UK) PLC
    Transacciones
    • 03 sept 2004Registro de un cargo (395)
    • 17 oct 2009Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Debenture
    Creado el 05 oct 2000
    Entregado el 11 oct 2000
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Hsbc Bank PLC
    Transacciones
    • 11 oct 2000Registro de un cargo (395)
    • 29 dic 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0