LOGOPLASTE BRIDGWATER LIMITED
Visión general
Nombre de la empresa | LOGOPLASTE BRIDGWATER LIMITED |
---|---|
Estado de la empresa | Disuelta |
Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
Número de empresa | 03572037 |
Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
Fecha de constitución | |
Fecha de cese |
Resumen
Tiene PSCs súper seguros | No |
---|---|
Tiene gravámenes | Sí |
Tiene historial de insolvencia | No |
La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de LOGOPLASTE BRIDGWATER LIMITED?
- Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas
¿Dónde se encuentra LOGOPLASTE BRIDGWATER LIMITED?
Dirección de la sede social | Apex Plaza Forbury Road RG1 1AX Reading Berkshire |
---|---|
Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de LOGOPLASTE BRIDGWATER LIMITED?
Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
---|---|---|
LOGOPASTE BRIDGWATER LIMITED | 03 oct 2008 | 03 oct 2008 |
SUNNY-PLAST LIMITED | 30 nov 1998 | 30 nov 1998 |
WATERFRONT NOMINEE 3 LIMITED | 28 may 1998 | 28 may 1998 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de LOGOPLASTE BRIDGWATER LIMITED?
Vencido | Sí |
---|---|
Próximas cuentas | |
Próximo período contable finaliza el | 31 dic 2012 |
Próximas cuentas vencen el | 30 sept 2013 |
Últimas cuentas | |
Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2011 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para LOGOPLASTE BRIDGWATER LIMITED?
Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de C/O Haines Watts 7-11 Station Road Reading Berkshire RG1 1LG a Apex Plaza Forbury Road Reading Berkshire RG1 1AX el 14 dic 2016 | 2 páginas | AD01 | ||||||||||
Restauración por orden judicial | 5 páginas | AC92 | ||||||||||
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 4 páginas | DS01 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | SH20 | ||||||||||
Estado de capital el 27 dic 2012
| 4 páginas | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | CAP-SS | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 3 páginas | MG02 | ||||||||||
legacy | 3 páginas | MG02 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 28 may 2012 avec liste complète des actionnaires | 8 páginas | AR01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2011 | 18 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 28 may 2011 avec liste complète des actionnaires | 8 páginas | AR01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2010 | 19 páginas | AA | ||||||||||
Cese del nombramiento de Stephen Mancey como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Misceláneos Section 519 | 2 páginas | MISC | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 28 may 2010 avec liste complète des actionnaires | 7 páginas | AR01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2009 | 21 páginas | AA | ||||||||||
Cambio de datos del director Jose Ortigao Ramos el 14 oct 2009 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Alexandre Carlos Mello Vieira Costa Relvas el 14 oct 2009 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Nigel Paul Sladden el 14 oct 2009 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de LOGOPLASTE BRIDGWATER LIMITED?
Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRAZER, Angus Luff Thomas | Secretario | Forbury Road RG1 1AX Reading Apex Plaza Berkshire United Kingdom | British | 120782660001 | ||||||
DE BOTTON, Filipe Mauricio | Director | Forbury Road RG1 1AX Reading Apex Plaza Berkshire United Kingdom | Portugal | Portuguese | Company Director | 66927790001 | ||||
HILLBURN, Lisa | Director | Forbury Road RG1 1AX Reading Apex Plaza Berkshire United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 120784440002 | ||||
MELLO VIEIRA COSTA RELVAS, Alexandre Carlos | Director | Forbury Road RG1 1AX Reading Apex Plaza Berkshire United Kingdom | Portugal | Portuguese | Company Director | 66496910002 | ||||
RAMOS, Jose Ortigao | Director | Forbury Road RG1 1AX Reading Apex Plaza Berkshire United Kingdom | Portugal | Portuguese | Director | 139083960001 | ||||
SLADDEN, Nigel Paul | Director | Forbury Road RG1 1AX Reading Apex Plaza Berkshire United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 137403340001 | ||||
FAISCA, Paulo | Secretario | Flat 1 64 Gosbrook Road, Caversham RG4 8BS Reading Berkshire | British | 108255010002 | ||||||
MELLO VIEIRA COSTA RELVAS, Alexandre Carlos | Secretario | Rua Da Imprensa Nacional 75 Sobreloja P-1250 Lisboa Portugal | Portuguese | Company Director | 66496910001 | |||||
PRIESTLEY, Caroline Dawn | Secretario | 93 Ruskin Henley Road Caversham RG4 6LF Reading Berkshire | British | Company Director | 114232240002 | |||||
QUEIROZ NETO, Francisco Maria Campos Monteiro | Secretario | Rua Conde De Avranches 6593/3 FOREIGN Porto 4200-011 Portugal | Portuguese | Company Director | 89218290001 | |||||
SOROMENHO DE ALVITO, Pedro Manuel David | Secretario | Azinhaga Das Travessas Quinta Do Conde B1 3 Paco Do Lumiar FOREIGN P-1600 Lisboa Portugal | British | 62972110001 | ||||||
VINCX, Alain Christian Jaques | Secretario | Duinviool Jesstraat 16-41 Knokke Helst B-8300 Belgium | Belgian | Director | 62026810001 | |||||
WEST, Stephen | Secretario | 22 Turpins Way SG7 6LW Baldock Hertfordshire | British | 105347490001 | ||||||
ST JAMES SECRETARIES LIMITED | Secretario corporativo | 1 Georges Square Bath Street BS1 6BA Bristol | 89176110001 | |||||||
CAMPOS DESIDERIO, Jose Manuel Pedroso | Director | Padholme Road PE1 5JA Peterborough 161 Cambridgeshire | Portuguese | Company Director | 114232530002 | |||||
CORREA DA SILVA AMARAL, Marcelo | Director | Estrada Da Torre, Nr. 100 Edificio Cascais Atrium, Apartamento 808 2750-768 Cascais Portugal | Portuguese | Group Cfo | 124985450001 | |||||
DAVID SOROMENHO DE ALVITO, Pedro Manuel | Director | Azinhaga Das Travessas Quinta Do Conde B1 3 Paco Do Lumiar P-1600 Lisboa Portugal | Portuguese | Company Director | 61787730001 | |||||
MANCEY, Stephen John | Director | Forbury Road RG1 1AX Reading Apex Plaza Berkshire United Kingdom | British | Company Director | 74658160003 | |||||
PRIESTLEY, Caroline Dawn | Director | 93 Ruskin Henley Road Caversham RG4 6LF Reading Berkshire | British | Company Director | 114232240002 | |||||
QUEIROZ NETO, Francisco Maria Campos Monteiro | Director | Rua Conde De Avranches 6593/3 FOREIGN Porto 4200-011 Portugal | Portuguese | Company Director | 89218290001 | |||||
QUIGLEY, Martin Rae | Director | New Road HP16 OEU Little Kingshill 71 Bucks | United Kingdom | British | Director | 188979860001 | ||||
VINX, Alain Christian Jacques | Director | Duinviool Jesstraat 16/41 B-83oo Knokke Helst Belgium | Belgian | Director | 61787140001 | |||||
ST JAMES DIRECTORS LIMITED | Director corporativo | 1 Georges Square Bath Street BS1 6BA Bristol | 84059680002 |
¿Tiene LOGOPLASTE BRIDGWATER LIMITED alguna carga?
Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
---|---|---|---|---|
Mortgage | Creado el 22 dic 2004 Entregado el 30 dic 2004 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada £1,000,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción One uniloy milacon model UR10Z7-7HYD blow moulding machine serial no NO1A0100019,one uniloy milacon model UR6X11-7HYD extrusion blow moulding machine serial no. N01A100027,one-pint standard jug mould,cavtiies and trim package as per uniloy milacon invoice no.388320-5 Dated 08/05/03 together with all accessories and component parts and all improvements and renewals therof together also with all books,manuals,handbooks,technical data,drawings,schedules and other documentation. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Debenture | Creado el 29 mar 1999 Entregado el 30 mar 1999 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Debenture | Creado el 08 mar 1999 Entregado el 13 mar 1999 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0