WILLIAM COOK MACHINE SHOP (TOW LAW) LIMITED

WILLIAM COOK MACHINE SHOP (TOW LAW) LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaWILLIAM COOK MACHINE SHOP (TOW LAW) LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 03576124
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de WILLIAM COOK MACHINE SHOP (TOW LAW) LIMITED?

    • (9999) /

    ¿Dónde se encuentra WILLIAM COOK MACHINE SHOP (TOW LAW) LIMITED?

    Dirección de la sede social
    93 Queen Street
    S1 1WF Sheffield
    South Yorkshire
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de WILLIAM COOK MACHINE SHOP (TOW LAW) LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    WILLIAM COOK BLAIR MACHINE SHOP LIMITED29 oct 199829 oct 1998
    IMCO (1898) LIMITED04 jun 199804 jun 1998

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de WILLIAM COOK MACHINE SHOP (TOW LAW) LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta27 mar 2010

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para WILLIAM COOK MACHINE SHOP (TOW LAW) LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de acreedores

    14 páginas4.72

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo extraordinario para la liquidación el 05 ago 2011

    LRESEX

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 04 ago 2012

    14 páginas4.68

    Domicilio social registrado cambiado de 93 Queen Street Sheffield South Yorkshire S1 1WF England el 18 ago 2011

    1 páginasAD01

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    1 páginas600

    Declaración de asuntos con el formulario adjunto 4.19

    5 páginas4.20

    Domicilio social registrado cambiado de Parkway Avenue Sheffield S9 4UL el 07 jul 2011

    1 páginasAD01

    Déclaration annuelle établie au 04 jun 2011 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital07 jun 2011

    Estado de capital el 07 jun 2011

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Cuentas completas preparadas hasta el 27 mar 2010

    14 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 04 jun 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01

    Cuentas completas preparadas hasta el 28 mar 2009

    15 páginasAA

    legacy

    3 páginas363a

    Cuentas completas preparadas hasta el 29 mar 2008

    17 páginasAA

    Resoluciones

    Resolutions
    3 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resoluciones

    Re guarnatee / debenture & intercreditior deed 29/01/2008
    RES13

    legacy

    4 páginas363a

    legacy

    8 páginas395

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2007

    17 páginasAA

    legacy

    7 páginas363s

    Cuentas completas preparadas hasta el 01 abr 2006

    17 páginasAA

    legacy

    1 páginas403a

    legacy

    7 páginas363s

    legacy

    7 páginas395

    Cuentas completas preparadas hasta el 02 abr 2005

    16 páginasAA

    legacy

    1 páginas288b

    ¿Quiénes son los directivos de WILLIAM COOK MACHINE SHOP (TOW LAW) LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    HOUGHTON, Michael Barry
    8 The Old Saw Mill
    Cowling
    BD22 0JT Keighley
    West Yorkshire
    Secretario
    8 The Old Saw Mill
    Cowling
    BD22 0JT Keighley
    West Yorkshire
    British109567330001
    COOK, Andrew John, Sir
    Reduit
    Le Variouf Forest
    GY8 0BH Guernsey
    Channel Islands
    Director
    Reduit
    Le Variouf Forest
    GY8 0BH Guernsey
    Channel Islands
    EnglandBritish102659430002
    GRAYLEY, Kevin John
    Dove Cottage
    23 Mill Farm Drive Newmillerdam
    WF2 6QP Wakefield
    West Yorkshire
    Director
    Dove Cottage
    23 Mill Farm Drive Newmillerdam
    WF2 6QP Wakefield
    West Yorkshire
    EnglandBritish43273780002
    AUSTIN, John Alan
    1 Hollincross Lane
    SK13 8JQ Glossop
    Derbyshire
    Secretario
    1 Hollincross Lane
    SK13 8JQ Glossop
    Derbyshire
    British99402330001
    BARTLE, Thomas
    18 Ringwood Way
    Hemsworth
    WF9 4HZ Pontefract
    West Yorkshire
    Secretario
    18 Ringwood Way
    Hemsworth
    WF9 4HZ Pontefract
    West Yorkshire
    British79918800001
    CALDWELL, John Christopher
    282 Ecclesall Road South
    S11 9PS Sheffield
    South Yorkshire
    Secretario
    282 Ecclesall Road South
    S11 9PS Sheffield
    South Yorkshire
    British83552520001
    COOK, David Laurence
    30 Hargreaves Close
    Morley
    LS27 9TE Leeds
    West Yorkshire
    Secretario
    30 Hargreaves Close
    Morley
    LS27 9TE Leeds
    West Yorkshire
    British92183980001
    MOORE, Peter John
    Flat 3 Osborne Court
    154 Osborne Road
    S11 9BB Sheffield
    Secretario
    Flat 3 Osborne Court
    154 Osborne Road
    S11 9BB Sheffield
    British43273740002
    UPRICHARD, Andrew
    1 Alexandra Road
    SK17 9NQ Buxton
    Derbyshire
    Secretario designado
    1 Alexandra Road
    SK17 9NQ Buxton
    Derbyshire
    British900006640001
    BARTLE, Thomas
    18 Ringwood Way
    Hemsworth
    WF9 4HZ Pontefract
    West Yorkshire
    Director
    18 Ringwood Way
    Hemsworth
    WF9 4HZ Pontefract
    West Yorkshire
    British79918800001
    CALDWELL, John Christopher
    282 Ecclesall Road South
    S11 9PS Sheffield
    South Yorkshire
    Director
    282 Ecclesall Road South
    S11 9PS Sheffield
    South Yorkshire
    EnglandBritish83552520001
    CLARK, Ross Mckenzie
    15 Hall Farm Grove
    Hoylandswaine
    S36 7LJ Barnsley
    South Yorkshire
    Director designado
    15 Hall Farm Grove
    Hoylandswaine
    S36 7LJ Barnsley
    South Yorkshire
    British900016690001
    DEAN, David James
    15 Tremaine Close
    Hartside
    TS27 3LE Hartlepool
    Teeside
    Director
    15 Tremaine Close
    Hartside
    TS27 3LE Hartlepool
    Teeside
    EnglandBritish90981030001
    KITE, Philip John
    Garden House Town Farm
    NE43 7UL Newton
    Northumberland
    Director
    Garden House Town Farm
    NE43 7UL Newton
    Northumberland
    United KingdomBritish43273920002
    MOORE, Peter John
    Flat 3 Osborne Court
    154 Osborne Road
    S11 9BB Sheffield
    Director
    Flat 3 Osborne Court
    154 Osborne Road
    S11 9BB Sheffield
    British43273740002
    SIMKINS, Angela
    Hambleton View Kirby Hill
    Boroughbridge
    YO51 9DS York
    Director
    Hambleton View Kirby Hill
    Boroughbridge
    YO51 9DS York
    United KingdomBritish60263960001

    ¿Tiene WILLIAM COOK MACHINE SHOP (TOW LAW) LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Composite guarantee and debenture
    Creado el 29 ene 2008
    Entregado el 08 feb 2008
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from any group company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • William Cook Holdings Limited
    Transacciones
    • 08 feb 2008Registro de un cargo (395)
    Composite guarantee and debenture
    Creado el 29 jun 2006
    Entregado el 04 jul 2006
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from any group company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Catton foundry cross green approach leeds t/n WYK458821, inkerman tow law county durham t/n DU169329, bond isle works stanhope durham t/n DU178165 for details of further properties charged please refer to form 395 fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Trustees of the Aj Cook Pension Scheme
    Transacciones
    • 04 jul 2006Registro de un cargo (395)
    Debenture
    Creado el 17 ago 2004
    Entregado el 27 ago 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the royal bank of scotland PLC and barclays bank PLC on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC (Security Trustee)
    Transacciones
    • 27 ago 2004Registro de un cargo (395)
    • 03 oct 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Creado el 17 ago 2004
    Entregado el 26 ago 2004
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All present and future obligations and liabilities of all or any group company to the chargee under or pursuant to any finance document under the terms of the debenture
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Andrew John Cook Cbe (As Security Trustee for the Security Beneficiaries)
    Transacciones
    • 26 ago 2004Registro de un cargo (395)
    Dede of adherence (to a composite guanrantee and debenture date 23 january 1998)
    Creado el 30 oct 1998
    Entregado el 17 nov 1998
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All indebtedness liabilities and payment obligations which are as at 30 october 1998 may at any time hereafter be due owing or incurred in any manner whatsoever by any group company (as defined) to the chargee as security trustee for the beneficiaries whether pursuant to the guarantee or otherwise
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 17 nov 1998Registro de un cargo (395)

    ¿Tiene WILLIAM COOK MACHINE SHOP (TOW LAW) LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    07 ene 2014Fecha de disolución
    05 ago 2011Inicio de la liquidación
    Liquidación voluntaria de acreedores
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    John Russell
    The P & A Partnership 93 Queen Street
    S1 1WF Sheffield
    Profesional
    The P & A Partnership 93 Queen Street
    S1 1WF Sheffield
    Andrew Philip Wood
    The P & A Partnership 93 Queen Street
    S1 1WF Sheffield
    Profesional
    The P & A Partnership 93 Queen Street
    S1 1WF Sheffield

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0