JOHN LAING SOCIAL INFRASTRUCTURE LIMITED
Visión general
Nombre de la empresa | JOHN LAING SOCIAL INFRASTRUCTURE LIMITED |
---|---|
Estado de la empresa | Disuelta |
Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
Número de empresa | 03576132 |
Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
Fecha de constitución | |
Fecha de cese |
Resumen
Tiene PSCs súper seguros | No |
---|---|
Tiene gravámenes | Sí |
Tiene historial de insolvencia | No |
La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de JOHN LAING SOCIAL INFRASTRUCTURE LIMITED?
- Intermediación financiera no clasificada en otra parte (64999) / Actividades financieras y de seguros
- Actividades de oficinas centrales (70100) / Actividades profesionales, científicas y técnicas
¿Dónde se encuentra JOHN LAING SOCIAL INFRASTRUCTURE LIMITED?
Dirección de la sede social | 1 Kingsway WC2B 6AN London |
---|---|
Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de JOHN LAING SOCIAL INFRASTRUCTURE LIMITED?
Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
---|---|---|
EQUION LIMITED | 02 jul 2004 | 02 jul 2004 |
EQUION PLC | 11 dic 2000 | 11 dic 2000 |
LAING HYDER PLC | 03 sept 1998 | 03 sept 1998 |
CYBERSTAGE PLC | 04 jun 1998 | 04 jun 1998 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de JOHN LAING SOCIAL INFRASTRUCTURE LIMITED?
Últimas cuentas | |
---|---|
Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2019 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para JOHN LAING SOCIAL INFRASTRUCTURE LIMITED?
Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 1 páginas | DS01 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | SH20 | ||||||||||
Estado de capital el 19 jul 2021
| 4 páginas | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | CAP-SS | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 2 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 04 jun 2021 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas consolidadas preparadas hasta el 31 dic 2019 | 23 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 04 jun 2020 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas consolidadas preparadas hasta el 31 dic 2018 | 23 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 04 jun 2019 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Nombramiento de Emily Martin como secretario el 08 may 2019 | 2 páginas | AP03 | ||||||||||
Nombramiento de Mrs Clare Underwood como director el 31 ene 2019 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Christopher Brian Waples como director el 31 ene 2019 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Philip Naylor como secretario el 18 ene 2019 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Cuentas consolidadas preparadas hasta el 31 dic 2017 | 26 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 04 jun 2018 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Carolyn Tracy Cattermole como director el 29 mar 2018 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Carolyn Tracy Cattermole como secretario el 29 mar 2018 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 04 jun 2017 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas consolidadas preparadas hasta el 31 dic 2016 | 31 páginas | AA | ||||||||||
Nombramiento de Mr Stuart Martin Colvin como director el 31 mar 2017 | 3 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Ms Carolyn Tracy Cattermole como director el 31 mar 2017 | 3 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Derek Potts como director el 31 mar 2017 | 2 páginas | TM01 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de JOHN LAING SOCIAL INFRASTRUCTURE LIMITED?
Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARTIN, Emily | Secretario | Kingsway WC2B 6AN London 1 | 258403470001 | |||||||
COLVIN, Stuart Martin | Director | Kingsway WC2B 6AN London 1 | England | British | Chartered Accountant | 99643100002 | ||||
UNDERWOOD, Clare | Director | Kingsway WC2B 6AN London 1 | England | British | Accountant | 250549100002 | ||||
CATTERMOLE, Carolyn Tracy | Secretario | Kingsway WC2B 6AN London 1 | British | 172669190001 | ||||||
CURTIS, Richard Gregory | Secretario | 92 Beacons Park LD3 9BQ Brecon Powys | British | 34503940003 | ||||||
DUNBAR, Angela | Secretario | Cilsaig 16 Pentrepoeth Road SA15 4HH Llanelli Dyfed | British | 61341260001 | ||||||
GEORGE, John Philip | Secretario | 11 Nantfawr Road CF23 6JQ Cardiff South Glamorgan | British | 72272750003 | ||||||
JONES, Stuart Nigel | Secretario | 48 Beacons Park LD3 9BR Brecon Powys | British | Investment Manager | 41149470001 | |||||
LEWIS, Maria Bernadette | Secretario | Kingsway WC2B 6AN London 1 | British | 54836960001 | ||||||
MILLER, Roger Keith | Secretario | Kingsway WC2B 6AN London 1 | British | 120645920001 | ||||||
MILLER, Roger Keith | Secretario | Hatters Barn Stockwell Lane Little Meadle HP17 9UG Aylesbury Buckinghamshire | British | 120645920001 | ||||||
NAYLOR, Philip | Secretario | Kingsway WC2B 6AN London 1 | 201695650001 | |||||||
SHELL, Peter Geoffrey | Secretario | 5 Kingsdale Road HP4 3BS Berkhamsted Hertfordshire | British | 75961450003 | ||||||
ASSET MANAGEMENT SOLUTIONS LIMITED | Secretario corporativo | 3rd Floor 46 Charles Street CF10 2GE Cardiff South Glamorgan | 114724080001 | |||||||
SEVERNSIDE SECRETARIAL LIMITED | Secretario designado corporativo | 14-18 City Road CF24 3DL Cardiff | 900003990001 | |||||||
BALLSDON, Andrew James | Director | 10 Fernbrook Road Caversham RG4 7HG Reading Berkshire | England | British | Chartered Accountant | 94560360001 | ||||
BARRAS, Florence Marie Francoise | Director | 14 Rydon Street N1 7AL London | England | British,French | Director | 58686720001 | ||||
BLOOD, Gerard David | Director | Flat 3 88 Greencroft Gardens NW6 3JQ London | Australian | Bid Manager | 74828410001 | |||||
CANN, John | Director | Oaklands Devauden NP16 6PE Chepstow Monmouthshire | British | Project Bid Manager | 84199540001 | |||||
CASSIDY, John Charles | Director | 81 Little Bushey Lane WD23 4RA Bushey Hertfordshire | England | British | Chief Executive Officer | 155974650003 | ||||
CATTERMOLE, Carolyn Tracy | Director | Kingsway WC2B 6AN London 1 | United Kingdom | British | Solicitor | 53026290002 | ||||
CHARLESWORTH, Andrew Gilbert | Director | December Cottage 18a Newton Toney SP4 0HS Salisbury Wiltshire | United Kingdom | British | Chief Executive | 155424980001 | ||||
CLARK, Colin Bullough | Director | 5 Orchard Close Uppingham LE2 5PL Rutland Leicestershire | British | Business Development D | 87575230001 | |||||
EWER, Adrian James Henry | Director | Kingsway WC2B 6AN London 1 | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 33196010004 | ||||
EWER, Adrian James Henry | Director | Blagdens House Bumpstead Road Hempstead CB10 2PW Saffron Walden Essex | United Kingdom | British | Accountant | 33196010002 | ||||
FRIEND, Andrew Erskine | Director | 1 Priory Crescent BN7 1HP Lewes East Sussex | England | British | Managing Director Investments | 66359650001 | ||||
GRIER, Timothy Nicholas | Director | 48 St Albans Avenue Chiswick W4 5JP London | England | British | Director | 100444730004 | ||||
HARDY, David Michael | Director | 53 Lyncombe Hill BA2 4EQ Bath Somerset | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 106339430002 | ||||
HARTSHORNE, David John Morice | Director | Periwinkle High Street Eggington LU7 9PD Leighton Buzzard Bedfordshire | England | British | Chartered Engineer | 87382740001 | ||||
HARTSHORNE, David John Morice | Director | Periwinkle High Street Eggington LU7 9PD Leighton Buzzard Bedfordshire | England | British | Chartered Engineer | 87382740001 | ||||
JONES, Peter Donne | Director | The Red Barn Mounton Road NP16 6AA Chepstow Monmouthshire | British | Operations Manager Sector Dire | 75137020001 | |||||
JONES, Stuart Nigel | Director | 48 Beacons Park LD3 9BR Brecon Powys | British | Investment Manager | 41149470001 | |||||
KRIGE, Lynette Gillian | Director | Marsh Close Mill Hill NW7 4NY London 8 | United Kingdom | British | Chartered Accountant Sa | 90566820002 | ||||
LUCAS, Gary Stephen | Director | 18 Willoughby Way Piddington NN7 2EH Northamptonshire | England | British | Commercial Director | 70621740001 | ||||
MARTIN, Christopher John | Director | 78 Richard Street Cathays CF2 4DD Cardiff South Glamorgan | British | Accountant | 60744860001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de JOHN LAING SOCIAL INFRASTRUCTURE LIMITED?
Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Laing Investments Limited | 06 abr 2016 | Kingsway WC2B 6AN London 1 England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
|
¿Tiene JOHN LAING SOCIAL INFRASTRUCTURE LIMITED alguna carga?
Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
---|---|---|---|---|
Charge | Creado el 25 feb 1999 Entregado el 05 mar 1999 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies and liabilities due or to become due from laing hyder worlds end school limited to any finance party (as defined) under each of the finance documents (as defined) and any amounts owed by the chargor to the chargee (except for any obligation, if it were so included, would result in the charge contravening section 151 of the companies act 1985) | |
Breve descripción All the company's right title and interest in and to the shares (as defined in the charge together with first legal mortgage over all dividents all, stocks shares securities rights benefits moneys or property accruing therefrom all other income in repect of any such assets above. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0