GROSVENOR BASINGSTOKE PROPERTIES LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | GROSVENOR BASINGSTOKE PROPERTIES LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 03580641 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de GROSVENOR BASINGSTOKE PROPERTIES LIMITED?
- Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas
¿Dónde se encuentra GROSVENOR BASINGSTOKE PROPERTIES LIMITED?
| Dirección de la sede social | 70 Grosvenor Street London W1K 3JP |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de GROSVENOR BASINGSTOKE PROPERTIES LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| TRUSHELFCO (NO.2376) LIMITED | 12 jun 1998 | 12 jun 1998 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de GROSVENOR BASINGSTOKE PROPERTIES LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2019 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para GROSVENOR BASINGSTOKE PROPERTIES LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr David Robert Wright el 01 ago 2021 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr David Robert Wright el 01 ago 2021 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Cese del nombramiento de Richard Brian Mallett como director el 29 jul 2021 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Sebastien Dominique Hyest como director el 29 jul 2021 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 1 páginas | DS01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 14 jun 2021 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2019 | 4 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 14 jun 2020 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2018 | 4 páginas | AA | ||||||||||
Cese del nombramiento de Sebastien Dominique Hyest como director el 26 sept 2019 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Richard Brian Mallett como director el 26 sept 2019 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Robert Richard Davis como director el 26 sept 2019 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr David Robert Wright el 01 jul 2019 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr David Robert Wright el 01 jul 2019 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 14 jun 2019 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2017 | 4 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 14 jun 2018 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2016 | 4 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 08 jun 2017 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Robert Richard Davis el 10 may 2017 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2015 | 4 páginas | AA | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Sebastien Dominique Hyest el 01 sept 2016 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 16 jun 2016 avec liste complète des actionnaires | 6 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
¿Quiénes son los directivos de GROSVENOR BASINGSTOKE PROPERTIES LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SORRELL, Lisa | Secretario | Grosvenor Street W1K 3JP London 70 United Kingdom | 185868450001 | |||||||
| HYEST, Sebastien Dominique | Director | Boulevard Haussmann 75008 Paris 69 France | France | French | 172561570018 | |||||
| WRIGHT, David Robert | Director | 70 Grosvenor Street London W1K 3JP | England | British | 182526700003 | |||||
| DUNCAN, Virginia | Secretario | Grosvenor Street W1K 3JP London 70 United Kingdom | 181495290001 | |||||||
| HARGREAVES, Alison Ann | Secretario | 49 St Georges Avenue N7 0AJ London | British | 35895680001 | ||||||
| HINCHLIFFE, Caroline | Secretario | Yukon Road SW12 9PY London 31a | British | 131590610002 | ||||||
| ROBINSON, Katharine Emma | Secretario | Gipsy Hill SE19 1QL London 85a United Kingdom | 147937630001 | |||||||
| TOLHURST, Caroline Mary | Secretario | Flat B 10 Oxberry Avenue SW6 5SS London | British | 65695810004 | ||||||
| WATSON-BROCK, Leonie | Secretario | Grosvenor Street W1K 3JP London 70 United Kingdom | 153200830001 | |||||||
| TRUSEC LIMITED | Secretario designado corporativo | 35 Basinghall Street EC2V 5DB London | 900007200001 | |||||||
| ALDRED, Martin | Director | 16 Elliott Square NW3 3SU London | British | 935660002 | ||||||
| BEEVOR, Stuart Robert Hartley | Director | Yorktown Burgh Heath Road KT17 4LS Epsom Surrey | United Kingdom | British | 38901650004 | |||||
| BULLOUGH, William John Ashworth | Director | Chailey House Heydon SG8 8PW Royston Hertfordshire | England | British | 69640700001 | |||||
| CURTIS, Sarah-Jane | Director | 26 Vallance Road N22 7UB London | United Kingdom | British | 57607200001 | |||||
| DAVIS, Robert Richard | Director | 70 Grosvenor Street London W1K 3JP | England | British | 83730570002 | |||||
| DUMBRECK, Timothy Alan | Director | 44 Mountside GU2 4JE Guildford Surrey | United Kingdom | British | 146855970002 | |||||
| FEATHERBY, James Milton | Director | Copperdell 16 Nomansland AL4 8EJ Wheathampstead Hertfordshire | England | British | 4867190002 | |||||
| GERMAN, John Francis | Director | Bramfield Road Battersea SW11 6RA London 39 United Kingdom | United Kingdom | British | 116328670001 | |||||
| HALL, Colin | Director | The Oast House West End GU10 3EP Frensham Farnham Surrey | British | 25274560001 | ||||||
| HANDLEY, Richard Simon | Director | The Linhay Ilsington TQ13 9RS Newton Abbot Devon | Uk | British | 56271160005 | |||||
| HOWARD, Mervyn | Director | 5 Park Avenue South N8 8LU London | United Kingdom | British | 52891020001 | |||||
| HYEST, Sebastien Dominique | Director | Boulevard Haussmann 75008 Paris 69 France | France | French | 172561570018 | |||||
| JUKES, Christopher James | Director | Grosvenor Street W1K 3JP London 70 England | England | British | 186481960001 | |||||
| MALLETT, Richard Brian | Director | 70 Grosvenor Street London W1K 3JP | England | British | 102822550001 | |||||
| MALLETT, Richard Brian | Director | Grosvenor Street W1K 3JP London 70 United Kingdom | England | British | 102822550001 | |||||
| MALLETT, Richard Brian | Director | Grosvenor Street W1K 3JP London 70 United Kingdom | England | British | 102822550001 | |||||
| MALLETT, Richard Brian | Director | 138 South Park Road SW19 8TA London | England | British | 102822550001 | |||||
| MUSGRAVE, Stephen Howard Rhodes | Director | 4 Haverfield Gardens Kew TW9 3DD Richmond Surrey | United Kingdom | British | 6981200001 | |||||
| MYLES, Louise Anne | Director | 36 Fontarabia Road Clapham SW11 5PF London | British | 58428370001 | ||||||
| PRESTON, Nicholas Oliver | Director | Grosvenor Street W1K 3JP London 70 England | United Kingdom | British | 172740620002 | |||||
| ROWE, Drusilla Charlotte Jane | Director | 51 Moreton Terrace SW1V 2NS London | British | 77049790001 | ||||||
| ROWLAND, Scott Mark | Director | Miller Place Gerrards Cross SL9 7QQ Buckinghamshire 11 United Kingdom | United Kingdom | British | 123145990002 | |||||
| SCARLES, Nicholas Richard | Director | Mills Folly Hawthorn Lane SL2 3TE Farnham Common Berkshire | British | 113933450001 | ||||||
| WILLIAMS, Raymond Charles | Director | 5 Weldon Rise Loughton Village MK5 8BW Milton Keynes | British | 45838930003 | ||||||
| ZUERCHER, Eleanor Jane | Director | 14 St Marys Court Tingewick MK18 4RE Buckingham Buckinghamshire | British | 61053330001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de GROSVENOR BASINGSTOKE PROPERTIES LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grosvenor Basingstoke Management Limited | 06 abr 2016 | Grosvenor Street W1K 3JP London 70 United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Tiene GROSVENOR BASINGSTOKE PROPERTIES LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Deed of amendment amending a debenture dated 16 november 2004 and | Creado el 12 mar 2009 Entregado el 18 mar 2009 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from each chargor to any beneficiary on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción The initial debenture and all encumbrances security and guarantee and all references in the finance documents see image for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 12 mar 2009 Entregado el 18 mar 2009 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from each chargor to any beneficiary on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Deed of debenture | Creado el 16 nov 2004 Entregado el 01 dic 2004 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to any beneficiary on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0