PAYPOINT PLC

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración de confirmación
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaPAYPOINT PLC
    Estado de la empresaActiva
    Forma jurídicaSociedad anónima cotizada
    Número de empresa 03581541
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenesNo
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de PAYPOINT PLC?

    • Otras actividades de servicios de tecnología de la información (62090) / Información y comunicación
    • Otras actividades de apoyo a los negocios n.c.p. (82990) / Actividades administrativas y de apoyo

    ¿Dónde se encuentra PAYPOINT PLC?

    Dirección de la sede social
    1 The Boulevard
    Shire Park
    AL7 1EL Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de PAYPOINT PLC?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    PAYPOINT LIMITED04 ago 199804 ago 1998
    LEADHOLD LIMITED15 jun 199815 jun 1998

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de PAYPOINT PLC?

    VencidoNo
    Próximas cuentas
    Próximo período contable finaliza el31 mar 2026
    Próximas cuentas vencen el30 sept 2026
    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 mar 2025

    ¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para PAYPOINT PLC?

    Última declaración de confirmación cerrada hasta21 jun 2026
    Próxima declaración de confirmación vence05 jul 2026
    Última declaración de confirmación
    Próxima declaración de confirmación cerrada hasta21 jun 2025
    VencidoNo

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para PAYPOINT PLC?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Nombramiento de Manasi Prakash Bhalerao como director el 25 mar 2026

    2 páginasAP01

    Cancelación de acciones. Estado de capital el 17 mar 2026

    • Capital: GBP 220,634.54
    4 páginasSH06

    Cancelación de acciones. Estado de capital el 11 mar 2026

    • Capital: GBP 221,371.84
    4 páginasSH06

    Compra de acciones propias.

    4 páginasSH03
    Anotaciones
    FechaAnotación
    21 mar 2026Clarification HMRC confirmation received that appropriate duty has been paid on this repurchase.

    Compra de acciones propias.

    4 páginasSH03
    Anotaciones
    FechaAnotación
    21 mar 2026Clarification HMRC confirmation received that appropriate duty has been paid on this repurchase.

    Cancelación de acciones. Estado de capital el 04 mar 2026

    • Capital: GBP 222,114.23
    4 páginasSH06

    Cancelación de acciones. Estado de capital el 02 mar 2026

    • Capital: GBP 222,597.20
    4 páginasSH06

    Compra de acciones propias.

    4 páginasSH03
    Anotaciones
    FechaAnotación
    10 mar 2026Clarification HMRC confirmation received that appropriate Stamp Duty has been paid for this transaction.

    Compra de acciones propias.

    4 páginasSH03
    Anotaciones
    FechaAnotación
    10 mar 2026Clarification HMRC confirmation received that appropriate Stamp Duty has been paid for this transaction.

    Cancelación de acciones. Estado de capital el 20 feb 2026

    • Capital: GBP 223,178.58
    4 páginasSH06

    Compra de acciones propias.

    4 páginasSH03
    Anotaciones
    FechaAnotación
    25 feb 2026Clarification HMRC - CONFIRMATION RECEVIED THAT APPRORIATE DUTY THAT HAS BEEN PAID ON THIS TRANSACTION.

    Compra de acciones propias.

    4 páginasSH03
    Anotaciones
    FechaAnotación
    25 feb 2026Clarification HMRC confirmation received that appropriate duty has been paid on this repurchase.

    Compra de acciones propias.

    4 páginasSH03
    Anotaciones
    FechaAnotación
    25 feb 2026Clarification HMRC confirmation received that appropriate duty has been paid on this repurchase.

    Cancelación de acciones. Estado de capital el 11 feb 2026

    • Capital: GBP 223,509.54
    4 páginasSH06

    Compra de acciones propias.

    4 páginasSH03
    Anotaciones
    FechaAnotación
    17 feb 2026Clarification HMRC confirmation received that appropriate Stamp Duty has been paid for this transaction.

    Cancelación de acciones. Estado de capital el 04 feb 2026

    • Capital: GBP 223,911.57
    4 páginasSH06

    Cancelación de acciones. Estado de capital el 28 ene 2026

    • Capital: GBP 224,260.86
    4 páginasSH06

    Cancelación de acciones. Estado de capital el 20 ene 2026

    • Capital: GBP 224,698.84
    4 páginasSH06

    Cancelación de acciones. Estado de capital el 13 ene 2026

    • Capital: GBP 225,068.85
    4 páginasSH06

    Cancelación de acciones. Estado de capital el 07 ene 2026

    • Capital: GBP 225,522.22
    4 páginasSH06

    Compra de acciones propias.

    4 páginasSH03
    Anotaciones
    FechaAnotación
    29 ene 2026Clarification HMRC confirmation received that appropriate duty has been paid on this repurchase.

    Compra de acciones propias.

    4 páginasSH03
    Anotaciones
    FechaAnotación
    29 ene 2026Clarification HMRC confirmation received that appropriate duty has been paid on this repurchase.

    Compra de acciones propias.

    4 páginasSH03
    Anotaciones
    FechaAnotación
    29 ene 2026Clarification HMRC confirmation received that appropriate duty has been paid on this repurchase.

    Compra de acciones propias.

    4 páginasSH03
    Anotaciones
    FechaAnotación
    16 ene 2026Clarification HMRC confirmation received that appropriate Stamp Duty has been paid on this transaction

    Compra de acciones propias.

    4 páginasSH03
    Anotaciones
    FechaAnotación
    09 ene 2026Clarification HMRC confirmation received that appropriate duty has been paid on this transaction.

    ¿Quiénes son los directivos de PAYPOINT PLC?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    INDIGO CORPORATE SECRETARY LIMITED
    853-855 London Road
    SS0 9SZ Westcliff On Sea
    Vincent Court, Ground Floor
    Essex
    United Kingdom
    Secretario corporativo
    853-855 London Road
    SS0 9SZ Westcliff On Sea
    Vincent Court, Ground Floor
    Essex
    United Kingdom
    Tipo de identificaciónSociedad limitada del Reino Unido
    Número de registro13253973
    281695990002
    BHALERAO, Manasi Prakash
    1 The Boulevard
    Shire Park
    AL7 1EL Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    Director
    1 The Boulevard
    Shire Park
    AL7 1EL Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    United KingdomBritish346879250001
    HARDING, David Robert
    1 The Boulevard
    Shire Park
    AL7 1EL Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    Director
    1 The Boulevard
    Shire Park
    AL7 1EL Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    EnglandBritish269895420001
    KERR, Giles Francis Bertram
    1 The Boulevard
    Shire Park
    AL7 1EL Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    Director
    1 The Boulevard
    Shire Park
    AL7 1EL Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    EnglandBritish202849490001
    SHAPLAND, Rosemary Jean
    1 The Boulevard
    Shire Park
    AL7 1EL Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    Director
    1 The Boulevard
    Shire Park
    AL7 1EL Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    EnglandBritish275037160001
    SHARMA, Rakesh
    1 The Boulevard
    Shire Park
    AL7 1EL Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    Director
    1 The Boulevard
    Shire Park
    AL7 1EL Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    EnglandBritish253839580001
    TU, Thi Nhuoc Lan
    1 The Boulevard
    Shire Park
    AL7 1EL Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    Director
    1 The Boulevard
    Shire Park
    AL7 1EL Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    United KingdomBritish163940470001
    WILES, Nicholas Winston Braid
    1 The Boulevard
    Shire Park
    AL7 1EL Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    Director
    1 The Boulevard
    Shire Park
    AL7 1EL Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    United KingdomBritish141641510001
    WISHART, Ben
    1 The Boulevard
    Shire Park
    AL7 1EL Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    Director
    1 The Boulevard
    Shire Park
    AL7 1EL Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    NetherlandsBritish264569390001
    CARNE, Sarah
    Shire Park
    AL7 1EL Welwyn Garden City
    1 The Boulevard
    Herts
    United Kingdom
    Secretario
    Shire Park
    AL7 1EL Welwyn Garden City
    1 The Boulevard
    Herts
    United Kingdom
    265358220001
    CLIFFORD, Amanda Elizabeth
    5 Lambrook Terrace
    Fulham
    SW6 6TF London
    Secretario
    5 Lambrook Terrace
    Fulham
    SW6 6TF London
    British59910080001
    COURT, Susan Catherine
    1 The Boulevard
    Shire Park
    AL7 1EL Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    Secretario
    1 The Boulevard
    Shire Park
    AL7 1EL Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    British76828040003
    HANSON, Shay Dinata
    29 Trebovir Road
    SW5 9NQ London
    Secretario
    29 Trebovir Road
    SW5 9NQ London
    British64503850001
    MCDOUGALL, Ian Paul, Mr.
    39 Manor Road
    Old Moulsham
    CM2 0EP Chelmsford
    Essex
    Secretario
    39 Manor Road
    Old Moulsham
    CM2 0EP Chelmsford
    Essex
    British68817460002
    MCLELLAND, Brian
    1 The Boulevard
    Shire Park
    AL7 1EL Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    Secretario
    1 The Boulevard
    Shire Park
    AL7 1EL Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    292611670001
    NORTON ROSE LIMITED
    Kempson House
    P.O. Box 570, Camomile Street
    EC3A 7AN London
    Secretario designado corporativo
    Kempson House
    P.O. Box 570, Camomile Street
    EC3A 7AN London
    900006420001
    ANSTEE, Eric Edward
    1 The Boulevard
    Shire Park
    AL7 1EL Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    Director
    1 The Boulevard
    Shire Park
    AL7 1EL Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    EnglandBritish76479900003
    ASTBURY, Mark Harvey Ayrton
    6 Blinco Grove
    CB1 7TS Cambridge
    Cambridgeshire
    Director
    6 Blinco Grove
    CB1 7TS Cambridge
    Cambridgeshire
    British101313750001
    BARR, Gillian Carole
    1 The Boulevard
    Shire Park
    AL7 1EL Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    Director
    1 The Boulevard
    Shire Park
    AL7 1EL Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    EnglandBritish165091810001
    BOTT, Stephen John
    Acorns
    The Fairway Busbridge
    GU7 1PG Godalming
    Surrey
    Director
    Acorns
    The Fairway Busbridge
    GU7 1PG Godalming
    Surrey
    United KingdomBritish31624930002
    BULL, Ian Alan
    16 Wykeham Gate
    HP17 8DF Haddenham
    Buckinghamshire
    Director
    16 Wykeham Gate
    HP17 8DF Haddenham
    Buckinghamshire
    EnglandBritish210299090001
    CARSON, Neil Andrew Patrick
    1 The Boulevard
    Shire Park
    AL7 1EL Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    Director
    1 The Boulevard
    Shire Park
    AL7 1EL Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    EnglandBritish65525870003
    CLIFFORD, Amanda Elizabeth
    5 Lambrook Terrace
    Fulham
    SW6 6TF London
    Director
    5 Lambrook Terrace
    Fulham
    SW6 6TF London
    British59910080001
    COLLISON, David
    44 Lowther Road
    SW13 9NU London
    England
    Director
    44 Lowther Road
    SW13 9NU London
    England
    United KingdomBritish34835160001
    DALE, Alan Christopher
    1 The Boulevard
    Shire Park
    AL7 1EL Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    Director
    1 The Boulevard
    Shire Park
    AL7 1EL Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    EnglandBritish96401190004
    EARLE, George William Eric David
    1 The Boulevard
    Shire Park
    AL7 1EL Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    Director
    1 The Boulevard
    Shire Park
    AL7 1EL Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    United KingdomBritish8826580001
    HEADON, Patrick Vincent
    1 The Boulevard
    Shire Park
    AL7 1EL Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    Director
    1 The Boulevard
    Shire Park
    AL7 1EL Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    United KingdomBritish257074890001
    KENTLETON, Rachel Elizabeth
    1 The Boulevard
    Shire Park
    AL7 1EL Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    Director
    1 The Boulevard
    Shire Park
    AL7 1EL Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    EnglandBritish287255940001
    MINTON, Kenneth Joseph
    7 Midway
    AL3 4BD St Albans
    Hertfordshire
    Director
    7 Midway
    AL3 4BD St Albans
    Hertfordshire
    United KingdomBritish513690001
    MORRISON, David John
    1 The Boulevard
    Shire Park
    AL7 1EL Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    Director
    1 The Boulevard
    Shire Park
    AL7 1EL Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    EnglandBritish29500910005
    MURPHY, William Patrick
    Summerhaze Farm Church Street
    Woolley
    BA1 8AS Bath
    Director
    Summerhaze Farm Church Street
    Woolley
    BA1 8AS Bath
    Great BritainRetired1612940005
    NEWLANDS, David Baxter
    Lane End Chucks Lane
    Walton-On-The-Hill
    KT20 7UB Tadworth
    Surrey
    Director
    Lane End Chucks Lane
    Walton-On-The-Hill
    KT20 7UB Tadworth
    Surrey
    EnglandBritish14918650001
    PARSONS, Guy Paul Cuthbert
    1 The Boulevard
    Shire Park
    AL7 1EL Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    Director
    1 The Boulevard
    Shire Park
    AL7 1EL Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    EnglandBritish136891930001
    PAULL, Charles Arthur
    The Croft
    Station Road Tilbrook
    PE28 0JT Huntingdon
    Cambridgeshire
    Director
    The Croft
    Station Road Tilbrook
    PE28 0JT Huntingdon
    Cambridgeshire
    EnglandBritish654450001
    ROBB, Andrew Mackenzie
    16 Hillgate Place
    W8 7SJ London
    Director
    16 Hillgate Place
    W8 7SJ London
    EnglandBritish119518980001

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0