BRITISH COMPRESSED AIR SOCIETY LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | BRITISH COMPRESSED AIR SOCIETY LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Activa |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada por garantía sin capital social |
| Número de empresa | 03589631 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de BRITISH COMPRESSED AIR SOCIETY LIMITED?
- Actividades de organizaciones de miembros empresariales y de empleadores (94110) / Otras actividades de servicios
¿Dónde se encuentra BRITISH COMPRESSED AIR SOCIETY LIMITED?
| Dirección de la sede social | Unit 14, The Stottie Shed Christon Road Baker's Yard NE3 1XD Newcastle Upon Tyne Tyne And Wear United Kingdom |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles son las últimas cuentas de BRITISH COMPRESSED AIR SOCIETY LIMITED?
| Vencido | No |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 30 jun 2025 |
| Próximas cuentas vencen el | 31 mar 2026 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 30 jun 2024 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para BRITISH COMPRESSED AIR SOCIETY LIMITED?
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 24 jun 2026 |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación vence | 08 jul 2026 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 24 jun 2025 |
| Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para BRITISH COMPRESSED AIR SOCIETY LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Notification de Jason Asa Morgan en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 17 feb 2026 | 2 páginas | PSC01 | ||||||||||
Cessation de Jason Asa Morgan en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 16 feb 2026 | 1 páginas | PSC07 | ||||||||||
Notification de Wendy Jayne Hayward en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 feb 2026 | 2 páginas | PSC01 | ||||||||||
Cessation de Wendy Jayne Hayward en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 05 feb 2026 | 1 páginas | PSC07 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de Numeric House 98 Station Road Sidcup Kent DA15 7BY United Kingdom a Unit 14, the Stottie Shed Christon Road Baker's Yard Newcastle upon Tyne Tyne and Wear NE3 1XD el 30 ene 2026 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Memorándum y Estatutos | 36 páginas | MA | ||||||||||
Declaración de los objetos de la sociedad | 2 páginas | CC04 | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Nombramiento de Mr Mark Thomas Scott como director el 21 nov 2025 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr James Daniel Shaw como director el 21 nov 2025 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Nigel John Palmer como director el 21 nov 2025 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Christopher Hall como director el 21 nov 2025 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Memorándum y Estatutos | 35 páginas | MA | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Cese del nombramiento de Paul Daniel Sparke como director el 12 sept 2025 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de David Seenan como director el 31 jul 2025 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Vanda Joyce Jones como director el 25 jun 2025 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Vanda Jones como secretario el 25 jun 2025 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Cessation de Vanda Joyce Jones en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 25 jun 2025 | 1 páginas | PSC07 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 24 jun 2025 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 30 jun 2024 | 8 páginas | AA | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Steven William Rohan el 10 ene 2025 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Notification de Ashley James Quarterman en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 12 sept 2024 | 2 páginas | PSC01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Ashley James Quarterman como director el 12 sept 2024 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Stephen Thomas Wright como director el 27 ago 2024 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de BRITISH COMPRESSED AIR SOCIETY LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOLBY, Allan John | Director | Christon Road Baker's Yard NE3 1XD Newcastle Upon Tyne Unit 14, The Stottie Shed Tyne And Wear United Kingdom | United Kingdom | British | 42157780004 | |||||
| HALL, Christopher | Director | Christon Road Baker's Yard NE3 1XD Newcastle Upon Tyne Unit 14, The Stottie Shed Tyne And Wear United Kingdom | England | British | 170608160001 | |||||
| HAYWARD, Wendy Jayne | Director | Christon Road Baker's Yard NE3 1XD Newcastle Upon Tyne Unit 14, The Stottie Shed Tyne And Wear United Kingdom | United Kingdom | British | 213805190002 | |||||
| JOHN, Benjamin | Director | Christon Road Baker's Yard NE3 1XD Newcastle Upon Tyne Unit 14, The Stottie Shed Tyne And Wear United Kingdom | England | British | 319581180001 | |||||
| JONES, Andrew Steven | Director | Christon Road Baker's Yard NE3 1XD Newcastle Upon Tyne Unit 14, The Stottie Shed Tyne And Wear United Kingdom | England | British | 178849080006 | |||||
| LEITH, Derek Gordon | Director | Christon Road Baker's Yard NE3 1XD Newcastle Upon Tyne Unit 14, The Stottie Shed Tyne And Wear United Kingdom | Scotland | British | 307069870002 | |||||
| MIDDLETON-DUFF, Meltem | Director | Christon Road Baker's Yard NE3 1XD Newcastle Upon Tyne Unit 14, The Stottie Shed Tyne And Wear United Kingdom | England | Turkish | 292565640001 | |||||
| MORGAN, Jason Asa | Director | Christon Road Baker's Yard NE3 1XD Newcastle Upon Tyne Unit 14, The Stottie Shed Tyne And Wear United Kingdom | England | British | 107710770002 | |||||
| PALMER, Nigel John | Director | Christon Road Baker's Yard NE3 1XD Newcastle Upon Tyne Unit 14, The Stottie Shed Tyne And Wear United Kingdom | England | British | 256644370001 | |||||
| QUARTERMAN, Ashley James | Director | Christon Road Baker's Yard NE3 1XD Newcastle Upon Tyne Unit 14, The Stottie Shed Tyne And Wear United Kingdom | England | British | 327218500001 | |||||
| ROHAN, Steven William | Director | Christon Road Baker's Yard NE3 1XD Newcastle Upon Tyne Unit 14, The Stottie Shed Tyne And Wear United Kingdom | England | British | 246063520002 | |||||
| SANTOS, Serge Marc, Dr | Director | Christon Road Baker's Yard NE3 1XD Newcastle Upon Tyne Unit 14, The Stottie Shed Tyne And Wear United Kingdom | England | Swiss | 167620970005 | |||||
| SCOTT, Mark Thomas | Director | Christon Road Baker's Yard NE3 1XD Newcastle Upon Tyne Unit 14, The Stottie Shed Tyne And Wear United Kingdom | England | British | 343094430001 | |||||
| SHAW, James Daniel | Director | Christon Road Baker's Yard NE3 1XD Newcastle Upon Tyne Unit 14, The Stottie Shed Tyne And Wear United Kingdom | England | British | 322352210001 | |||||
| WRIGHT, Martin Julian | Director | Christon Road Baker's Yard NE3 1XD Newcastle Upon Tyne Unit 14, The Stottie Shed Tyne And Wear United Kingdom | England | British | 216136640001 | |||||
| CAISLEY, Leslie Austin | Secretario | Carroncroft High Hamsterley Road NE39 1HD Hamsterley Mill Tyne And Wear | British | 168375550001 | ||||||
| DEE, Christopher | Secretario | 14 Redcar Close CV32 7SU Leamington Spa Warwickshire | British | 75817670001 | ||||||
| JONES, Vanda | Secretario | 98 Station Road DA15 7BY Sidcup Numeric House Kent United Kingdom | 206197900001 | |||||||
| WALL, Robert Desmond | Secretario | 80 Chiltern Court Baker Street NW1 5SD London | British | 58152700001 | ||||||
| BAILLIE, Gawaine George Hope, Sir | Director | Freechase RH17 5SZ Warninglid West Sussex | British | 2173340001 | ||||||
| BILLIET, Colin Thomas | Director | 30 Richmond Court Kells Lane Low Fell NE9 5JG Gateshead Tyne & Wear | United Kingdom | British | 117720510001 | |||||
| BRIDGER, Andrew Jeffery | Director | Devonshire Street W1G 6PY London 33-34 | England | British | 266550140001 | |||||
| CLARK, Paul David | Director | Swallowdale Lane Hemel Hempstead Industrial Estate HP2 7EA Hemel Hempstead Atlas Copco Ltd Hertfordshire England | United Kingdom | British | 206790610001 | |||||
| CURTIS, Ian | Director | St Marys Lodge Kitson Road SW13 9HJ Barnes London | British | 98844440001 | ||||||
| DEE, Christopher | Director | 33/34 Devonshire Street London W1G 6PY | United Kingdom | British | 75817670001 | |||||
| DIBBITS, Theodorus Gerardus Josephus | Director | 3 Lowside Avenue Lostock BL1 5XQ Bolton Lancashire | Dutch | 119054100001 | ||||||
| DOLBY, Allan John | Director | Devonshire Street W1G 6PY London 33-34 | United Kingdom | British | 42157780004 | |||||
| EARLE, Alan | Director | 36 Penn Gardens Herefield NN4 0QX Northampton | United Kingdom | British | 93892060001 | |||||
| ERRINGTON, Douglas William Johnson | Director | 57 Montagu Court Gosforth NE3 4JL Newcastle Upon Tyne | British | 14034420002 | ||||||
| FOLLENS, Geert | Director | Willow Wood House Northchurch Lane HP5 3PD Ashley Green Buckinghamshire | Belgian | 93892130001 | ||||||
| GILLIES, David Alexander | Director | Devonshire Street W1G 6PY London 33-34 | England | British | 237659420001 | |||||
| HORN, Dean | Director | Devonshire Street W1G 6PY London 33-34 | England | British | 296168330001 | |||||
| HOULGATE, Geoffrey Francis | Director | 149 Findon Road Findon Valley BN14 0BQ Worthing West Sussex | British | 35253300001 | ||||||
| HUNT, Conrad | Director | Devonshire Street W1G 6PY London 33-34 | England | British | 210040620001 | |||||
| JONES, Andrew Steven | Director | Devonshire Street W1G 6PY London 33-34 | England | British | 178849080005 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de BRITISH COMPRESSED AIR SOCIETY LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado |
|---|---|---|---|
| Mr Jason Asa Morgan | 17 feb 2026 | Christon Road Baker's Yard NE3 1XD Newcastle Upon Tyne Unit 14, The Stottie Shed Tyne And Wear United Kingdom | No |
Nacionalidad: British País de residencia: England | |||
Naturaleza del control
| |||
| Mrs Wendy Jayne Hayward | 06 feb 2026 | Christon Road Baker's Yard NE3 1XD Newcastle Upon Tyne Unit 14, The Stottie Shed Tyne And Wear United Kingdom | No |
Nacionalidad: British País de residencia: United Kingdom | |||
Naturaleza del control
| |||
| Mr Ashley James Quarterman | 12 sept 2024 | Christon Road Baker's Yard NE3 1XD Newcastle Upon Tyne Unit 14, The Stottie Shed Tyne And Wear United Kingdom | No |
Nacionalidad: British País de residencia: England | |||
Naturaleza del control
| |||
| Mrs Wendy Jayne Hayward | 22 feb 2024 | Christon Road Baker's Yard NE3 1XD Newcastle Upon Tyne Unit 14, The Stottie Shed Tyne And Wear United Kingdom | Sí |
Nacionalidad: British País de residencia: England | |||
Naturaleza del control
| |||
| Mr Steven William Rohan | 25 nov 2021 | Christon Road Baker's Yard NE3 1XD Newcastle Upon Tyne Unit 14, The Stottie Shed Tyne And Wear United Kingdom | No |
Nacionalidad: British País de residencia: England | |||
Naturaleza del control
| |||
| Mr Jason Asa Morgan | 04 ene 2021 | Christon Road Baker's Yard NE3 1XD Newcastle Upon Tyne Unit 14, The Stottie Shed Tyne And Wear United Kingdom | Sí |
Nacionalidad: British País de residencia: England | |||
Naturaleza del control
| |||
| Mr James Robert Maziak | 04 ene 2021 | Devonshire Street W1G 6PY London 33-34 | Sí |
Nacionalidad: British País de residencia: England | |||
Naturaleza del control
| |||
| Mr Mark James Ranger | 09 may 2019 | 98 Station Road DA15 7BY Sidcup Numeric House Kent United Kingdom | Sí |
Nacionalidad: British País de residencia: England | |||
Naturaleza del control
| |||
| Mr Jason Asa Morgan | 03 may 2018 | Devonshire Street W1G 6PY London 33-34 | Sí |
Nacionalidad: British País de residencia: England | |||
Naturaleza del control
| |||
| Mr Anthony Wilson | 25 may 2017 | Devonshire Street W1G 6PY London 33-34 | Sí |
Nacionalidad: British País de residencia: England | |||
Naturaleza del control
| |||
| Mrs Vanda Joyce Jones | 06 abr 2016 | 98 Station Road DA15 7BY Sidcup Numeric House Kent United Kingdom | Sí |
Nacionalidad: British País de residencia: England | |||
Naturaleza del control
| |||
| Mr James Robert Maziak | 06 abr 2016 | Devonshire Street W1G 6PY London 33-34 | Sí |
Nacionalidad: British País de residencia: England | |||
Naturaleza del control
| |||
| Mr Andrew Steven Jones | 06 abr 2016 | Devonshire Street W1G 6PY London 33-34 | Sí |
Nacionalidad: British País de residencia: England | |||
Naturaleza del control
| |||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0