INNSPIRED DEVELOPMENTS LIMITED

INNSPIRED DEVELOPMENTS LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración de confirmación
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaINNSPIRED DEVELOPMENTS LIMITED
    Estado de la empresaLiquidación
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 03589962
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de INNSPIRED DEVELOPMENTS LIMITED?

    • Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra INNSPIRED DEVELOPMENTS LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Jubilee House
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton On Trent
    Staffordshire
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de INNSPIRED DEVELOPMENTS LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    THE ALEHOUSE GROUP LIMITED24 jun 199824 jun 1998

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de INNSPIRED DEVELOPMENTS LIMITED?

    Vencido
    Próximas cuentas
    Próximo período contable finaliza el11 ago 2022
    Próximas cuentas vencen el11 may 2023
    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta15 ago 2021

    ¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para INNSPIRED DEVELOPMENTS LIMITED?

    Vencido
    Última declaración de confirmación cerrada hasta14 jun 2023
    Próxima declaración de confirmación vence28 jun 2023
    Última declaración de confirmación
    Próxima declaración de confirmación cerrada hasta14 jun 2022
    Vencido

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para INNSPIRED DEVELOPMENTS LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 26 mar 2024

    8 páginasLIQ03

    Declaración de solvencia

    5 páginasLIQ01

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    4 páginas600

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo especial para la liquidación el 27 mar 2023

    LRESSP

    Memorándum y Estatutos

    8 páginasMA

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resoluciones

    Removal of directors/ appointment of director 01/02/2023
    RES13
    incorporation

    Resolución de adopción de los Artículos de Asociación

    RES01

    Nombramiento de Mr Derek Anthony Howell como director el 01 feb 2023

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Stephen Peter Dando como director el 01 feb 2023

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Edward Michael Bashforth como director el 01 feb 2023

    1 páginasTM01

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resoluciones

    26/08/2022
    RES13

    Cese del nombramiento de Francesca Appleby como secretario el 22 ago 2022

    1 páginasTM02

    Estado de capital el 11 ago 2022

    • Capital: GBP 1
    3 páginasSH19

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resoluciones

    Cancel share premium account 10/08/2022
    RES13
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06

    legacy

    1 páginasSH20

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Declaración de confirmación presentada el 14 jun 2022 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 15 ago 2021

    4 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 14 jun 2021 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 16 ago 2020

    3 páginasAA

    Exercice comptable précédent raccourci du 24 ago 2020 au 11 ago 2020

    1 páginasAA01

    Declaración de confirmación presentada el 14 jun 2020 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 18 ago 2019

    3 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 14 jun 2019 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 18 ago 2018

    3 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 14 jun 2018 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    ¿Quiénes son los directivos de INNSPIRED DEVELOPMENTS LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    HOWELL, Derek Anthony
    Chamberlain Square
    B3 3AX Birmingham
    One
    England
    Director
    Chamberlain Square
    B3 3AX Birmingham
    One
    England
    United KingdomBritishDirector299032280001
    APPLEBY, Francesca
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Secretario
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    191628240001
    GREEN, Andrew Bernard
    Roddenbrook Lodge Huntenhull Lane
    Chapmanslade
    BA13 4AS Westbury
    Wiltshire
    Secretario
    Roddenbrook Lodge Huntenhull Lane
    Chapmanslade
    BA13 4AS Westbury
    Wiltshire
    British62833460001
    HARRIS, Claire Louise
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Secretario
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    175488360001
    MURRAY, John Duncan
    Little Hatchett
    Hatchet Lane
    SO42 7WA Beaulieu
    Hampshire
    Secretario
    Little Hatchett
    Hatchet Lane
    SO42 7WA Beaulieu
    Hampshire
    British52310900004
    RUDD, Susan Clare
    17 Thacker Drive
    WS13 6NS Lichfield
    Staffordshire
    Secretario
    17 Thacker Drive
    WS13 6NS Lichfield
    Staffordshire
    British81789210004
    STEWART, Claire Susan
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton-On-Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Secretario
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton-On-Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    British117216940001
    TYRRELL, Helen
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Secretario
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    161624480001
    BARNES, Robert Bruce
    19 Lewisham High Street
    Lewisham
    SE13 5AF London
    Director
    19 Lewisham High Street
    Lewisham
    SE13 5AF London
    BritishVenture Capitalist38841560002
    BASHFORTH, Edward Michael
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Director
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector131551840002
    BIRCH, James
    7 Woods Close
    Sherston
    SN16 0LF Malmesbury
    Wiltshire
    Director
    7 Woods Close
    Sherston
    SN16 0LF Malmesbury
    Wiltshire
    BritishDirector116449180001
    BLACKLEDGE, David Albert
    The Stoop
    Stanley
    SN15 3RF Chippenham
    Wiltshire
    Director
    The Stoop
    Stanley
    SN15 3RF Chippenham
    Wiltshire
    EnglandBritishDirector123065010001
    BROOK, Peter Stuart
    Curzon House
    Rode
    BA11 6QW Frome
    Somerset
    Director
    Curzon House
    Rode
    BA11 6QW Frome
    Somerset
    EnglandBritishDirector120715800001
    DANDO, Stephen Peter
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Director
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Accountant152083750001
    DUTTON, Philip
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Director
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector141395280001
    MCDONALD, Robert James
    46 Wentworth Drive
    WS14 9HN Lichfield
    Staffordshire
    Director
    46 Wentworth Drive
    WS14 9HN Lichfield
    Staffordshire
    BritishDirector42019620001
    MURRAY, John Duncan
    Little Hatchett
    Hatchet Lane
    SO42 7WA Beaulieu
    Hampshire
    Director
    Little Hatchett
    Hatchet Lane
    SO42 7WA Beaulieu
    Hampshire
    BritishCompany Director52310900004
    PRESTON, Neil David
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Director
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector63043630002
    SHEPHERD, Keith Donald
    Cedar Lodge
    8 Aston Park
    OX9 5SW Aston Rowant
    Oxon
    Director
    Cedar Lodge
    8 Aston Park
    OX9 5SW Aston Rowant
    Oxon
    BritishDirector33866710001
    TEGG, Stephen John
    Ivybank 20 Highfield Lane
    Highfield
    SO17 1PZ Southampton
    Hampshire
    Director
    Ivybank 20 Highfield Lane
    Highfield
    SO17 1PZ Southampton
    Hampshire
    BritishCompany Director72160000001
    THORLEY, Giles Alexander
    Charlton Manor
    Ashley Road Charlton Kings
    GL52 6NS Cheltenham
    Gloucestershire
    Director
    Charlton Manor
    Ashley Road Charlton Kings
    GL52 6NS Cheltenham
    Gloucestershire
    Gb-EngBritishDirector81928120001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de INNSPIRED DEVELOPMENTS LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    06 abr 2016
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    No
    Forma jurídicaLimited By Shares
    País de registroEngland And Wales
    Autoridad legalUnited Kingdom (England And Wales)
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro3776523
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.

    ¿Tiene INNSPIRED DEVELOPMENTS LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Guarantee & debenture
    Creado el 29 ene 1999
    Entregado el 10 feb 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All present and future obligations and liabilties (whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or as principal debtor, guarantor, surety or otherwise or as the equivalent obligor (as defined) under the laws of any other jurisdiction) of each obligor (as defined) to the chargee and the secured parties (as defined) together with:- (a) all costs, charges and expenses incurred by the chargee or any of the secured parties (as defined) in connection with the protection, preservation or enforcement of its respective rights under the financing documents (as defined); (b) any refinancing, novation, refunding, deferral or extension of or increase in any of those obligations or liabilities; (c) any further advances which may be made by any secured party to any obligor (as defined) under any agreement expressed to be supplemental to any of the financing documents (as defined) and all interest, fees and costs in connection therewith; (d) any claim for damages or restitution in the event of recission of any of those obligations or liabilities or otherwise in connection with the financing documents (as defined); (e) any cliam against any obligor (as defined) flowing from the recovery by an obligor (as defined) of a payment or discharge in respect of any of those obligations or liabilities on grounds of preference or otherwise; and (f) any amounts which would be included in any of the foregoing but for any discharge, non-provability, unenforceability or non- allowability of the same in any insolvency or other proceedings
    Breve descripción
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotlandas Agent and Security Trustee for Itself and for Each of the Secured Parties (As Defined in Rider A)
    Transacciones
    • 10 feb 1999Registro de un cargo (395)
    • 13 oct 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creado el 03 jul 1998
    Entregado el 09 jul 1998
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 09 jul 1998Registro de un cargo (395)
    • 10 feb 1999Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    ¿Tiene INNSPIRED DEVELOPMENTS LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    27 mar 2023Inicio de la liquidación
    21 mar 2023Fecha de la declaración de solvencia jurada
    Liquidación voluntaria de socios
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    David Matthew Hammond
    1 Chamberlain Square
    B3 3AX Birmingham
    Profesional
    1 Chamberlain Square
    B3 3AX Birmingham
    Emma Cray
    One Chamberlain Square
    B3 3AX Birmingham
    Profesional
    One Chamberlain Square
    B3 3AX Birmingham
    Steven Sherry
    Pricewaterhousecoopers Llp 7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Profesional
    Pricewaterhousecoopers Llp 7 More London Riverside
    SE1 2RT London

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0