CP 100 LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaCP 100 LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 03590026
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de CP 100 LIMITED?

    • (7222) /

    ¿Dónde se encuentra CP 100 LIMITED?

    Dirección de la sede social
    88 Wood Street
    EC2V 7QF London
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de CP 100 LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    COPPEREYE LIMITED09 ene 200109 ene 2001
    INDIGO ONE TECHNOLOGIES LIMITED 22 jun 199922 jun 1999
    INDIGO ONE TECHNOLOGY LIMITED18 may 199918 may 1999
    GODZILLA LIMITED30 jun 199830 jun 1998

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de CP 100 LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2008

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para CP 100 LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Informe de progreso del administrador hasta 16 mar 2012

    14 páginas2.24B

    Aviso de cambio de la administración a la disolución el 16 mar 2012

    14 páginas2.35B

    Informe de progreso del administrador hasta 30 sept 2011

    12 páginas2.24B

    Orden judicial de insolvencia

    Court order insolvency:replacement of liquidator :- r h Pick replaces f c Satow
    6 páginasLIQ MISC OC

    Aviso de nombramiento de administrador suplente/adicional

    1 páginas2.40B

    Aviso de vacante de oficina por el administrador

    7 páginas2.39B

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación obligatoria

    1 páginasGAZ1

    Notificación de la aprobación presunta de las propuestas

    1 páginasF2.18

    Declaración de la propuesta del administrador

    23 páginas2.17B

    Declaración de asuntos con el formulario 2.14B

    6 páginas2.16B

    Domicilio social registrado cambiado de Suite 47, Aztec Centre Aztec West Almondsbury Bristol Bristol and Ne Somerset BS32 4TD el 14 abr 2011

    2 páginasAD01

    Nombramiento de un administrador

    1 páginas2.12B

    Resoluciones

    Resolutions
    3 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    change-of-name

    Resolución de cambio de nombre de la empresa el 25 mar 2011

    RES15

    Aviso de cambio de nombre

    2 páginasCONNOT

    Cese del nombramiento de Carmen Carey como director

    1 páginasTM01

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación obligatoria

    1 páginasGAZ1

    Se ha descontinuado la acción de cancelación obligatoria

    1 páginasDISS40

    Déclaration annuelle établie au 30 jun 2010 avec liste complète des actionnaires

    8 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital22 oct 2010

    Estado de capital el 22 oct 2010

    • Capital: GBP 1,521,507.387
    SH01

    Cambio de datos del director Carmen Carey el 30 jun 2010

    2 páginasCH01

    Nombramiento de Mrs Sian Castle como secretario

    1 páginasAP03

    Cese del nombramiento de Ashley Cartman como secretario

    1 páginasTM02

    Domicilio social registrado cambiado de Box House Box Corsham Wiltshire SN13 8AA el 29 jun 2010

    1 páginasAD01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2008

    23 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 30 jun 2009 avec liste complète des actionnaires

    13 páginasAR01

    ¿Quiénes son los directivos de CP 100 LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    CASTLE, Sian
    Wood Street
    EC2V 7QF London
    88
    Secretario
    Wood Street
    EC2V 7QF London
    88
    155108950001
    SNOW, Edward
    Beacon Field House, The Causeway
    Therfield
    SG8 9PP Royston
    Hertfordshire
    Director
    Beacon Field House, The Causeway
    Therfield
    SG8 9PP Royston
    Hertfordshire
    United KingdomBritish120026800001
    SZPIRO, James Lucien Alexander
    Talbot Road
    W2 5JJ London
    51b
    Director
    Talbot Road
    W2 5JJ London
    51b
    EnglandBritish136504450001
    CARTMAN, Ashley
    139 Brynland Avenue
    Bishopston
    BS7 9DZ Bristol
    Secretario
    139 Brynland Avenue
    Bishopston
    BS7 9DZ Bristol
    British119027760001
    PAULY, Duncan Gunther
    11 Downfield Close
    Alveston
    BS35 3NJ Bristol
    Secretario
    11 Downfield Close
    Alveston
    BS35 3NJ Bristol
    British31270490006
    BLACKFRIAR SECRETARIES LIMITED
    44 Upper Belgrave Road
    Clifton
    BS8 2XN Bristol
    Avon
    Secretario designado corporativo
    44 Upper Belgrave Road
    Clifton
    BS8 2XN Bristol
    Avon
    900011530001
    ALI, Zahid
    9 Eaton Court
    48 Eaton Rise
    W5 2EU London
    Director
    9 Eaton Court
    48 Eaton Rise
    W5 2EU London
    British69459930001
    CAREY, Carmen
    Linden Gardens
    W2 4HZ London
    Flat 6 61
    Director
    Linden Gardens
    W2 4HZ London
    Flat 6 61
    United KingdomUnited States129984050001
    HABGOOD, Nicholas John
    6 Avery Close
    Finchampstead
    RG40 3SQ Wokingham
    Berkshire
    Director
    6 Avery Close
    Finchampstead
    RG40 3SQ Wokingham
    Berkshire
    United KingdomBritish76793280001
    JOYCE, Richard William
    Swinley Court
    Prince Albert Drive
    SL5 8AQ Ascot
    Berkshire
    Director
    Swinley Court
    Prince Albert Drive
    SL5 8AQ Ascot
    Berkshire
    EnglandBritish74233810001
    KEMP, Nicholas
    The Old School
    Munslow
    SY7 9ET Craven Arms
    Shropshire
    Director
    The Old School
    Munslow
    SY7 9ET Craven Arms
    Shropshire
    British77415980001
    MCCAFFERTY, Paul John
    Brockeridge Cottage
    4 Hillside Lane Frampton Cotterell
    BS36 2HZ Bristol
    Avon
    Director
    Brockeridge Cottage
    4 Hillside Lane Frampton Cotterell
    BS36 2HZ Bristol
    Avon
    United KingdomBritish59596190002
    MITCHELL PALLANDRE, Kathleen
    80 Shorelands Drive
    Madison
    Ct 06443
    Usa
    Director
    80 Shorelands Drive
    Madison
    Ct 06443
    Usa
    United StatesAmerican149414140001
    PAULY, Duncan Gunther
    23 Brunel Close
    Warmley
    BS30 5BB Bristol
    Director
    23 Brunel Close
    Warmley
    BS30 5BB Bristol
    British31270490003
    ROGERSON, Philip Graham
    56 Vogans Mill
    Mill Street
    SE1 2BZ London
    Director
    56 Vogans Mill
    Mill Street
    SE1 2BZ London
    British93942500001
    ROGERSON, Simon Andrew
    Pagoda Cottage
    Pagoda Gardens Blackheath
    SE3 0UZ London
    Director
    Pagoda Cottage
    Pagoda Gardens Blackheath
    SE3 0UZ London
    British68877960002
    ROSE, Steven Christopher Enderwick
    Home Farm
    GU31 5BJ Rogate
    Hampshire
    Director
    Home Farm
    GU31 5BJ Rogate
    Hampshire
    EnglandBritish190797440001
    RYAN, Peter
    Green Farm
    St Maughans
    NP25 5QG Monmouth
    Gwent
    Director
    Green Farm
    St Maughans
    NP25 5QG Monmouth
    Gwent
    United KingdomBritish80305950004
    STEELE, Cameron
    575 Market Street, Suite 1975
    San Francisco
    California 94105
    Usa
    Director
    575 Market Street, Suite 1975
    San Francisco
    California 94105
    Usa
    American113953550001
    SWANN, Allen Albert
    Ladyham
    Fulbrook
    OX18 4BD Burford
    Oxfordshire
    Director
    Ladyham
    Fulbrook
    OX18 4BD Burford
    Oxfordshire
    United KingdomBritish234173890001
    TUCKER, John Anthony
    59 Warminster Road
    Bathampton
    BA2 6RX Bath
    Director
    59 Warminster Road
    Bathampton
    BA2 6RX Bath
    British59596280001
    BLACKFRIAR DIRECTORS LIMITED
    44 Upper Belgrave Road
    Clifton
    BS8 2XN Bristol
    Avon
    Director designado corporativo
    44 Upper Belgrave Road
    Clifton
    BS8 2XN Bristol
    Avon
    900011520001

    ¿Tiene CP 100 LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Debenture
    Creado el 17 oct 2008
    Entregado el 01 nov 2008
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the lender under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personas con derecho
    • Lms Capital 2008 L.P.
    Transacciones
    • 01 nov 2008Registro de un cargo (395)
    Debenture
    Creado el 23 jul 2007
    Entregado el 03 ago 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Lms Capital (Bermuda) Limited
    Transacciones
    • 03 ago 2007Registro de un cargo (395)
    • 16 nov 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 13 jun 2007
    Entregado el 22 jun 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Lms Capital (Bermuda) Limited
    Transacciones
    • 22 jun 2007Registro de un cargo (395)
    • 16 nov 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 22 feb 2007
    Entregado el 13 mar 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Lms Capital (Bermuda) Limited
    Transacciones
    • 13 mar 2007Registro de un cargo (395)
    • 16 nov 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 11 dic 2006
    Entregado el 14 dic 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Lms Capital (Bermuda) Limited
    Transacciones
    • 14 dic 2006Registro de un cargo (395)
    • 16 nov 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 21 sept 2006
    Entregado el 28 sept 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Lms Capital (Bermuda) Limited (the Security Trustee)
    Transacciones
    • 28 sept 2006Registro de un cargo (395)
    • 16 nov 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 31 mar 2006
    Entregado el 08 abr 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the security trustee for itself and each of the noteholders under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Lms Capital (Bermuda) Limited as Security Trustee for the Noteholders
    Transacciones
    • 08 abr 2006Registro de un cargo (395)
    • 16 nov 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 29 dic 2005
    Entregado el 12 ene 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the noteholders and the security trustee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Lms Capital (Bermuda) Limited as Security Trustee for the Noteholders
    Transacciones
    • 12 ene 2006Registro de un cargo (395)
    • 16 nov 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 25 abr 2005
    Entregado el 05 may 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the noteholders and the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Lms Capital (Bermuda) Limited as Security Trustee for the Noteholders
    Transacciones
    • 05 may 2005Registro de un cargo (395)
    • 21 ene 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 19 nov 2004
    Entregado el 06 dic 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the noteholders and the security trustee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Lms Capital (Bermuda) Limited as Security Trustee for the Noteholders
    Transacciones
    • 06 dic 2004Registro de un cargo (395)
    • 21 ene 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    ¿Tiene CP 100 LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    01 abr 2011Inicio de la administración
    16 mar 2012Fin de la administración
    En administración
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Simon Robert Thomas
    Moorfields Corporate Recovery 34 Park Cross Street
    LS1 2QH Leeds
    West Yorkshire
    Profesional
    Moorfields Corporate Recovery 34 Park Cross Street
    LS1 2QH Leeds
    West Yorkshire
    Frederick Charles Satow
    88 Wood Street
    EC2V 7QF London
    Profesional
    88 Wood Street
    EC2V 7QF London
    Robert Harry Pick
    88 Wood Street
    EC2V 7QF London
    Profesional
    88 Wood Street
    EC2V 7QF London

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0