TRADER MEDIA GROUP HOLDINGS LIMITED

TRADER MEDIA GROUP HOLDINGS LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaTRADER MEDIA GROUP HOLDINGS LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 03591323
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de TRADER MEDIA GROUP HOLDINGS LIMITED?

    • Actividades de oficinas centrales (70100) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra TRADER MEDIA GROUP HOLDINGS LIMITED?

    Dirección de la sede social
    1 Tony Wilson Place
    M15 4FN Manchester
    England
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de TRADER MEDIA GROUP HOLDINGS LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    HURST PUBLISHING HOLDINGS LIMITED03 jul 199803 jul 1998
    HURST NEWCO 2 LIMITED26 jun 199826 jun 1998

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de TRADER MEDIA GROUP HOLDINGS LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta29 mar 2015

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para TRADER MEDIA GROUP HOLDINGS LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros

    6 páginas4.71

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    2 páginas600

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo especial para la liquidación el 24 mar 2016

    LRESSP

    Declaración de solvencia

    3 páginas4.70

    Cancelación total de la carga 035913230008

    1 páginasMR04

    Cuentas completas preparadas hasta el 29 mar 2015

    12 páginasAA

    Cese del nombramiento de Joanne Walker como director el 22 jun 2015

    1 páginasTM01

    Memorándum y Estatutos

    9 páginasMA

    Resoluciones

    Resolutions
    3 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    incorporation

    Resolución de modificación de los Artículos de Asociación

    RES01

    Déclaration annuelle établie au 20 may 2015 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital28 may 2015

    Estado de capital el 28 may 2015

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Resoluciones

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    incorporation

    Resolución de modificación de los Artículos de Asociación

    RES01

    Registro de la carga 035913230008, creada el 15 abr 2015

    31 páginasMR01

    Cancelación total de la carga 035913230007

    1 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 035913230006

    1 páginasMR04

    Cambio de datos del director Mrs Joanne Walker el 18 mar 2015

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Mr Ian Somerset el 17 mar 2015

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del secretario Mr Sean Glithero el 17 mar 2015

    1 páginasCH03

    Cambio de datos del director Mr Sean Robert Glithero el 17 mar 2015

    2 páginasCH01

    Domicilio social registrado cambiado de Auto Trader House, Cutbush Park Industrial Estate Danehill Lower Earley Reading Berkshire RG6 4UT a 1 Tony Wilson Place Manchester England M15 4FN el 23 dic 2014

    1 páginasAD01

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 mar 2014

    11 páginasAA

    Cese del nombramiento de Tara Collet como director el 03 oct 2014

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Ian Somerset como director el 25 sept 2014

    2 páginasAP01

    Déclaration annuelle établie au 20 may 2014 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital28 may 2014

    Estado de capital el 28 may 2014

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Registro de la carga 035913230007

    27 páginasMR01

    ¿Quiénes son los directivos de TRADER MEDIA GROUP HOLDINGS LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    GLITHERO, Sean
    Tony Wilson Place
    M15 4FN Manchester
    1
    England
    England
    Secretario
    Tony Wilson Place
    M15 4FN Manchester
    1
    England
    England
    159905460001
    GLITHERO, Sean Robert
    Tony Wilson Place
    M15 4FN Manchester
    1
    England
    England
    Director
    Tony Wilson Place
    M15 4FN Manchester
    1
    England
    England
    EnglandBritish129229070002
    SOMERSET, Ian
    Tony Wilson Place
    M15 4FN Manchester
    1
    England
    England
    Director
    Tony Wilson Place
    M15 4FN Manchester
    1
    England
    England
    EnglandBritish191225040001
    BESWITHERICK, David Peter
    12 Horncastle Close
    BL8 1XE Bury
    Lancashire
    Secretario
    12 Horncastle Close
    BL8 1XE Bury
    Lancashire
    British15959630001
    HODGSON, Simon
    28 Malvern Close
    Woodley
    RG5 4HL Reading
    Berkshire
    Secretario
    28 Malvern Close
    Woodley
    RG5 4HL Reading
    Berkshire
    British6848030001
    HOWARD, Katherine Frances
    25a Gorringe Road
    SP2 7JA Salisbury
    Wiltshire
    Secretario
    25a Gorringe Road
    SP2 7JA Salisbury
    Wiltshire
    British86019470001
    JENKIN, Elizabeth
    Sundew Close
    RG40 5YB Wokingham
    7
    Berkshire
    United Kingdom
    Secretario
    Sundew Close
    RG40 5YB Wokingham
    7
    Berkshire
    United Kingdom
    British137518870001
    MILLER, Andrew Arthur
    The Cottage
    Bucklebury Alley, Cold Ash
    RG18 9NN Thatcham
    Berkshire
    Secretario
    The Cottage
    Bucklebury Alley, Cold Ash
    RG18 9NN Thatcham
    Berkshire
    British162220750001
    MILLER, Andrew Arthur
    The Cottage
    Bucklebury Alley, Cold Ash
    RG18 9NN Thatcham
    Berkshire
    Secretario
    The Cottage
    Bucklebury Alley, Cold Ash
    RG18 9NN Thatcham
    Berkshire
    British162220750001
    MUIRHEAD, Brian Geoffrey
    Foxley House
    High Street
    OX7 5RH Great Rollright
    Oxfordshire
    Secretario
    Foxley House
    High Street
    OX7 5RH Great Rollright
    Oxfordshire
    United Kingdom155633620001
    PERRISS, Robyn
    The Corn Stook
    Skinners Green, Enborne
    RG14 6RE Newbury
    Berkshire
    Secretario
    The Corn Stook
    Skinners Green, Enborne
    RG14 6RE Newbury
    Berkshire
    South African97879810002
    BYNG-MADDICK, Zillah Ellen
    Danehill
    Lower Earley
    RG6 4UT Reading
    Auto Trader House, Cutbush Park Industrial Estate
    Berkshire
    United Kingdom
    Director
    Danehill
    Lower Earley
    RG6 4UT Reading
    Auto Trader House, Cutbush Park Industrial Estate
    Berkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish147214630001
    CASTRO, Nicholas
    18 Branscombe Gardens
    N21 3BN London
    Director
    18 Branscombe Gardens
    N21 3BN London
    EnglandBritish39006500001
    COLLET, Tara
    Wing Close
    SL7 2RA Marlow
    2
    Bucks
    United Kingdom
    Director
    Wing Close
    SL7 2RA Marlow
    2
    Bucks
    United Kingdom
    EnglandBritish160951420001
    HODGSON, Simon
    28 Malvern Close
    Woodley
    RG5 4HL Reading
    Berkshire
    Director
    28 Malvern Close
    Woodley
    RG5 4HL Reading
    Berkshire
    British6848030001
    HOWARD, Katherine Frances
    25a Gorringe Road
    SP2 7JA Salisbury
    Wiltshire
    Director
    25a Gorringe Road
    SP2 7JA Salisbury
    Wiltshire
    British86019470001
    LANE, Stephen John Roger
    55 Matlock Road
    Caversham
    RG4 7BP Reading
    Berkshire
    Director
    55 Matlock Road
    Caversham
    RG4 7BP Reading
    Berkshire
    EnglandBritish123670600001
    LUFF, Graham Ewart
    Willows Westbrook
    Boxford
    RG20 8DN Newbury
    Berkshire
    Director
    Willows Westbrook
    Boxford
    RG20 8DN Newbury
    Berkshire
    British46555440002
    MCCALL, Carolyn Julia
    New Tesco House
    Delamare Road
    EN8 9SL Cheshunt
    Hertfordshire
    Director
    New Tesco House
    Delamare Road
    EN8 9SL Cheshunt
    Hertfordshire
    British39252480010
    MILLER, Andrew Arthur
    The Cottage
    Bucklebury Alley, Cold Ash
    RG18 9NN Thatcham
    Berkshire
    Director
    The Cottage
    Bucklebury Alley, Cold Ash
    RG18 9NN Thatcham
    Berkshire
    United KingdomBritish162220750001
    MUIRHEAD, Brian Geoffrey
    Foxley House
    High Street
    OX7 5RH Great Rollright
    Oxfordshire
    Director
    Foxley House
    High Street
    OX7 5RH Great Rollright
    Oxfordshire
    EnglandUnited Kingdom155633620001
    PERRISS, Robyn
    The Corn Stook
    Skinners Green, Enborne
    RG14 6RE Newbury
    Berkshire
    Director
    The Corn Stook
    Skinners Green, Enborne
    RG14 6RE Newbury
    Berkshire
    South African97879810002
    WALKER, Joanne
    Tony Wilson Place
    M15 4FN Manchester
    1
    England
    England
    Director
    Tony Wilson Place
    M15 4FN Manchester
    1
    England
    England
    EnglandBritish180119580001

    ¿Tiene TRADER MEDIA GROUP HOLDINGS LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    A registered charge
    Creado el 15 abr 2015
    Entregado el 20 abr 2015
    Satisfecho en su totalidad
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Wilmington Trust (London) Limited and Its Successors in Title and Permitted Transferees
    Transacciones
    • 20 abr 2015Registro de una carga (MR01)
    • 08 ene 2016Satisfacción de una carga (MR04)
    A registered charge
    Creado el 26 feb 2014
    Entregado el 13 mar 2014
    Satisfecho en su totalidad
    Breve descripción
    None. Notification of addition to or amendment of charge.
    Personas con derecho
    • Wilmington Trust (London) Limited as Security Agent for the Secured Parties
    Transacciones
    • 13 mar 2014Registro de una carga (MR01)
    • 25 mar 2015Satisfacción de una carga (MR04)
    A registered charge
    Creado el 26 feb 2014
    Entregado el 13 mar 2014
    Satisfecho en su totalidad
    Breve descripción
    Notification of addition to or amendment of charge.
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Wilmington Trust (London) Limited as Security Agent for the Secured Parties
    Transacciones
    • 13 mar 2014Registro de una carga (MR01)
    • 25 mar 2015Satisfacción de una carga (MR04)
    Global accession deed
    Creado el 03 oct 2003
    Entregado el 10 oct 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each obligor to the secured creditors (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Agent
    Transacciones
    • 10 oct 2003Registro de un cargo (395)
    • 01 mar 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Charge on cash collateral deposit
    Creado el 30 abr 2003
    Entregado el 19 may 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    All its right title and interest in the deposit moneys from time to time standing to the credit of the cash collateral account held with the royal bank of scotland ac no: 20207614 s/c no: 160400. see the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 19 may 2003Registro de un cargo (395)
    • 11 oct 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Supplemental debenture , supplementing and amending a debenture dated 21/07/98 between the company and each of the companies listed therein
    Creado el 24 may 2000
    Entregado el 08 jun 2000
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All present ans future obligations and liabilities (whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever ) of each obligor to the lenders (or any of them) under each of the senior finance documents, the senior subordinated facility agreement and the hedging documents
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Deutsche Bank Ag London as Agent and Trustee for Itself and Each of the Lenders
    Transacciones
    • 08 jun 2000Registro de un cargo (395)
    • 11 oct 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Charge on cash collateral deposit
    Creado el 21 jul 1998
    Entregado el 07 ago 1998
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the termsof the deed and/or the investor deed dated 4TH july 1998
    Breve descripción
    First fixed charge all the company's right title and interest in and to the deposit monies and the debt represented by the deposit monies. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Deutsche Bank A.G.
    Transacciones
    • 07 ago 1998Registro de un cargo (395)
    • 11 oct 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 21 jul 1998
    Entregado el 07 ago 1998
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any other companies named therein (each an "obligor") to the chargees under the terms of each or any of the senior finance documents, the mezzanine finance documents and the hedging documents (all as defined in the debenture)
    Breve descripción
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Deutsche Bank Ag London(As Agent and Trustee for Itself and Each of the Lenders)
    Transacciones
    • 07 ago 1998Registro de un cargo (395)
    • 11 oct 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    ¿Tiene TRADER MEDIA GROUP HOLDINGS LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    24 mar 2016Inicio de la liquidación
    21 ene 2017Fecha de disolución
    Liquidación voluntaria de socios
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Emma Cray
    Benson House
    33 Wellington Street
    LS1 4JP Leeds
    Profesional
    Benson House
    33 Wellington Street
    LS1 4JP Leeds
    Karen Lesley Dukes
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Profesional
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0