TRADER MEDIA GROUP HOLDINGS LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | TRADER MEDIA GROUP HOLDINGS LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 03591323 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | Sí |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de TRADER MEDIA GROUP HOLDINGS LIMITED?
- Actividades de oficinas centrales (70100) / Actividades profesionales, científicas y técnicas
¿Dónde se encuentra TRADER MEDIA GROUP HOLDINGS LIMITED?
| Dirección de la sede social | 1 Tony Wilson Place M15 4FN Manchester England |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de TRADER MEDIA GROUP HOLDINGS LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| HURST PUBLISHING HOLDINGS LIMITED | 03 jul 1998 | 03 jul 1998 |
| HURST NEWCO 2 LIMITED | 26 jun 1998 | 26 jun 1998 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de TRADER MEDIA GROUP HOLDINGS LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 29 mar 2015 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para TRADER MEDIA GROUP HOLDINGS LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaceta final disuelta tras la liquidación | 1 páginas | GAZ2 | ||||||||||
Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros | 6 páginas | 4.71 | ||||||||||
Nombramiento de un liquidador voluntario | 2 páginas | 600 | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Declaración de solvencia | 3 páginas | 4.70 | ||||||||||
Cancelación total de la carga 035913230008 | 1 páginas | MR04 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 29 mar 2015 | 12 páginas | AA | ||||||||||
Cese del nombramiento de Joanne Walker como director el 22 jun 2015 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Memorándum y Estatutos | 9 páginas | MA | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 3 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Déclaration annuelle établie au 20 may 2015 avec liste complète des actionnaires | 6 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Resoluciones Resolutions | RESOLUTIONS | |||||||||||
| ||||||||||||
Registro de la carga 035913230008, creada el 15 abr 2015 | 31 páginas | MR01 | ||||||||||
Cancelación total de la carga 035913230007 | 1 páginas | MR04 | ||||||||||
Cancelación total de la carga 035913230006 | 1 páginas | MR04 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mrs Joanne Walker el 18 mar 2015 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Ian Somerset el 17 mar 2015 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cambio de datos del secretario Mr Sean Glithero el 17 mar 2015 | 1 páginas | CH03 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Sean Robert Glithero el 17 mar 2015 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de Auto Trader House, Cutbush Park Industrial Estate Danehill Lower Earley Reading Berkshire RG6 4UT a 1 Tony Wilson Place Manchester England M15 4FN el 23 dic 2014 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 30 mar 2014 | 11 páginas | AA | ||||||||||
Cese del nombramiento de Tara Collet como director el 03 oct 2014 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Ian Somerset como director el 25 sept 2014 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 20 may 2014 avec liste complète des actionnaires | 6 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Registro de la carga 035913230007 | 27 páginas | MR01 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de TRADER MEDIA GROUP HOLDINGS LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLITHERO, Sean | Secretario | Tony Wilson Place M15 4FN Manchester 1 England England | 159905460001 | |||||||
| GLITHERO, Sean Robert | Director | Tony Wilson Place M15 4FN Manchester 1 England England | England | British | 129229070002 | |||||
| SOMERSET, Ian | Director | Tony Wilson Place M15 4FN Manchester 1 England England | England | British | 191225040001 | |||||
| BESWITHERICK, David Peter | Secretario | 12 Horncastle Close BL8 1XE Bury Lancashire | British | 15959630001 | ||||||
| HODGSON, Simon | Secretario | 28 Malvern Close Woodley RG5 4HL Reading Berkshire | British | 6848030001 | ||||||
| HOWARD, Katherine Frances | Secretario | 25a Gorringe Road SP2 7JA Salisbury Wiltshire | British | 86019470001 | ||||||
| JENKIN, Elizabeth | Secretario | Sundew Close RG40 5YB Wokingham 7 Berkshire United Kingdom | British | 137518870001 | ||||||
| MILLER, Andrew Arthur | Secretario | The Cottage Bucklebury Alley, Cold Ash RG18 9NN Thatcham Berkshire | British | 162220750001 | ||||||
| MILLER, Andrew Arthur | Secretario | The Cottage Bucklebury Alley, Cold Ash RG18 9NN Thatcham Berkshire | British | 162220750001 | ||||||
| MUIRHEAD, Brian Geoffrey | Secretario | Foxley House High Street OX7 5RH Great Rollright Oxfordshire | United Kingdom | 155633620001 | ||||||
| PERRISS, Robyn | Secretario | The Corn Stook Skinners Green, Enborne RG14 6RE Newbury Berkshire | South African | 97879810002 | ||||||
| BYNG-MADDICK, Zillah Ellen | Director | Danehill Lower Earley RG6 4UT Reading Auto Trader House, Cutbush Park Industrial Estate Berkshire United Kingdom | United Kingdom | British | 147214630001 | |||||
| CASTRO, Nicholas | Director | 18 Branscombe Gardens N21 3BN London | England | British | 39006500001 | |||||
| COLLET, Tara | Director | Wing Close SL7 2RA Marlow 2 Bucks United Kingdom | England | British | 160951420001 | |||||
| HODGSON, Simon | Director | 28 Malvern Close Woodley RG5 4HL Reading Berkshire | British | 6848030001 | ||||||
| HOWARD, Katherine Frances | Director | 25a Gorringe Road SP2 7JA Salisbury Wiltshire | British | 86019470001 | ||||||
| LANE, Stephen John Roger | Director | 55 Matlock Road Caversham RG4 7BP Reading Berkshire | England | British | 123670600001 | |||||
| LUFF, Graham Ewart | Director | Willows Westbrook Boxford RG20 8DN Newbury Berkshire | British | 46555440002 | ||||||
| MCCALL, Carolyn Julia | Director | New Tesco House Delamare Road EN8 9SL Cheshunt Hertfordshire | British | 39252480010 | ||||||
| MILLER, Andrew Arthur | Director | The Cottage Bucklebury Alley, Cold Ash RG18 9NN Thatcham Berkshire | United Kingdom | British | 162220750001 | |||||
| MUIRHEAD, Brian Geoffrey | Director | Foxley House High Street OX7 5RH Great Rollright Oxfordshire | England | United Kingdom | 155633620001 | |||||
| PERRISS, Robyn | Director | The Corn Stook Skinners Green, Enborne RG14 6RE Newbury Berkshire | South African | 97879810002 | ||||||
| WALKER, Joanne | Director | Tony Wilson Place M15 4FN Manchester 1 England England | England | British | 180119580001 |
¿Tiene TRADER MEDIA GROUP HOLDINGS LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Creado el 15 abr 2015 Entregado el 20 abr 2015 | Satisfecho en su totalidad | ||
Contiene una promesa negativa: Sí Contiene una garantía fija: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| A registered charge | Creado el 26 feb 2014 Entregado el 13 mar 2014 | Satisfecho en su totalidad | ||
Breve descripción None. Notification of addition to or amendment of charge. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| A registered charge | Creado el 26 feb 2014 Entregado el 13 mar 2014 | Satisfecho en su totalidad | ||
Breve descripción Notification of addition to or amendment of charge. Contiene una garantía fija: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Global accession deed | Creado el 03 oct 2003 Entregado el 10 oct 2003 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from each obligor to the secured creditors (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Charge on cash collateral deposit | Creado el 30 abr 2003 Entregado el 19 may 2003 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción All its right title and interest in the deposit moneys from time to time standing to the credit of the cash collateral account held with the royal bank of scotland ac no: 20207614 s/c no: 160400. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Supplemental debenture , supplementing and amending a debenture dated 21/07/98 between the company and each of the companies listed therein | Creado el 24 may 2000 Entregado el 08 jun 2000 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All present ans future obligations and liabilities (whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever ) of each obligor to the lenders (or any of them) under each of the senior finance documents, the senior subordinated facility agreement and the hedging documents | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Charge on cash collateral deposit | Creado el 21 jul 1998 Entregado el 07 ago 1998 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee under the termsof the deed and/or the investor deed dated 4TH july 1998 | |
Breve descripción First fixed charge all the company's right title and interest in and to the deposit monies and the debt represented by the deposit monies. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 21 jul 1998 Entregado el 07 ago 1998 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company and/or all or any other companies named therein (each an "obligor") to the chargees under the terms of each or any of the senior finance documents, the mezzanine finance documents and the hedging documents (all as defined in the debenture) | |
Breve descripción .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
¿Tiene TRADER MEDIA GROUP HOLDINGS LIMITED algún caso de insolvencia?
| Número de expediente | Fechas | Tipo | Profesionales | Otro | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidación voluntaria de socios |
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0