PARTNERS ANDREWS ALDRIDGE LIMITED

PARTNERS ANDREWS ALDRIDGE LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración anual
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaPARTNERS ANDREWS ALDRIDGE LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 03595717
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de PARTNERS ANDREWS ALDRIDGE LIMITED?

    • Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales

    ¿Dónde se encuentra PARTNERS ANDREWS ALDRIDGE LIMITED?

    Dirección de la sede social
    60 Great Portland Street
    W1W 7RT London
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de PARTNERS ANDREWS ALDRIDGE LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    LINEDART LIMITED09 jul 199809 jul 1998

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de PARTNERS ANDREWS ALDRIDGE LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2013

    ¿Cuál es el estado de la última declaración anual para PARTNERS ANDREWS ALDRIDGE LIMITED?

    Declaración anual
    Última declaración anual

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para PARTNERS ANDREWS ALDRIDGE LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    legacy

    1 páginasSH20

    Estado de capital el 15 dic 2014

    • Capital: GBP 1
    4 páginasSH19

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06
    capital

    Resoluciones

    Cancellation of share premium account 12/12/2014
    RES13

    Cese del nombramiento de Peter John Scott como director el 10 dic 2014

    1 páginasTM01

    Misceláneos

    Section 519
    2 páginasMISC

    Cancelación total de la carga 035957170009

    4 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 8

    4 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 7

    4 páginasMR04

    Cuentas preparadas hasta el 31 dic 2013

    7 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 28 jun 2014 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01

    Cuentas de subsidiaria exentas de auditoría preparadas hasta el 31 dic 2012

    12 páginasAA

    legacy

    48 páginasPARENT_ACC

    legacy

    1 páginasAGREEMENT2

    legacy

    3 páginasGUARANTEE2

    Déclaration annuelle établie au 28 jun 2013 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01

    Registro de la carga 035957170009, creada el 26 jul 2013

    60 páginasMR01

    Nombramiento de Miss Mary Louise Cole como secretario el 19 mar 2013

    1 páginasAP03

    Cese del nombramiento de Susanna Ewing como secretario el 21 dic 2012

    1 páginasTM02

    Cese del nombramiento de Edmund Martin Smiley Jones como director el 31 oct 2012

    1 páginasTM01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2011

    21 páginasAA

    Nombramiento de Susanna Ewing como secretario el 30 jun 2012

    1 páginasAP03

    ¿Quiénes son los directivos de PARTNERS ANDREWS ALDRIDGE LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    COLE, Mary Louise
    Great Portland Street
    W1W 7RT London
    60
    Secretario
    Great Portland Street
    W1W 7RT London
    60
    177910110001
    KLEIN, Deborah
    87 St Gabriels Road
    NW2 4DU London
    Director
    87 St Gabriels Road
    NW2 4DU London
    United KingdomBritishDirector104574070001
    MARTIN, Ashley Graham
    Great Portland Street
    W1W 7RT London
    60
    Director
    Great Portland Street
    W1W 7RT London
    60
    United KingdomBritishFinance Director169305720001
    BAILEY, Dionne Marie
    24 Dellfield
    AL1 5HB St Albans
    Hertfordshire
    Secretario
    24 Dellfield
    AL1 5HB St Albans
    Hertfordshire
    New ZealandAccountant93416160002
    BAILEY, Dionne Marie
    24 Dellfield
    AL1 5HB St Albans
    Hertfordshire
    Secretario
    24 Dellfield
    AL1 5HB St Albans
    Hertfordshire
    New ZealandAccountant93416160002
    BALLARD, Jude
    68a Oaklands Road
    Hanwell
    W7 2DU London
    Secretario
    68a Oaklands Road
    Hanwell
    W7 2DU London
    BritishFinancial Controller71591810002
    BRAND, Peter William
    50 Longtye Drive
    Chestfield
    CT5 3NF Whitstable
    Kent
    Secretario
    50 Longtye Drive
    Chestfield
    CT5 3NF Whitstable
    Kent
    British33349000002
    DAY, Ian Philip
    5b Bury Lane
    Codicote
    SG4 8XX Hitchin
    Hertfordshire
    Secretario
    5b Bury Lane
    Codicote
    SG4 8XX Hitchin
    Hertfordshire
    BritishDirector74800310002
    ELLSE, Simon Richard
    West Lodge Cottage 33 West Street
    RH4 1DD Dorking
    Surrey
    Secretario
    West Lodge Cottage 33 West Street
    RH4 1DD Dorking
    Surrey
    BritishAccountant34468680004
    EWING, Susanna
    Great Portland Street
    W1W 7RT London
    60
    Secretario
    Great Portland Street
    W1W 7RT London
    60
    171623130001
    GRUNDY, Bryan
    14 Veronica Gardens
    SW16 5JS Streatham
    Secretario
    14 Veronica Gardens
    SW16 5JS Streatham
    BritishManagement Accountant111852370002
    HARRIS, Peter
    Great Portland Street
    W1W 7RT London
    60
    Secretario
    Great Portland Street
    W1W 7RT London
    60
    151473680001
    HOLDGATE, Deborah
    49 Brodrick Road
    SW17 7DX London
    Secretario
    49 Brodrick Road
    SW17 7DX London
    BritishAccountant43041010002
    MARSHALL, Peter John David
    33 Oathall Road
    RH16 3EG Haywards Heath
    West Sussex
    Secretario
    33 Oathall Road
    RH16 3EG Haywards Heath
    West Sussex
    British54426680002
    LONDON LAW SECRETARIAL LIMITED
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    Secretario designado corporativo
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    900001510001
    ALDRIDGE, Stephen John
    104 Kempe Road
    NW6 6SL London
    Director
    104 Kempe Road
    NW6 6SL London
    United KingdomBritishCreative Director59790370002
    ANDREWS, Philip Kenneth
    Great Portland Street
    W1W 7RT London
    60
    Director
    Great Portland Street
    W1W 7RT London
    60
    United KingdomBritishChief Executive59790330006
    BALLARD, Jude
    68a Oaklands Road
    Hanwell
    W7 2DU London
    Director
    68a Oaklands Road
    Hanwell
    W7 2DU London
    BritishFinancial Director71591810002
    CHAPMAN, Aidan Gerard
    74 Marshalswick Lane
    AL1 4XE St Albans
    Hertfordshire
    Director
    74 Marshalswick Lane
    AL1 4XE St Albans
    Hertfordshire
    United KingdomBritishAccountant51799970001
    DAVISON, William Mark
    Picks Barn
    The Green Stonesby
    LE14 4QE Melton Mowbray
    Leicestershire
    Director
    Picks Barn
    The Green Stonesby
    LE14 4QE Melton Mowbray
    Leicestershire
    EnglandBritishDirect Marketing37345670002
    DAY, Ian Philip
    5b Bury Lane
    Codicote
    SG4 8XX Hitchin
    Hertfordshire
    Director
    5b Bury Lane
    Codicote
    SG4 8XX Hitchin
    Hertfordshire
    EnglandBritishDirector74800310002
    ELLSE, Simon Richard
    West Lodge Cottage 33 West Street
    RH4 1DD Dorking
    Surrey
    Director
    West Lodge Cottage 33 West Street
    RH4 1DD Dorking
    Surrey
    BritishAccountant34468680004
    FOX, Victoria
    Flat 1
    7 Highwood Road
    N19 4PN London
    Greater London
    Director
    Flat 1
    7 Highwood Road
    N19 4PN London
    Greater London
    BritishAdvertising112271510001
    GOWAR, Jon
    Flat 6
    21 Chartfield Avenue
    SW15 6DX London
    Director
    Flat 6
    21 Chartfield Avenue
    SW15 6DX London
    BritishManaging Partner102980350002
    HARRIS, Peter Jonathan
    Great Portland Street
    W1W 7RT London
    60
    Director
    Great Portland Street
    W1W 7RT London
    60
    EnglandBritishDirector40917640001
    HARTLEY, Mark Graham
    15 Church Hill
    CR8 3QP Purley
    Surrey
    Director
    15 Church Hill
    CR8 3QP Purley
    Surrey
    United KingdomBritishSolicitor1472660001
    HOLDGATE, Deborah
    49 Brodrick Road
    SW17 7DX London
    Director
    49 Brodrick Road
    SW17 7DX London
    BritishAccountant43041010002
    JAMES, Harrison
    82 Balham Grove
    Balham
    SW12 8BE London
    Director
    82 Balham Grove
    Balham
    SW12 8BE London
    BritishDirector101528750001
    JASINSKI, Nina Marta
    April Cottage
    18 Danes Way
    KT22 0LX Oxshott
    Surrey
    Director
    April Cottage
    18 Danes Way
    KT22 0LX Oxshott
    Surrey
    EnglandBritishMarketing Partner141323990001
    LONG, Nigel Gregory
    Cotswold Lodge
    17 Westfield Road
    HP9 1EF Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Director
    Cotswold Lodge
    17 Westfield Road
    HP9 1EF Beaconsfield
    Buckinghamshire
    EnglandBritishDirector46299270001
    MORAN, Shaun Micheal
    14 Tuskar Street
    Greenwich
    SE10 9UR London
    Director
    14 Tuskar Street
    Greenwich
    SE10 9UR London
    BritishCreative Director84990220001
    SCOTT, Peter John
    9 Pelham Crescent
    South Kensington
    SW7 2NP London
    Middlesex
    Director
    9 Pelham Crescent
    South Kensington
    SW7 2NP London
    Middlesex
    EnglandBritishDirector97249440006
    SMILEY JONES, Edmund Martin
    Debdale Farm
    Melton Spinney Road
    LE14 4SB Melton Mowbray
    Leicestershire
    Director
    Debdale Farm
    Melton Spinney Road
    LE14 4SB Melton Mowbray
    Leicestershire
    United KingdomBritishMarketing84434950001
    SNOXELL, Paul Antony
    17 Spencer Gate
    AL1 4AD St Albans
    Hertfordshire
    Director
    17 Spencer Gate
    AL1 4AD St Albans
    Hertfordshire
    United KingdomBritishCreative Director165155480001
    TOALDO, Simon
    Brunswick House The Pound
    Cookham
    SL6 9QD Maidenhead
    Berkshire
    Director
    Brunswick House The Pound
    Cookham
    SL6 9QD Maidenhead
    Berkshire
    BritishDirector63244280004

    ¿Tiene PARTNERS ANDREWS ALDRIDGE LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    A registered charge
    Creado el 26 jul 2013
    Entregado el 31 jul 2013
    Satisfecho en su totalidad
    Breve descripción
    Notification of addition to or amendment of charge.
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Incap Finance B.V.
    Transacciones
    • 31 jul 2013Registro de una carga (MR01)
    • 09 sept 2014Satisfacción de una carga (MR04)
    Debenture
    Creado el 20 may 2011
    Entregado el 04 jun 2011
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each chargor to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor & Company of the Bank of Ireland
    Transacciones
    • 04 jun 2011Registro de un cargo (MG01)
    • 09 sept 2014Satisfacción de una carga (MR04)
    A deed of accession to a debenture
    Creado el 15 feb 2008
    Entregado el 22 feb 2008
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each chargor to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland (The Security Trustee)
    Transacciones
    • 22 feb 2008Registro de un cargo (395)
    • 24 may 2011Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad gravada ha sido liberada (MG04)
    • 09 sept 2014Satisfacción de una carga (MR04)
    Debenture
    Creado el 13 jul 2004
    Entregado el 28 jul 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 28 jul 2004Registro de un cargo (395)
    • 01 abr 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    A deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 16TH october 2000
    Creado el 24 feb 2003
    Entregado el 28 feb 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies and liabilities due or to become due from either the company or any one or more of the other parties to the agreement (other than the bank) to the chargee
    Breve descripción
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with the bank.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 28 feb 2003Registro de un cargo (395)
    • 15 jul 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    A deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 16TH october 2000 (the "agreement")
    Creado el 11 feb 2003
    Entregado el 13 feb 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with the bank.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 13 feb 2003Registro de un cargo (395)
    • 15 jul 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    A deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 16TH october 2000 and
    Creado el 09 ago 2002
    Entregado el 10 ago 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with the bank.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 10 ago 2002Registro de un cargo (395)
    • 15 jul 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 16TH october 2000 and
    Creado el 25 jun 2002
    Entregado el 03 jul 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with the bank.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 03 jul 2002Registro de un cargo (395)
    • 15 jul 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creado el 27 jul 1998
    Entregado el 08 ago 1998
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Partners Bddh Limited
    Transacciones
    • 08 ago 1998Registro de un cargo (395)
    • 15 jul 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0