PROTECTAGROUP LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaPROTECTAGROUP LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 03599653
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de PROTECTAGROUP LIMITED?

    • Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales

    ¿Dónde se encuentra PROTECTAGROUP LIMITED?

    Dirección de la sede social
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de PROTECTAGROUP LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    MOTAQUOTE HOLDINGS LIMITED11 dic 200211 dic 2002
    FINALROUND LIMITED17 jul 199817 jul 1998

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de PROTECTAGROUP LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2017

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para PROTECTAGROUP LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros

    6 páginasLIQ13

    Domicilio social registrado cambiado de Tower Gate House Eclipse Park Sittingbourne Road Maidstone Kent ME14 3EN a 15 Canada Square London E14 5GL el 11 mar 2019

    2 páginasAD01

    Declaración de solvencia

    5 páginasLIQ01

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    3 páginas600

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo especial para la liquidación el 15 feb 2019

    LRESSP

    Nombramiento de Dean Clarke como secretario el 11 dic 2018

    2 páginasAP03

    Cese del nombramiento de Geoffrey Costerton Gouriet como secretario el 11 dic 2018

    1 páginasTM02

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2017

    4 páginasAA

    Cancelación total de la carga 035996530014

    1 páginasMR04

    Nombramiento de Mr Geoffrey Costerton Gouriet como secretario el 03 ago 2018

    2 páginasAP03

    Cese del nombramiento de Jacqueline Anne Gregory como secretario el 03 ago 2018

    1 páginasTM02

    Declaración de confirmación presentada el 22 jun 2018 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Nombramiento de Mr Antonios Erotocritou como director el 02 mar 2018

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Mark Stephen Mugge como director el 02 mar 2018

    1 páginasTM01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2016

    21 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 22 jun 2017 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    Nombramiento de Mr David Christopher Ross como director el 20 dic 2016

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mrs Jacqueline Anne Gregory como secretario el 20 dic 2016

    2 páginasAP03

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2015

    27 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 17 jul 2016 con actualizaciones

    5 páginasCS01

    Cese del nombramiento de Jennifer Owens como secretario el 01 mar 2016

    1 páginasTM02

    Cambio de datos del director Mr Mark Stephen Mugge el 25 nov 2015

    2 páginasCH01

    Cancelación total de la carga 12

    4 páginasMR04

    Cese del nombramiento de Scott Egan como director el 14 sept 2015

    1 páginasTM01

    ¿Quiénes son los directivos de PROTECTAGROUP LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    CLARKE, Dean
    Canada Square
    E14 5GL London
    15
    Secretario
    Canada Square
    E14 5GL London
    15
    253940010001
    EROTOCRITOU, Antonios
    Canada Square
    E14 5GL London
    15
    Director
    Canada Square
    E14 5GL London
    15
    United KingdomCypriot167795710001
    ROSS, David Christopher
    Canada Square
    E14 5GL London
    15
    Director
    Canada Square
    E14 5GL London
    15
    United KingdomIrish222326970001
    BROWN, Ian William
    36 Beech Wood Drive
    Tonyrefail
    CF39 8JE Rhondda Cynon Taff
    Mid Glamorgan
    Secretario
    36 Beech Wood Drive
    Tonyrefail
    CF39 8JE Rhondda Cynon Taff
    Mid Glamorgan
    British262382040001
    CLARK, Samuel Thomas Budgen
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    England
    Secretario
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    England
    British117669700002
    GOURIET, Geoffrey Costerton
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    Secretario
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    249430920001
    GREGORY, Jacqueline Anne
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    Secretario
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    221973010001
    KIRKNESS, Barrie
    76 Glan Y Ffordd
    CF15 7SL Taffs Well
    South Glamorgan
    Secretario
    76 Glan Y Ffordd
    CF15 7SL Taffs Well
    South Glamorgan
    British103733180001
    OWENS, Jennifer
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    England
    Secretario
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    England
    183327890001
    RAGAN, Sharon Marie
    Old Tregyrnog Farmhouse
    St Brides Super Ely
    CF5 6EZ Cardiff
    Secretario
    Old Tregyrnog Farmhouse
    St Brides Super Ely
    CF5 6EZ Cardiff
    British67745500003
    SECRETARIAL APPOINTMENTS LIMITED
    16 Churchill Way
    CF10 2DX Cardiff
    Secretario designado corporativo
    16 Churchill Way
    CF10 2DX Cardiff
    900017270001
    ATTWOOD, Leo Samuel
    127 Kennerleigh Road
    Rumney
    CF3 4BH Cardiff
    Director
    127 Kennerleigh Road
    Rumney
    CF3 4BH Cardiff
    British102933950002
    BARR, Graham Maxwell
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    England
    Director
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    England
    United KingdomBritish125097020001
    BRICE, Richard Ian James
    14 Hensol Villas
    Hensol
    CF72 8JZ Pontyclun
    Mid Glamorgan
    Director
    14 Hensol Villas
    Hensol
    CF72 8JZ Pontyclun
    Mid Glamorgan
    WalesWelsh120606700001
    BROWN, Ian William
    Gate House
    Eclipse Park, Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    United Kingdom
    Director
    Gate House
    Eclipse Park, Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    United Kingdom
    United KingdomBritish262382040001
    BROWN, Roger Michael
    Staceys Street
    ME14 1ST Maidstone
    2 County Gate
    Kent
    Director
    Staceys Street
    ME14 1ST Maidstone
    2 County Gate
    Kent
    EnglandBritish134140540001
    BRUCE, David James
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    England
    Director
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    England
    United KingdomBritish171398800001
    CHARD, Michael Francis
    23 Knightsbridge Court
    CH1 1QG Chester
    Director
    23 Knightsbridge Court
    CH1 1QG Chester
    UkBritish45725420009
    CLARK, Samuel Thomas Budgen
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    England
    Director
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    England
    EnglandBritish149939610001
    EGAN, Scott
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    England
    Director
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    England
    EnglandBritish170703910001
    HAGGETT, Linda
    Graig Y Mynydd
    CF39 8FD Thomastown
    51
    Tonyrefail
    Director
    Graig Y Mynydd
    CF39 8FD Thomastown
    51
    Tonyrefail
    United KingdomWelsh137893590001
    HODGES, Mark Steven
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    England
    Director
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    England
    United KingdomBritish58444370003
    JOHNSON, Timothy David
    The Green
    Westerham
    TN16 1AS Kent
    Nursery Cottage 3a
    Director
    The Green
    Westerham
    TN16 1AS Kent
    Nursery Cottage 3a
    EnglandBritish129538180001
    LYONS, Alastair David
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    Director
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    EnglandBritish193700560001
    MUGGE, Mark Stephen
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    Director
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    EnglandBritish162920630005
    PARK, Bryan
    Gate House
    Eclipse Park, Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    United Kingdom
    Director
    Gate House
    Eclipse Park, Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    United Kingdom
    EnglandBritish113694470002
    POWELL, Kenneth John
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    England
    Director
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    England
    WalesBritish27317930001
    RAGAN, Edwin Robert
    109 Rowan Gardens
    CF38 2TH Llantwit Fardre
    Mid Glamorgan
    Director
    109 Rowan Gardens
    CF38 2TH Llantwit Fardre
    Mid Glamorgan
    British61072270005
    RAGAN, Kay Elaine
    109 Rowan Gardens
    CF38 2TH Llantwit Fardre
    Mid Glamorgan
    Director
    109 Rowan Gardens
    CF38 2TH Llantwit Fardre
    Mid Glamorgan
    British86274390002
    RAGAN, Paul Robert
    Tregyrnog Farmhouse
    St. Brides-Super-Ely
    CF5 6EZ Cardiff
    Vale Of Glamorgan
    Director
    Tregyrnog Farmhouse
    St. Brides-Super-Ely
    CF5 6EZ Cardiff
    Vale Of Glamorgan
    United KingdomBritish60263070005
    RAGAN, Sharon Marie
    Old Tregyrnog Farmhouse
    St Brides Super Ely
    CF5 6EZ Cardiff
    Director
    Old Tregyrnog Farmhouse
    St Brides Super Ely
    CF5 6EZ Cardiff
    British67745500003
    REA, Michael Peter
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    England
    Director
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    England
    EnglandBritish147194830001
    REES, Paul
    Plot 1 Springfield Gardens
    Hirwaun
    CF44 9PA Aberdare
    Mid Glamorgan
    Director
    Plot 1 Springfield Gardens
    Hirwaun
    CF44 9PA Aberdare
    Mid Glamorgan
    British72333970002
    RIDEWOOD, Gary Spencer
    Leigh Cottage
    Mount Road
    CF64 4DG Dinas Powys
    South Glamorgan
    Director
    Leigh Cottage
    Mount Road
    CF64 4DG Dinas Powys
    South Glamorgan
    WalesBritish112745560001
    RILEY, Dylan James
    14 Three Cliffs Drive
    Southgate
    SA3 2BN Swansea
    Director
    14 Three Cliffs Drive
    Southgate
    SA3 2BN Swansea
    West GlamorganBritish117675190001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de PROTECTAGROUP LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Protectagroup Holdings Limited
    Eclipse Park
    Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Eclipse Park
    Kent
    England
    06 abr 2016
    Eclipse Park
    Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Eclipse Park
    Kent
    England
    No
    Forma jurídicaCompany Limited By Shares
    País de registroEngland
    Autoridad legalCompanies Act 2006
    Lugar de registroCompanies House Cardiff
    Número de registro05081105
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.

    ¿Tiene PROTECTAGROUP LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    A registered charge
    Creado el 02 abr 2015
    Entregado el 22 abr 2015
    Satisfecho en su totalidad
    Breve descripción
    By way of first legal mortgage all legal interest in trademark registration/application number 24770055 as listed in schedule 5 (intellectual property) of the instrument.
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • The Bank of New York Mellon, London Branch
    Transacciones
    • 22 abr 2015Registro de una carga (MR01)
    • 29 ago 2018Satisfacción de una carga (MR04)
    A registered charge
    Creado el 10 may 2013
    Entregado el 23 may 2013
    Satisfecho en su totalidad
    Breve descripción
    Pursuant to clause 3.1(b)(vii) of the charge, the company charged by way of first fixed charge all its intellectual property, including the following:. Trademark registration/application number 2477005.. pursuant to the charge, the company charged by way of first legal mortgage all its real property (although no further details are specified in the charge for real property owned by this company). For further detail, see clause 3.1(a) of the charge.. Notification of addition to or amendment of charge.
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 23 may 2013Registro de una carga (MR01)
    • 29 abr 2015Satisfacción de una carga (MR04)
    Security accession deed
    Creado el 27 jun 2012
    Entregado el 07 jul 2012
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from any charging company or any other debtor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC as Security Trustee for Itself and the Other Secured Parties (The Security Agent)
    Transacciones
    • 07 jul 2012Registro de un cargo (MG01)
    • 23 sept 2015Satisfacción de una carga (MR04)
    Debenture
    Creado el 27 jun 2012
    Entregado el 06 jul 2012
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from any charging company or any other debtor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC as Security Agent and Trustee for Itself and the Other Secured Parties (The "Security Agent")
    Transacciones
    • 06 jul 2012Registro de un cargo (MG01)
    • 23 jul 2015Satisfacción de una carga (MR04)
    Debenture
    Creado el 14 sept 2010
    Entregado el 18 sept 2010
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the chargors to any secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Bank of Scotland PLC (The Security Trustee)
    Transacciones
    • 18 sept 2010Registro de un cargo (MG01)
    • 28 sept 2011Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad gravada ha sido liberada (MG04)
    • 06 jul 2012Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Deed of accession
    Creado el 04 jun 2008
    Entregado el 17 jun 2008
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Bank of Scotland PLC (The Security Trustee)
    Transacciones
    • 17 jun 2008Registro de un cargo (395)
    • 28 sept 2011Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad gravada ha sido liberada (MG04)
    • 06 jul 2012Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Guarantee & debenture
    Creado el 26 sept 2006
    Entregado el 04 oct 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 04 oct 2006Registro de un cargo (395)
    • 01 nov 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 29 oct 2004
    Entregado el 14 abr 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    The f/h property k/a 14 commercial street, pontnewydd, cymbran, gwent.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 14 abr 2005Registro de un cargo (395)
    • 26 mar 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creado el 06 oct 2004
    Entregado el 21 oct 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 21 oct 2004Registro de un cargo (395)
    • 01 nov 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 02 abr 2003
    Entregado el 17 abr 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    The property k/a 38 hannah street porth rhondda cynon taff.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 17 abr 2003Registro de un cargo (395)
    • 26 mar 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 01 abr 2003
    Entregado el 17 abr 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    The property k/a 76 bute street treorchy rhondda cynon taff.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 17 abr 2003Registro de un cargo (395)
    • 26 mar 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 01 ene 2003
    Entregado el 08 ene 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 08 ene 2003Registro de un cargo (395)
    • 01 nov 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creado el 14 dic 2002
    Entregado el 03 ene 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 03 ene 2003Registro de un cargo (395)
    • 01 nov 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Loan facility agreement
    Creado el 03 ago 2001
    Entregado el 11 ago 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    Up to £150,000 due from the company to the chargee
    Breve descripción
    All debts arising from and the goodwill of the business of after the event litigation insurance carried on by the company all book debts computer software intellectual property assets and rights. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Finsure Premium Finance Limited
    Transacciones
    • 11 ago 2001Registro de un cargo (395)
    • 19 mar 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    • 27 mar 2008
    • 05 abr 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    ¿Tiene PROTECTAGROUP LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    15 feb 2019Inicio de la liquidación
    27 jun 2020Fecha de disolución
    Liquidación voluntaria de socios
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Mark Jeremy Orton
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Profesional
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Nicholas James Timpson
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Profesional
    15 Canada Square
    E14 5GL London

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0