RIVENDELL GARDEN CENTRE LIMITED

RIVENDELL GARDEN CENTRE LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaRIVENDELL GARDEN CENTRE LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 03604717
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de RIVENDELL GARDEN CENTRE LIMITED?

    • Otra venta al por menor en establecimientos no especializados (47190) / Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas

    ¿Dónde se encuentra RIVENDELL GARDEN CENTRE LIMITED?

    Dirección de la sede social
    The Nursery
    Cumberland Street
    IP12 4AF Woodbridge
    Suffolk
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de RIVENDELL GARDEN CENTRE LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    CUBEBAG LIMITED27 jul 199827 jul 1998

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de RIVENDELL GARDEN CENTRE LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta28 feb 2015

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para RIVENDELL GARDEN CENTRE LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Nombramiento de Mr Mark Haddock como director el 17 feb 2016

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Ian William Furniss como director el 17 feb 2016

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Ian William Furniss como secretario el 17 feb 2016

    1 páginasTM02

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 28 feb 2015

    7 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 09 nov 2015 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital09 nov 2015

    Estado de capital el 09 nov 2015

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Cese del nombramiento de Andrew Michael Lawrence Staff como director el 31 mar 2015

    1 páginasTM01

    Déclaration annuelle établie au 09 nov 2014 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital04 dic 2014

    Estado de capital el 04 dic 2014

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 28 feb 2014

    7 páginasAA

    Nombramiento de Mr Ian William Furniss como director

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Andrew Staff como secretario

    1 páginasTM02

    Nombramiento de Mr Ian William Furniss como secretario

    2 páginasAP03

    Déclaration annuelle établie au 09 nov 2013 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital05 dic 2013

    Estado de capital el 05 dic 2013

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 28 feb 2013

    7 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 09 nov 2012 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 29 feb 2012

    7 páginasAA

    Cese del nombramiento de Andrew King como director

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Michael Cole como director

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Roger Notcutt como director

    1 páginasTM01

    Déclaration annuelle établie au 09 nov 2011 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 28 feb 2011

    7 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 09 nov 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01

    Resoluciones

    Resolutions
    6 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resoluciones

    Re property transfer 01/07/2010
    RES13

    ¿Quiénes son los directivos de RIVENDELL GARDEN CENTRE LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    HADDOCK, Mark William
    Cumberland Street
    IP12 4AF Woodbridge
    The Nursery
    Suffolk
    Director
    Cumberland Street
    IP12 4AF Woodbridge
    The Nursery
    Suffolk
    EnglandEnglish205242470001
    ANDREW, Stephen Robert
    Chapel Farmhouse Chapel Lane
    Mouldsworth
    CH3 8BF Chester
    Cheshire
    Secretario
    Chapel Farmhouse Chapel Lane
    Mouldsworth
    CH3 8BF Chester
    Cheshire
    British49087860002
    COOKSON, Michael Dean
    Bankside Farm
    Winsford Road
    CW7 4DL Wettenhall Winsford
    Cheshire
    Secretario
    Bankside Farm
    Winsford Road
    CW7 4DL Wettenhall Winsford
    Cheshire
    British2233500002
    FURNISS, Ian William
    Cumberland Street
    IP12 4AF Woodbridge
    The Nursery
    Suffolk
    Secretario
    Cumberland Street
    IP12 4AF Woodbridge
    The Nursery
    Suffolk
    188397320001
    STAFF, Andrew Michael Lawrence
    Cumberland Street
    IP12 4AF Woodbridge
    The Nursery
    Suffolk
    Secretario
    Cumberland Street
    IP12 4AF Woodbridge
    The Nursery
    Suffolk
    British134035650001
    WALKER, Linda Margaret
    21 Cornelia Crescent
    Belvidere
    SY2 5NA Shrewsbury
    Shropshire
    Secretario
    21 Cornelia Crescent
    Belvidere
    SY2 5NA Shrewsbury
    Shropshire
    British48968430002
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secretario designado corporativo
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    ANDREW, Stephen Robert
    Chapel Farmhouse Chapel Lane
    Mouldsworth
    CH3 8BF Chester
    Cheshire
    Director
    Chapel Farmhouse Chapel Lane
    Mouldsworth
    CH3 8BF Chester
    Cheshire
    EnglandBritish49087860002
    BARNES, Ian Malcolm
    Holly House The Fold
    Dorrington
    SY5 7JD Shrewsbury
    Shropshire
    Director
    Holly House The Fold
    Dorrington
    SY5 7JD Shrewsbury
    Shropshire
    United KingdomBritish37745750001
    COLE, Michael David
    Cumberland Street
    IP12 4AF Woodbridge
    The Nursery
    Suffolk
    Director
    Cumberland Street
    IP12 4AF Woodbridge
    The Nursery
    Suffolk
    United KingdomBritish146969370001
    FAUN, Stephen
    2 Worleston Close
    CW10 0RG Middlewich
    Cheshire
    Director
    2 Worleston Close
    CW10 0RG Middlewich
    Cheshire
    British81650270001
    FULKER, Alan Ernest
    White Lodge 17 Overhill Road
    SK9 2BE Wilmslow
    Cheshire
    Director
    White Lodge 17 Overhill Road
    SK9 2BE Wilmslow
    Cheshire
    British2233530001
    FURNISS, Ian William
    Cumberland Street
    IP12 4AF Woodbridge
    The Nursery
    Suffolk
    Director
    Cumberland Street
    IP12 4AF Woodbridge
    The Nursery
    Suffolk
    EnglandBritish117943650001
    GRUNDY, Paul
    74 Broadwalk
    SK9 5PN Wilmslow
    Cheshire
    Director
    74 Broadwalk
    SK9 5PN Wilmslow
    Cheshire
    EnglandBritish17333220001
    KING, Andrew James
    Cumberland Street
    IP12 4AF Woodbridge
    The Nursery
    Suffolk
    Director
    Cumberland Street
    IP12 4AF Woodbridge
    The Nursery
    Suffolk
    EnglandBritish217979240001
    NOTCUTT, Roger William
    Cumberland Street
    IP12 4AF Woodbridge
    The Nursery
    Suffolk
    Director
    Cumberland Street
    IP12 4AF Woodbridge
    The Nursery
    Suffolk
    EnglandBritish134038090001
    SCOTT, Graham Robert
    216 Main Road
    Goostrey
    CW4 8PE Crewe
    Cheshire
    Director
    216 Main Road
    Goostrey
    CW4 8PE Crewe
    Cheshire
    British44672550004
    SPURLING, Anthony Christopher
    36 Mossgrove Road
    Timperley
    WA15 6LF Altrincham
    Cheshire
    Director
    36 Mossgrove Road
    Timperley
    WA15 6LF Altrincham
    Cheshire
    EnglandBritish106994510001
    STAFF, Andrew Michael Lawrence
    Cumberland Street
    IP12 4AF Woodbridge
    The Nursery
    Suffolk
    Director
    Cumberland Street
    IP12 4AF Woodbridge
    The Nursery
    Suffolk
    EnglandBritish134035650001
    WHITING, Richard Antony
    Chestnut Farm
    Cross Lane, Kermincham
    CW12 2LJ Congleton
    Cheshire
    Director
    Chestnut Farm
    Cross Lane, Kermincham
    CW12 2LJ Congleton
    Cheshire
    EnglandBritish327792630001
    WHITING, Richard Antony
    Chestnut Farm
    Cross Lane, Kermincham
    CW12 2LJ Congleton
    Cheshire
    Director
    Chestnut Farm
    Cross Lane, Kermincham
    CW12 2LJ Congleton
    Cheshire
    EnglandBritish327792630001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Director designado corporativo
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    ¿Tiene RIVENDELL GARDEN CENTRE LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Guarantee & debenture
    Creado el 02 oct 2008
    Entregado el 09 oct 2008
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 09 oct 2008Registro de un cargo (395)
    Mortgage debenture
    Creado el 30 mar 2000
    Entregado el 10 abr 2000
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 10 abr 2000Registro de un cargo (395)
    • 01 nov 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0