GATHER & GATHER LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | GATHER & GATHER LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Activa |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 03610591 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de GATHER & GATHER LIMITED?
- Actividades de catering para eventos (56210) / Actividades de alojamiento y de servicios de comida
¿Dónde se encuentra GATHER & GATHER LIMITED?
| Dirección de la sede social | Parklands Court 24 Parklands Birmingham Great Park B45 9PZ Rubery West Midlands United Kingdom |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de GATHER & GATHER LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| MITIE CATERING SERVICES LIMITED | 27 mar 2002 | 27 mar 2002 |
| MITIE CATERING LIMITED | 02 oct 1998 | 02 oct 1998 |
| ADMINFORMAT LIMITED | 05 ago 1998 | 05 ago 1998 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de GATHER & GATHER LIMITED?
| Vencido | No |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 30 jun 2025 |
| Próximas cuentas vencen el | 30 jun 2026 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2023 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para GATHER & GATHER LIMITED?
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 30 sept 2026 |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación vence | 14 oct 2026 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 30 sept 2025 |
| Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para GATHER & GATHER LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Cese del nombramiento de Allister Richards como director el 31 dic 2025 | 1 páginas | TM01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 30 sept 2025 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Domicilio social registrado cambiado de 550 Second Floor Thames Valley Park Reading RG6 1PT England a Parklands Court 24 Parklands Birmingham Great Park Rubery West Midlands B45 9PZ el 30 may 2025 | 1 páginas | AD01 | ||
Exercice comptable en cours prolongé du 30 sept 2024 au 30 jun 2025 | 1 páginas | AA01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 30 sept 2024 con actualizaciones | 6 páginas | CS01 | ||
Cuentas de subsidiaria exentas de auditoría preparadas hasta el 31 dic 2023 | 36 páginas | AA | ||
legacy | 93 páginas | PARENT_ACC | ||
legacy | 1 páginas | AGREEMENT2 | ||
legacy | 3 páginas | GUARANTEE2 | ||
Exercice comptable en cours raccourci du 31 dic 2024 au 30 sept 2024 | 1 páginas | AA01 | ||
Nombramiento de Compass Secretaries Limited como secretario el 30 abr 2024 | 2 páginas | AP04 | ||
Cese del nombramiento de Adam Seymour como secretario el 30 abr 2024 | 1 páginas | TM02 | ||
Declaración de confirmación presentada el 30 sept 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas de subsidiaria exentas de auditoría preparadas hasta el 31 dic 2022 | 37 páginas | AA | ||
legacy | 83 páginas | PARENT_ACC | ||
legacy | 1 páginas | AGREEMENT2 | ||
legacy | 3 páginas | GUARANTEE2 | ||
Declaración de confirmación presentada el 30 sept 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas de subsidiaria exentas de auditoría preparadas hasta el 31 dic 2021 | 36 páginas | AA | ||
legacy | 83 páginas | PARENT_ACC | ||
legacy | 3 páginas | GUARANTEE2 | ||
legacy | 1 páginas | AGREEMENT2 | ||
Cuentas de subsidiaria exentas de auditoría preparadas hasta el 31 dic 2020 | 40 páginas | AA | ||
legacy | 3 páginas | GUARANTEE2 | ||
legacy | 87 páginas | PARENT_ACC | ||
¿Quiénes son los directivos de GATHER & GATHER LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPASS SECRETARIES LIMITED | Secretario corporativo | Guildford Street KT16 9BQ Chertsey Compass House England |
| 154268260001 | ||||||||||
| THOMAS, Nicholas Edward Heale | Director | 24 Parklands Birmingham Great Park B45 9PZ Rubery Parklands Court West Midlands United Kingdom | England | British | 245208170001 | |||||||||
| TONER, William James | Director | 24 Parklands Birmingham Great Park B45 9PZ Rubery Parklands Court West Midlands United Kingdom | Scotland | British | 141667140001 | |||||||||
| ROSS, Corina Katherine | Secretario | Ainslie's Cottage 30b Belvedere, Lansdown BA1 5HR Bath Avon | British | 69836440002 | ||||||||||
| SEYMOUR, Adam | Secretario | Thames Valley Park RG6 1PT Reading 550 Second Floor England | 268615960001 | |||||||||||
| THOMAS, Marshall Owen | Secretario | Rushmoor Clevedon Lane BS20 7RH Clapton In Gordano Bristol | British | 90914410001 | ||||||||||
| THOMAS, Nicholas Edward Heale | Secretario | Thames Valley Park RG6 1PT Reading 550 Second Floor England | 262217760001 | |||||||||||
| WATERS, Anthony Floyd | Secretario | The Stable Block Barley Wood BS40 5SA Wrington Bristol | British | 940440002 | ||||||||||
| MITIE COMPANY SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Secretario corporativo | The Shard 32 London Bridge Street SE1 9SG London Level 12 England England | 114537130001 | |||||||||||
| SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Secretario designado corporativo | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||||||
| ALLAN, Richard Friend | Director | Monarch Court, The Brooms Emersons Green BS16 7FH Bristol 8 United Kingdom | United Kingdom | British | 183409640001 | |||||||||
| BAXTER, Suzanne Claire | Director | Harlequin Office Park, Fieldfare Emersons Green BS16 7FN Bristol 1 England England | United Kingdom | British | 113058450002 | |||||||||
| BAXTER, Suzanne Claire | Director | Monarch Court, The Brooms Emersons Green BS16 7FH Bristol 8 United Kingdom | United Kingdom | British | 113058450002 | |||||||||
| BLUMBERGER, Richard John | Director | The Shard 32 London Bridge Street SE1 9SG London Level 12 England England | England | British | 137120140004 | |||||||||
| CATTELL, Robert Ian | Director | Harlequin Office Park, Fieldfare Emersons Green BS16 7FN Bristol 1 England England | United Kingdom | British | 167414780001 | |||||||||
| DIAMOND, Ian | Director | 2 The Lodge Isis Lakes Spine Road South Cerney GL7 5TL Cirencester Gloucestershire | British | 78749990001 | ||||||||||
| DICKINSON, Peter John Goddard | Director | Thames Valley Park RG6 1PT Reading 550 Second Floor England | England | British | 229653270002 | |||||||||
| FREEMAN, Martyn Alexander | Director | Harlequin Office Park, Fieldfare Emersons Green BS16 7FN Bristol 1 England England | England | British | 87874590001 | |||||||||
| GOODMAN, Neville Roger | Director | Monarch Court, The Brooms Emersons Green BS16 7FH Bristol 8 United Kingdom | England | British | 40455280001 | |||||||||
| HAY, James Robert Colquhoun | Director | Monarch Court, The Brooms Emersons Green BS16 7FH Bristol 8 United Kingdom | United Kingdom | British | 152073650001 | |||||||||
| IDLE, Matthew | Director | Thames Valley Park RG6 1PT Reading 550 Second Floor England | United Kingdom | British | 254600670001 | |||||||||
| MANNING, Elizabeth Jane | Director | 3 Rose Terrace 13a Gordon Road Clifton BS8 1AW Bristol Avon | United Kingdom | British | 64786930002 | |||||||||
| MCGREGOR-SMITH, Ruby | Director | Harlequin Office Park, Fieldfare Emersons Green BS16 7FN Bristol 1 England England | United Kingdom | British | 39857280005 | |||||||||
| MCGREGOR-SMITH, Ruby | Director | 8 Monarch Court The Brooms Emersons Green BS16 7FH Bristol | United Kingdom | British | 39857280003 | |||||||||
| RICHARDS, Allister | Director | 24 Parklands Birmingham Great Park B45 9PZ Rubery Parklands Court West Midlands United Kingdom | United Kingdom | British | 171850960001 | |||||||||
| SHERIDAN, John Spencer | Director | Monarch Court, The Brooms Emersons Green BS16 7FH Bristol 8 United Kingdom | United Kingdom | British | 111482200002 | |||||||||
| STEWART, Ian Reginald | Director | Lullingworth Stroud Road GL6 6UT Painswick Gloucestershire | England | British | 1517500002 | |||||||||
| TELLING, David Malcolm | Director | Meeting House Farm Long Lane Wrington BS40 5SP Bristol | British | 15023940001 | ||||||||||
| WAIN, Keith Ernest | Director | 8 Smithy Close Holybourne GU34 4EE Alton Hampshire | British | 78475820001 | ||||||||||
| INSTANT COMPANIES LIMITED | Director designado corporativo | Mitchell Lane BS1 6BU Bristol 1 Avon | 900008290001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de GATHER & GATHER LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ch & Co Catering Group Limited | 06 sept 2019 | Thames Valley Park RG6 1PT Reading 550 Second Floor England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Mitie Investments Limited | 06 abr 2016 | The Shard 32 London Bridge Street SE1 9SG London Level 12 England England | Sí | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Mitie Group Plc | 06 abr 2016 | Duchess Road Rutherglen G73 1AU Glasgow 35 United Kingdom | Sí | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0