BROOMCO (1644) LIMITED

BROOMCO (1644) LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaBROOMCO (1644) LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 03612012
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de BROOMCO (1644) LIMITED?

    • Actividades de otras sociedades holding n.c.o.p. (64209) / Actividades financieras y de seguros

    ¿Dónde se encuentra BROOMCO (1644) LIMITED?

    Dirección de la sede social
    6 Jephson Tancred Close
    CV31 3RZ Leamington Spa
    Warwickshire
    England
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de BROOMCO (1644) LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2014

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para BROOMCO (1644) LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    legacy

    1 páginasSH20

    Estado de capital el 04 oct 2016

    • Capital: GBP 1
    5 páginasSH19

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resoluciones

    Amount by which cap reduced be credited to a distributable reserve 29/02/2016
    RES13
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06

    Declaración de confirmación presentada el 28 jul 2016 con actualizaciones

    6 páginasCS01

    Domicilio social registrado cambiado de 100 New Bridge Street London EC4V 6JA a 6 Jephson Tancred Close Leamington Spa Warwickshire CV31 3RZ el 18 may 2016

    1 páginasAD01

    Cese del nombramiento de Abogado Nominees Limited como secretario el 10 feb 2016

    1 páginasTM02

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2014

    8 páginasAA

    Nombramiento de Mr Martin Gerard Mullin como director el 08 jun 2015

    2 páginasAP01

    Déclaration annuelle établie au 28 jul 2015 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital29 jul 2015

    Estado de capital el 29 jul 2015

    • Capital: GBP 3,999,828
    SH01

    Cambio de datos del secretario Abogado Nominees Limited el 01 oct 2009

    1 páginasCH04

    legacy

    páginasANNOTATION

    Cese del nombramiento de Simon David Whittaker como director el 27 mar 2015

    2 páginasTM01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2013

    10 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 28 jul 2014 avec liste complète des actionnaires

    14 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital13 ago 2014

    Estado de capital el 13 ago 2014

    • Capital: GBP 3,999,828
    SH01

    Cambio de datos del director Simon David Whittaker el 28 sept 2013

    3 páginasCH01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2012

    13 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 28 jul 2013 avec liste complète des actionnaires

    14 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital04 sept 2013

    Estado de capital el 04 sept 2013

    • Capital: GBP 3,999,828
    SH01

    Declaración de los objetos de la sociedad

    2 páginasCC04

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    incorporation

    Resolución del Memorándum de Asociación

    RES01
    capital

    Resolución de eliminación de derechos de suscripción preferente

    RES11
    capital

    Resolución de asignación de valores

    RES10

    Cese del nombramiento de Terrance Helz como secretario

    2 páginasTM02

    Cese del nombramiento de Terrance Helz como director

    2 páginasTM01

    ¿Quiénes son los directivos de BROOMCO (1644) LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    LEWIS, Paul Stephen
    Tancred Close
    Queensway
    CV31 3RZ Royal Leamington Spa
    Jephson Court
    Warwickshire
    Director
    Tancred Close
    Queensway
    CV31 3RZ Royal Leamington Spa
    Jephson Court
    Warwickshire
    EnglandBritish163019350001
    MULLIN, Martin Gerard
    Tancred Close
    CV31 3RZ Leamington Spa
    Jephson Court
    Warwickshire
    England
    Director
    Tancred Close
    CV31 3RZ Leamington Spa
    Jephson Court
    Warwickshire
    England
    EnglandBritish150271550001
    FORSTER, Robert
    Shady Beech
    Greenfield Lane Guiseley
    LS20 8HF Leeds
    West Yorkshire
    Secretario
    Shady Beech
    Greenfield Lane Guiseley
    LS20 8HF Leeds
    West Yorkshire
    British5336440001
    HELZ, Terrance Valentine
    11 China Rose Court
    The Woodlands
    Texas
    77381
    Usa
    Secretario
    11 China Rose Court
    The Woodlands
    Texas
    77381
    Usa
    American61652840001
    ABOGADO NOMINEES LIMITED
    100 New Bridge Street
    EC4V 6JA London
    Secretario designado corporativo
    100 New Bridge Street
    EC4V 6JA London
    Tipo de identificaciónEEE
    Número de registro01688036
    900021150001
    DLA SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    Secretario designado corporativo
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    900016460001
    BEYEN, Kris Maria August
    Tancred Close
    Queensway
    CV31 3RZ Royal Leamington Spa
    Jephson Court
    Warwickshire
    Director
    Tancred Close
    Queensway
    CV31 3RZ Royal Leamington Spa
    Jephson Court
    Warwickshire
    United KingdomBelgian157565820001
    COLEMAN, Anthony William John
    Darley Green House
    17 Bakers Lane, Knowle
    B93 8PW Solihull
    West Midlands
    Director
    Darley Green House
    17 Bakers Lane, Knowle
    B93 8PW Solihull
    West Midlands
    British76251510001
    FORSTER, Robert
    Shady Beech
    Greenfield Lane Guiseley
    LS20 8HF Leeds
    West Yorkshire
    Director
    Shady Beech
    Greenfield Lane Guiseley
    LS20 8HF Leeds
    West Yorkshire
    British5336440001
    GAWRONSKI, Grant Lawrence
    19 Hunters Crossing Court
    The Woodlands
    Texas 77381
    Usa
    Director
    19 Hunters Crossing Court
    The Woodlands
    Texas 77381
    Usa
    UsaAmerican115387690001
    HAACK, Axel Gottfried Gunther
    9 Haute Corniche
    67210 Obernai
    France
    Director
    9 Haute Corniche
    67210 Obernai
    France
    German120071580001
    HELZ, Terrance Valentine
    11 China Rose Court
    The Woodlands
    Texas
    77381
    Usa
    Director
    11 China Rose Court
    The Woodlands
    Texas
    77381
    Usa
    United StatesAmerican61652840001
    MAXWELL, Peter Willis
    Banbury Road
    CV37 7HW Stratford Upon Avon
    41
    Warwickshire
    Director
    Banbury Road
    CV37 7HW Stratford Upon Avon
    41
    Warwickshire
    United KingdomBritish60789150004
    PRIESTLEY, Robert
    118 Huddersfield Road
    Brighouse
    HD6 3RH Huddersfield
    Director
    118 Huddersfield Road
    Brighouse
    HD6 3RH Huddersfield
    EnglandBritish109114780001
    SCRIMSHAW, James Eric
    Dove House
    Temple Grafton
    B49 6NT Alcester
    Warwickshire
    Director
    Dove House
    Temple Grafton
    B49 6NT Alcester
    Warwickshire
    British60793220002
    SMITH, Gavin David
    144 Pannal Ash Road
    HG2 9AJ Harrogate
    North Yorkshire
    Director
    144 Pannal Ash Road
    HG2 9AJ Harrogate
    North Yorkshire
    United KingdomBritish102540130001
    THOMASSON, Leigh
    Alderson Drive
    Tickhill
    DN11 9HR Doncaster
    2
    South Yorkshire
    Director
    Alderson Drive
    Tickhill
    DN11 9HR Doncaster
    2
    South Yorkshire
    EnglandUnited Kingdom41994080004
    VALE, Michael John
    16 West Hill
    Portishead
    BS20 9QL Bristol
    North Somerset
    Director
    16 West Hill
    Portishead
    BS20 9QL Bristol
    North Somerset
    British37773560001
    WAKEFIELD, James Christopher
    Allington Grange
    Allington
    SN14 6LW Chippenham
    Wiltshire
    Director
    Allington Grange
    Allington
    SN14 6LW Chippenham
    Wiltshire
    British76972530001
    WHITTAKER, Simon David
    Tancred Close
    Queensway
    CV31 3RZ Royal Leamington Spa
    Jephson Court
    Warwickshire
    United Kingdom
    Director
    Tancred Close
    Queensway
    CV31 3RZ Royal Leamington Spa
    Jephson Court
    Warwickshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish115390050002
    DLA NOMINEES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    Director designado corporativo
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    900016450001
    DLA SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    Director designado corporativo
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    900016460001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de BROOMCO (1644) LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Tancred Close
    CV31 3RZ Leamington Spa
    Jephson Court
    England
    28 jul 2016
    Tancred Close
    CV31 3RZ Leamington Spa
    Jephson Court
    England
    No
    Forma jurídicaLimited Liability Company
    País de registroEngland
    Autoridad legalCompanies Act 2006
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro827991
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.

    ¿Tiene BROOMCO (1644) LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Composite guarantee and mortgage debenture
    Creado el 17 oct 1998
    Entregado el 21 oct 1998
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or in connection with the finance documents as described in the debenture on any account whatsoever
    Breve descripción
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotlandfor Itself and in Its Capacity as Security Trustee for the Other Beneficiaries as Described in the Debenture
    Transacciones
    • 21 oct 1998Registro de un cargo (395)
    • 25 nov 1999Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0