ADVANCED COMPOSITES GROUP HOLDINGS LIMITED

ADVANCED COMPOSITES GROUP HOLDINGS LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaADVANCED COMPOSITES GROUP HOLDINGS LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 03621275
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de ADVANCED COMPOSITES GROUP HOLDINGS LIMITED?

    • Otras actividades de apoyo a los negocios n.c.p. (82990) / Actividades administrativas y de apoyo

    ¿Dónde se encuentra ADVANCED COMPOSITES GROUP HOLDINGS LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Composites House
    Sinclair Close
    DE75 7SP Heanor
    Derbyshire
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de ADVANCED COMPOSITES GROUP HOLDINGS LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    PINCO 1110 LIMITED25 ago 199825 ago 1998

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de ADVANCED COMPOSITES GROUP HOLDINGS LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2018

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para ADVANCED COMPOSITES GROUP HOLDINGS LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2018

    17 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 25 ago 2019 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    legacy

    1 páginasSH20

    Estado de capital el 14 dic 2018

    • Capital: GBP 1
    5 páginasSH19

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resoluciones

    Cancellation of share premium account 13/12/2018
    RES13
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06

    Resoluciones

    Resolutions
    17 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de variación de los derechos o del nombre de las acciones

    RES12
    incorporation

    Resolución de adopción de los Artículos de Asociación

    RES01

    Cambio de nombre o denominación de la clase de acciones

    2 páginasSH08

    Declaración de confirmación presentada el 25 ago 2018 con actualizaciones

    5 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2017

    3 páginasAA

    Cambio de datos del secretario Alison Murphy el 01 nov 2017

    1 páginasCH03

    Declaración de confirmación presentada el 25 ago 2017 con actualizaciones

    5 páginasCS01

    Cese del nombramiento de Alison Murphy como director el 01 jul 2017

    1 páginasTM01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2016

    3 páginasAA

    Renuncia del auditor

    1 páginasAUD

    Nombramiento de Mrs Alison Murphy como director el 01 nov 2016

    2 páginasAP01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2015

    3 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 25 ago 2016 con actualizaciones

    6 páginasCS01

    Cese del nombramiento de Roy Douglas Smith como director el 12 ago 2016

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Daniel George Darazsdi como director el 12 ago 2016

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Alison Murphy como secretario el 12 ago 2016

    2 páginasAP03

    Cese del nombramiento de Roy Douglas Smith como secretario el 12 ago 2016

    1 páginasTM02

    ¿Quiénes son los directivos de ADVANCED COMPOSITES GROUP HOLDINGS LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    MURPHY, Alison
    Clarendon Road
    WD17 1JJ Watford
    34
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Secretario
    Clarendon Road
    WD17 1JJ Watford
    34
    Hertfordshire
    United Kingdom
    214335080001
    CLEARS, David Shaun
    Sinclair Close
    DE75 7SP Heanor
    Composites House
    Derbyshire
    Director
    Sinclair Close
    DE75 7SP Heanor
    Composites House
    Derbyshire
    United KingdomBritish214322760001
    GLENNON, Stephen Matthew
    Sinclair Close
    DE75 7SP Heanor
    Composites House
    Derbyshire
    England
    Director
    Sinclair Close
    DE75 7SP Heanor
    Composites House
    Derbyshire
    England
    EnglandBritish88291900001
    BOWERS, Steven John
    Thornbury Cottage
    Chalkhill Coleshill
    HP7 0LY Amersham
    Buckinghamshire
    Secretario
    Thornbury Cottage
    Chalkhill Coleshill
    HP7 0LY Amersham
    Buckinghamshire
    British61929330004
    MALITSKIE, Mark
    52 High Street
    Broughton
    NN14 1NQ Kettering
    Northamptonshire
    Secretario
    52 High Street
    Broughton
    NN14 1NQ Kettering
    Northamptonshire
    British68667640001
    MOORE, Alan Brian
    Rowan Cottage Hackney Lane
    Barlow
    S18 7TD Sheffield
    Secretario
    Rowan Cottage Hackney Lane
    Barlow
    S18 7TD Sheffield
    British14081040001
    MOORE, Alan Brian
    Rowan Cottage Hackney Lane
    Barlow
    S18 7TD Sheffield
    Secretario
    Rowan Cottage Hackney Lane
    Barlow
    S18 7TD Sheffield
    British14081040001
    SMITH, Roy Douglas
    Sinclair Close
    DE75 7SP Heanor
    Composites House
    Derbyshire
    England
    Secretario
    Sinclair Close
    DE75 7SP Heanor
    Composites House
    Derbyshire
    England
    170871450001
    TRESIDDER, Hereward Tolmie
    33 Belle Vue Road
    DE6 1AT Ashbourne
    Derbyshire
    Secretario
    33 Belle Vue Road
    DE6 1AT Ashbourne
    Derbyshire
    British39200370004
    PINSENT MASONS SECRETARIAL LIMITED
    1 Park Row
    LS1 5AB Leeds
    West Yorkshire
    Secretario corporativo
    1 Park Row
    LS1 5AB Leeds
    West Yorkshire
    76579530001
    BEAUMONT, Richard John Kirby
    10 Milverton Terrace
    CV32 5BA Leamington Spa
    Warwickshire
    Director
    10 Milverton Terrace
    CV32 5BA Leamington Spa
    Warwickshire
    British98953190001
    BLATHERWICK, Nigel Ashley
    7 Queen Marys Close
    NG12 2NR Nottingham
    Nottinghamshire
    Director
    7 Queen Marys Close
    NG12 2NR Nottingham
    Nottinghamshire
    United KingdomBritish118979720001
    BOWERS, Steven John
    Warwick New Road
    CV32 5JG Leamington Spa
    Concorde House
    Warwickshire
    Director
    Warwick New Road
    CV32 5JG Leamington Spa
    Concorde House
    Warwickshire
    United KingdomBritish176189250001
    DARAZSDI, Daniel George
    Sinclair Close
    DE75 7SP Heanor
    Composites House
    Derbyshire
    Director
    Sinclair Close
    DE75 7SP Heanor
    Composites House
    Derbyshire
    UsaAmerican195049720001
    DEVAULT, Jon
    18415 Azofar Ct San Diego Ca
    San Diego
    FOREIGN California
    92128
    United States Of America
    Director
    18415 Azofar Ct San Diego Ca
    San Diego
    FOREIGN California
    92128
    United States Of America
    American63857020001
    DRILLOCK, David M
    Sinclair Close
    DE75 7SP Heanor
    Composites House
    Derbyshire
    England
    Director
    Sinclair Close
    DE75 7SP Heanor
    Composites House
    Derbyshire
    England
    United StatesAmerican170878740001
    ENGLISH, Peter David
    76 Woodside
    Wimbledon
    SW19 7QL London
    Director
    76 Woodside
    Wimbledon
    SW19 7QL London
    British3355360001
    FORD, Richard Guy
    Water Stratford House
    Water Stratford
    MK18 5DS Buckingham
    Director
    Water Stratford House
    Water Stratford
    MK18 5DS Buckingham
    British1467170002
    GHAVAM SHAHIDI, Ebrahim
    2 St Georges Close
    Allestree
    DE22 1JH Derby
    Derbyshire
    Director
    2 St Georges Close
    Allestree
    DE22 1JH Derby
    Derbyshire
    United KingdomBritish117846410001
    MABBITT, Jonathan Peter
    Sunset
    Nether Lane
    DE56 4AP Hazelwood
    Derbyshire
    Director
    Sunset
    Nether Lane
    DE56 4AP Hazelwood
    Derbyshire
    EnglandBritish83707310002
    MALITSKIE, Mark
    52 High Street
    Broughton
    NN14 1NQ Kettering
    Northamptonshire
    Director
    52 High Street
    Broughton
    NN14 1NQ Kettering
    Northamptonshire
    EnglandBritish68667640001
    MOORE, Alan Brian
    Rowan Cottage Hackney Lane
    Barlow
    S18 7TD Sheffield
    Director
    Rowan Cottage Hackney Lane
    Barlow
    S18 7TD Sheffield
    British14081040001
    MOSS, Andrew Brian
    Warwick New Road
    CV32 5JG Leamington Spa
    Concorde House
    Warwickshire
    Director
    Warwick New Road
    CV32 5JG Leamington Spa
    Concorde House
    Warwickshire
    EnglandBritish161928410001
    MOSS, Andrew Brian
    Saddlebow Cottage
    Saddlebow Lane
    CV35 8PQ Claverdon
    Warwickshire
    Director
    Saddlebow Cottage
    Saddlebow Lane
    CV35 8PQ Claverdon
    Warwickshire
    EnglandBritish161928410001
    MURPHY, Alison
    Sinclair Close
    DE75 7SP Heanor
    Composites House
    Derbyshire
    Director
    Sinclair Close
    DE75 7SP Heanor
    Composites House
    Derbyshire
    United KingdomBritish111169560001
    POTTS, Hugh Adrian
    7921 S Hudson Avenue
    Tuisa
    Oklahoma
    74136
    Usa
    Director
    7921 S Hudson Avenue
    Tuisa
    Oklahoma
    74136
    Usa
    UsaBritish52210510003
    ROBERTSON, Douglas Grant
    Blackmore Grange
    Blackmore End
    WR8 0EE Hanley Swan
    Worcestershire
    Director
    Blackmore Grange
    Blackmore End
    WR8 0EE Hanley Swan
    Worcestershire
    EnglandBritish123487130001
    SLOMAN, Roger Mark
    13 Woodside
    Morley
    DE7 6DG Ilkeston
    Derbyshire
    Director
    13 Woodside
    Morley
    DE7 6DG Ilkeston
    Derbyshire
    British8257720002
    SMITH, Roy Douglas
    Sinclair Close
    DE75 7SP Heanor
    Composites House
    Derbyshire
    England
    Director
    Sinclair Close
    DE75 7SP Heanor
    Composites House
    Derbyshire
    England
    UsaUsa170877010001
    SNOWDON, Clive John
    New End Barn
    Spernall Lane Great Alne
    B49 6JD Alcester
    Warwickshire
    Director
    New End Barn
    Spernall Lane Great Alne
    B49 6JD Alcester
    Warwickshire
    United KingdomBritish32242700001
    STREET, Andrew John
    Fountain House 13 Main Street
    Middleton
    DE4 4LQ Matlock
    Derbyshire
    Director
    Fountain House 13 Main Street
    Middleton
    DE4 4LQ Matlock
    Derbyshire
    United KingdomBritish36056510008
    TRESIDDER, Hereward Tolmie
    33 Belle Vue Road
    DE6 1AT Ashbourne
    Derbyshire
    Director
    33 Belle Vue Road
    DE6 1AT Ashbourne
    Derbyshire
    EnglandBritish39200370004
    WEIDNER, John Charles
    53505 129th East Avenue
    Tulsa
    Oklahoma 74134
    Usa
    Director
    53505 129th East Avenue
    Tulsa
    Oklahoma 74134
    Usa
    Usa74299320001
    PINSENT MASONS SECRETARIAL LIMITED
    1 Park Row
    LS1 5AB Leeds
    West Yorkshire
    Director corporativo
    1 Park Row
    LS1 5AB Leeds
    West Yorkshire
    76579530001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de ADVANCED COMPOSITES GROUP HOLDINGS LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Umeco Limited
    Sinclair Close
    DE75 7SP Heanor
    Composites House
    England
    06 abr 2016
    Sinclair Close
    DE75 7SP Heanor
    Composites House
    England
    No
    Forma jurídicaLimited Company
    Autoridad legalCompanies Act
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.

    ¿Tiene ADVANCED COMPOSITES GROUP HOLDINGS LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement
    Creado el 11 dic 2009
    Entregado el 30 dic 2009
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with the bank.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 30 dic 2009Registro de un cargo (MG01)
    • 19 abr 2012Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    A deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement 27TH october 1997,
    Creado el 23 nov 2006
    Entregado el 29 nov 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with the bank.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 29 nov 2006Registro de un cargo (395)
    • 19 abr 2012Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 27/10/1997
    Creado el 16 jul 2004
    Entregado el 22 jul 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Any sum standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 22 jul 2004Registro de un cargo (395)
    • 19 abr 2012Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Debenture
    Creado el 31 mar 1999
    Entregado el 15 abr 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever in relation to the debenture
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Derbyshire Enterprise Board (Investments) Limited
    Transacciones
    • 15 abr 1999Registro de un cargo (395)
    • 09 may 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 31 mar 1999
    Entregado el 15 abr 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever in relation to the debenture
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Derbyshire County Council
    Transacciones
    • 15 abr 1999Registro de un cargo (395)
    • 09 may 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creado el 31 mar 1999
    Entregado el 08 abr 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    .. a specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 08 abr 1999Registro de un cargo (395)
    • 22 feb 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0