ZERO WASTE HOLDINGS LIMITED

ZERO WASTE HOLDINGS LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaZERO WASTE HOLDINGS LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 03639624
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de ZERO WASTE HOLDINGS LIMITED?

    • (9002) /

    ¿Dónde se encuentra ZERO WASTE HOLDINGS LIMITED?

    Dirección de la sede social
    4 Rudgate Court
    Walton
    LS23 7BF Wetherby
    West Yorkshire
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de ZERO WASTE HOLDINGS LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    ZERO WASTE LIMITED08 oct 199808 oct 1998
    BROOMCO (1651) LIMITED28 sept 199828 sept 1998

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de ZERO WASTE HOLDINGS LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2009

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para ZERO WASTE HOLDINGS LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Nombramiento de A G Secretarial Limited como secretario el 01 sept 2011

    2 páginasAP04

    Estado de capital el 29 sept 2011

    • Capital: GBP 0.10
    4 páginasSH19

    Resoluciones

    Resolutions
    3 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06

    legacy

    1 páginasSH20

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Cese del nombramiento de Tmf Corporate Administration Services Limited como secretario

    1 páginasTM02

    Nombramiento de Tmf Corporate Administration Services Limited como secretario

    2 páginasAP04

    Cese del nombramiento de Mawlaw Secretaries Limited como secretario

    1 páginasTM02

    La dirección de inspección del registro se ha cambiado de 201 Bishopsgate London EC2M 3AF

    1 páginasAD02

    Déclaration annuelle établie au 28 sept 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01

    Cese del nombramiento de Peter Southby como director

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Richard Allen como director

    2 páginasAP01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2009

    7 páginasAA

    legacy

    3 páginasMG02

    legacy

    3 páginasMG02

    Cambio de datos del director Paul George Blackler el 01 oct 2009

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Paul George Blackler el 01 oct 2009

    2 páginasCH01

    La dirección de inspección del registro se ha cambiado

    2 páginasAD02

    legacy

    3 páginas363a

    Cuentas preparadas hasta el 31 dic 2008

    7 páginasAA

    legacy

    1 páginas353

    legacy

    1 páginas288c

    ¿Quiénes son los directivos de ZERO WASTE HOLDINGS LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    A G SECRETARIAL LIMITED
    Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    100
    United Kingdom
    Secretario corporativo
    Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    100
    United Kingdom
    Tipo de identificaciónEEE
    Número de registro2598128
    90084920001
    ALLEN, Richard David
    Acaster Lane
    YO23 2TD Bishopthorpe
    116
    York
    United Kingdom
    Director
    Acaster Lane
    YO23 2TD Bishopthorpe
    116
    York
    United Kingdom
    United KingdomBritishGroup Finance Director153807080001
    BLACKLER, Paul George
    28 Halfleet
    PE6 8DB Market Deeping
    Shepherds Cottage
    Lincolnshire
    United Kingdom
    Director
    28 Halfleet
    PE6 8DB Market Deeping
    Shepherds Cottage
    Lincolnshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director120687680006
    GOUGH, Kathleen Philippa
    The Boundary
    Parkfield Road
    WA16 8NP Knutsford
    Cheshire
    Secretario
    The Boundary
    Parkfield Road
    WA16 8NP Knutsford
    Cheshire
    BritishDeal Originator96739130001
    HOLDITCH, Catherine Elisabeth Claire
    15 Moorland Road
    M20 6BB Manchester
    Lancashire
    Secretario
    15 Moorland Road
    M20 6BB Manchester
    Lancashire
    BritishFinance Director63944610001
    MCGREGOR TOWERS, Kirsty
    4 Burnside Cottages
    Rookhope
    DL13 2DB Bishop Auckland
    County Durham
    Secretario
    4 Burnside Cottages
    Rookhope
    DL13 2DB Bishop Auckland
    County Durham
    BritishAccountant80868340001
    DLA SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    Secretario designado corporativo
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    900016460001
    MAWLAW SECRETARIES LIMITED
    Bishopsgate
    EC2M 3AF London
    201
    Secretario corporativo
    Bishopsgate
    EC2M 3AF London
    201
    39182980003
    TMF CORPORATE ADMINISTRATION SERVICES LIMITED
    1st Floor
    9 Cloak Lane
    EC4R 2RU London
    Pellipar House
    United Kingdom
    Secretario corporativo
    1st Floor
    9 Cloak Lane
    EC4R 2RU London
    Pellipar House
    United Kingdom
    Tipo de identificaciónEEE
    Número de registro06902863
    140723560001
    ANDERSON, Bruce Kirkpatrick
    3 The Chestnuts
    Easthampstead Road
    RG40 2EE Wokingham
    Berkshire
    Director
    3 The Chestnuts
    Easthampstead Road
    RG40 2EE Wokingham
    Berkshire
    United KingdomBritishAccountant42501410001
    DOWNEY, Gary Gerard
    Pheasants Walk
    YO61 2QS Helperby
    Yorkshire
    Director
    Pheasants Walk
    YO61 2QS Helperby
    Yorkshire
    BritishChief Financial Officer92121410001
    GOUGH, Kathleen Philippa
    The Boundary
    Parkfield Road
    WA16 8NP Knutsford
    Cheshire
    Director
    The Boundary
    Parkfield Road
    WA16 8NP Knutsford
    Cheshire
    EnglandBritishDirector96739130001
    HOATHER, Hugh Allen, Dr
    Oak House
    Hassalls Lane Bridge Trafford
    CH2 4GA Chester
    Cheshire
    Director
    Oak House
    Hassalls Lane Bridge Trafford
    CH2 4GA Chester
    Cheshire
    EnglandBritishCompany Director28079330002
    HOLDITCH, Catherine Elisabeth Claire
    15 Moorland Road
    M20 6BB Manchester
    Lancashire
    Director
    15 Moorland Road
    M20 6BB Manchester
    Lancashire
    EnglandBritishFinance Director63944610001
    HOUGH, Robert Eric
    Manor House
    10 Theobald Road
    WA14 3HG Bowdon
    Cheshire
    Director
    Manor House
    10 Theobald Road
    WA14 3HG Bowdon
    Cheshire
    EnglandBritishDirector38776360001
    HUNTINGTON, John Michael
    Skelton Hall
    Skelton Lane Thorner
    LS14 1AE Leeds
    West Yorkshire
    Director
    Skelton Hall
    Skelton Lane Thorner
    LS14 1AE Leeds
    West Yorkshire
    BritishChief Executive102172280001
    SOUTHBY, Peter John
    Brander Lodge
    Trip Lane Linton
    LS22 4HX Wetherby
    Director
    Brander Lodge
    Trip Lane Linton
    LS22 4HX Wetherby
    EnglandBritishGroup Finance Director116859780002
    TIPPER, Gary William
    33 The Avenue
    Sale
    M33 4PJ Manchester
    Lancashire
    Director
    33 The Avenue
    Sale
    M33 4PJ Manchester
    Lancashire
    United KingdomBritishDirector125160140001
    WARD, Brian Eric
    Newton House
    Newton
    NN14 1BW Kettering
    Northamptonshire
    Director
    Newton House
    Newton
    NN14 1BW Kettering
    Northamptonshire
    EnglandBritishCompany Director7938140001
    WATHEN, John
    14 Carlton Road
    CW9 5PR Northwich
    Cheshire
    Director
    14 Carlton Road
    CW9 5PR Northwich
    Cheshire
    EnglandBritishDirector7012810001
    WORLLEDGE, Peter John Franklin
    YO62 4LG Hovingham
    Pasture House
    North Yorkshire
    Director
    YO62 4LG Hovingham
    Pasture House
    North Yorkshire
    BritishChief Executive138715540001
    DLA NOMINEES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    Director designado corporativo
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    900016450001
    DLA SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    Director designado corporativo
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    900016460001

    ¿Tiene ZERO WASTE HOLDINGS LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Debenture
    Creado el 23 may 2006
    Entregado el 31 may 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 31 may 2006Registro de un cargo (395)
    • 23 dic 2009Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Trust deposit deed
    Creado el 24 sept 1999
    Entregado el 04 oct 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the indemnity or the facility letter or in respect of bonds
    Breve descripción
    All right title and interest in the trust account and the cash collateral. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Zurich Gsg Limited
    Transacciones
    • 04 oct 1999Registro de un cargo (395)
    • 10 dic 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 24 sept 1999
    Entregado el 04 oct 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the counter indemnity the trust deposit deed and any bond
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Zurich Gsg Limited
    Transacciones
    • 04 oct 1999Registro de un cargo (395)
    • 10 dic 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 03 mar 1999
    Entregado el 15 mar 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • 3I PLC,as Security Trustee for the Investors (As Defined)
    Transacciones
    • 15 mar 1999Registro de un cargo (395)
    • 23 feb 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 03 mar 1999
    Entregado el 11 mar 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 11 mar 1999Registro de un cargo (395)
    • 23 dic 2009Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0