ZERO WASTE HOLDINGS LIMITED
Visión general
Nombre de la empresa | ZERO WASTE HOLDINGS LIMITED |
---|---|
Estado de la empresa | Disuelta |
Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
Número de empresa | 03639624 |
Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
Fecha de constitución | |
Fecha de cese |
Resumen
Tiene PSCs súper seguros | No |
---|---|
Tiene gravámenes | Sí |
Tiene historial de insolvencia | No |
La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de ZERO WASTE HOLDINGS LIMITED?
- (9002) /
¿Dónde se encuentra ZERO WASTE HOLDINGS LIMITED?
Dirección de la sede social | 4 Rudgate Court Walton LS23 7BF Wetherby West Yorkshire |
---|---|
Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de ZERO WASTE HOLDINGS LIMITED?
Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
---|---|---|
ZERO WASTE LIMITED | 08 oct 1998 | 08 oct 1998 |
BROOMCO (1651) LIMITED | 28 sept 1998 | 28 sept 1998 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de ZERO WASTE HOLDINGS LIMITED?
Últimas cuentas | |
---|---|
Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2009 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para ZERO WASTE HOLDINGS LIMITED?
Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||
Nombramiento de A G Secretarial Limited como secretario el 01 sept 2011 | 2 páginas | AP04 | ||||||||||
Estado de capital el 29 sept 2011
| 4 páginas | SH19 | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 3 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 1 páginas | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | CAP-SS | ||||||||||
Cese del nombramiento de Tmf Corporate Administration Services Limited como secretario | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Nombramiento de Tmf Corporate Administration Services Limited como secretario | 2 páginas | AP04 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Mawlaw Secretaries Limited como secretario | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
La dirección de inspección del registro se ha cambiado de 201 Bishopsgate London EC2M 3AF | 1 páginas | AD02 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 28 sept 2010 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Peter Southby como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Richard Allen como director | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2009 | 7 páginas | AA | ||||||||||
legacy | 3 páginas | MG02 | ||||||||||
legacy | 3 páginas | MG02 | ||||||||||
Cambio de datos del director Paul George Blackler el 01 oct 2009 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Paul George Blackler el 01 oct 2009 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
La dirección de inspección del registro se ha cambiado | 2 páginas | AD02 | ||||||||||
legacy | 3 páginas | 363a | ||||||||||
Cuentas preparadas hasta el 31 dic 2008 | 7 páginas | AA | ||||||||||
legacy | 1 páginas | 353 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | 288c | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de ZERO WASTE HOLDINGS LIMITED?
Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A G SECRETARIAL LIMITED | Secretario corporativo | Barbirolli Square M2 3AB Manchester 100 United Kingdom |
| 90084920001 | ||||||||||
ALLEN, Richard David | Director | Acaster Lane YO23 2TD Bishopthorpe 116 York United Kingdom | United Kingdom | British | Group Finance Director | 153807080001 | ||||||||
BLACKLER, Paul George | Director | 28 Halfleet PE6 8DB Market Deeping Shepherds Cottage Lincolnshire United Kingdom | United Kingdom | British | Company Director | 120687680006 | ||||||||
GOUGH, Kathleen Philippa | Secretario | The Boundary Parkfield Road WA16 8NP Knutsford Cheshire | British | Deal Originator | 96739130001 | |||||||||
HOLDITCH, Catherine Elisabeth Claire | Secretario | 15 Moorland Road M20 6BB Manchester Lancashire | British | Finance Director | 63944610001 | |||||||||
MCGREGOR TOWERS, Kirsty | Secretario | 4 Burnside Cottages Rookhope DL13 2DB Bishop Auckland County Durham | British | Accountant | 80868340001 | |||||||||
DLA SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Secretario designado corporativo | Fountain Precinct Balm Green S1 1RZ Sheffield | 900016460001 | |||||||||||
MAWLAW SECRETARIES LIMITED | Secretario corporativo | Bishopsgate EC2M 3AF London 201 | 39182980003 | |||||||||||
TMF CORPORATE ADMINISTRATION SERVICES LIMITED | Secretario corporativo | 1st Floor 9 Cloak Lane EC4R 2RU London Pellipar House United Kingdom |
| 140723560001 | ||||||||||
ANDERSON, Bruce Kirkpatrick | Director | 3 The Chestnuts Easthampstead Road RG40 2EE Wokingham Berkshire | United Kingdom | British | Accountant | 42501410001 | ||||||||
DOWNEY, Gary Gerard | Director | Pheasants Walk YO61 2QS Helperby Yorkshire | British | Chief Financial Officer | 92121410001 | |||||||||
GOUGH, Kathleen Philippa | Director | The Boundary Parkfield Road WA16 8NP Knutsford Cheshire | England | British | Director | 96739130001 | ||||||||
HOATHER, Hugh Allen, Dr | Director | Oak House Hassalls Lane Bridge Trafford CH2 4GA Chester Cheshire | England | British | Company Director | 28079330002 | ||||||||
HOLDITCH, Catherine Elisabeth Claire | Director | 15 Moorland Road M20 6BB Manchester Lancashire | England | British | Finance Director | 63944610001 | ||||||||
HOUGH, Robert Eric | Director | Manor House 10 Theobald Road WA14 3HG Bowdon Cheshire | England | British | Director | 38776360001 | ||||||||
HUNTINGTON, John Michael | Director | Skelton Hall Skelton Lane Thorner LS14 1AE Leeds West Yorkshire | British | Chief Executive | 102172280001 | |||||||||
SOUTHBY, Peter John | Director | Brander Lodge Trip Lane Linton LS22 4HX Wetherby | England | British | Group Finance Director | 116859780002 | ||||||||
TIPPER, Gary William | Director | 33 The Avenue Sale M33 4PJ Manchester Lancashire | United Kingdom | British | Director | 125160140001 | ||||||||
WARD, Brian Eric | Director | Newton House Newton NN14 1BW Kettering Northamptonshire | England | British | Company Director | 7938140001 | ||||||||
WATHEN, John | Director | 14 Carlton Road CW9 5PR Northwich Cheshire | England | British | Director | 7012810001 | ||||||||
WORLLEDGE, Peter John Franklin | Director | YO62 4LG Hovingham Pasture House North Yorkshire | British | Chief Executive | 138715540001 | |||||||||
DLA NOMINEES LIMITED | Director designado corporativo | Fountain Precinct Balm Green S1 1RZ Sheffield | 900016450001 | |||||||||||
DLA SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Director designado corporativo | Fountain Precinct Balm Green S1 1RZ Sheffield | 900016460001 |
¿Tiene ZERO WASTE HOLDINGS LIMITED alguna carga?
Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
---|---|---|---|---|
Debenture | Creado el 23 may 2006 Entregado el 31 may 2006 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Trust deposit deed | Creado el 24 sept 1999 Entregado el 04 oct 1999 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee under the indemnity or the facility letter or in respect of bonds | |
Breve descripción All right title and interest in the trust account and the cash collateral. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Debenture | Creado el 24 sept 1999 Entregado el 04 oct 1999 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee under the counter indemnity the trust deposit deed and any bond | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Debenture | Creado el 03 mar 1999 Entregado el 15 mar 1999 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Debenture | Creado el 03 mar 1999 Entregado el 11 mar 1999 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0