QUOCUMQUE LIMITED
Visión general
Nombre de la empresa | QUOCUMQUE LIMITED |
---|---|
Estado de la empresa | Disuelta |
Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
Número de empresa | 03642319 |
Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
Fecha de constitución | |
Fecha de cese |
Resumen
Tiene PSCs súper seguros | No |
---|---|
Tiene gravámenes | Sí |
Tiene historial de insolvencia | No |
La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de QUOCUMQUE LIMITED?
- Desarrollo de proyectos de construcción (41100) / Construcción
¿Dónde se encuentra QUOCUMQUE LIMITED?
Dirección de la sede social | 180 Great Portland Street W1W 5QZ London United Kingdom |
---|---|
Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de QUOCUMQUE LIMITED?
Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
---|---|---|
SHELFCO (NO.1560) LIMITED | 01 oct 1998 | 01 oct 1998 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de QUOCUMQUE LIMITED?
Últimas cuentas | |
---|---|
Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2016 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para QUOCUMQUE LIMITED?
Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||
Modification des détails de Quintain Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 01 dic 2017 | 2 páginas | PSC05 | ||||||||||
Cambio de datos del secretario Frances Victoria Heazell el 01 dic 2017 | 1 páginas | CH03 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr. Angus Alexander Dodd el 01 dic 2017 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr. James Michael Edward Saunders el 01 dic 2017 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr. Michael Ben Jenkins el 01 dic 2017 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de 43-45 Portman Square London W1H 6LY a 180 Great Portland Street London W1W 5QZ el 03 dic 2017 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 01 oct 2017 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2016 | 15 páginas | AA | ||||||||||
Nombramiento de Mr Michael Ben Jenkins como director el 13 ene 2017 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr James Michael Edward Saunders como director el 13 ene 2017 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Simon Geoffrey Carter como director el 13 ene 2017 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2016 | 15 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 01 oct 2016 con actualizaciones | 6 páginas | CS01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Sandra Judith Odell como secretario el 05 oct 2016 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Nombramiento de Frances Victoria Heazell como secretario el 05 oct 2016 | 2 páginas | AP03 | ||||||||||
Exercice comptable en cours raccourci du 31 mar 2017 au 31 dic 2016 | 1 páginas | AA01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Angus Alexander Dodd como director el 27 jun 2016 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Maxwell David Shaw James como director el 27 jun 2016 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cancelación total de la carga 7 | 3 páginas | MR04 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Maxwell David Shaw James el 26 feb 2016 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2015 | 14 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 01 oct 2015 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
¿Quiénes son los directivos de QUOCUMQUE LIMITED?
Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEAZELL, Frances Victoria | Secretario | Great Portland Street W1W 5QZ London 180 United Kingdom | 215875170001 | |||||||
DODD, Angus Alexander | Director | Great Portland Street W1W 5QZ London 180 United Kingdom | England | British | Senior Managing Director | 201606390001 | ||||
JENKINS, Michael Ben | Director | Great Portland Street W1W 5QZ London 180 United Kingdom | United Kingdom | British | Company Director | 221017630001 | ||||
SAUNDERS, James Michael Edward | Director | Great Portland Street W1W 5QZ London 180 United Kingdom | England | British | Company Director | 192568400002 | ||||
DIXON, Susan Elizabeth | Secretario | Flat 1 29-31 Dingley Place EC1 8BR London | British | 90007990001 | ||||||
EASTWOOD, Charlotte Ind | Secretario | 16 Edna Street SW11 3DP London | British | Solicitor Company Secretary | 50099790003 | |||||
HUGHES, Paul | Secretario | Lark Rise 5 Greville Park Avenue KT21 2QS Ashtead Surrey | British | 23950030001 | ||||||
ODELL, Sandra Judith | Secretario | Portman Square W1H 6LY London 43-45 United Kingdom | 175341610001 | |||||||
WORTHINGTON, Rebecca Jane | Secretario | The Old Cottage 97 The High Street RG10 8DD Wargrave Berkshire | British | 130493170001 | ||||||
E P S SECRETARIES LIMITED | Secretario designado corporativo | 50 Stratton Street W1X 6NX London | 900004930001 | |||||||
CARTER, Simon Geoffrey | Director | Portman Square W1H 6LY London 43-45 United Kingdom | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 184444990001 | ||||
DUGDALE, Edward Stratford | Director | Tickwood Hall TF13 6NZ Much Wenlock Shropshire | England | British | Company Director | 35942980003 | ||||
DWYER, Tonianne | Director | 170 Bishops Road Fulham SW6 7JG London | United Kingdom | Australian | Property Fund Manager | 94124780001 | ||||
ELLIS, Nigel George | Director | Willmead Farm Bovey Tracey TQ13 9NP Newton Abbot Devon | British | Chartered Accountant | 14185110002 | |||||
GAVAGHAN, David Nicholas | Director | 16 Grosvenor Street London W1K 4QF | United Kingdom | British | Fund Manager | 151855940001 | ||||
GREENSLADE, Daniel Mark | Director | Portman Square W1H 6LY London 43-45 United Kingdom | England | British | Chartered Accountant | 196504990001 | ||||
HAMILTON STUBBER, James Robert | Director | 1 The Regency Hide Place SW1P 4HD London | United Kingdom | British | Director | 84913850002 | ||||
JAMES, Maxwell David Shaw | Director | Portman Square W1H 6LY London 43-45 United Kingdom | England | British | Company Director | 164108510003 | ||||
RILEY, Michael Edward | Director | Tylers Barn Tylers Green Broad Street RH17 5DX Cuckfield West Sussex | British | Chartered Surveyor | 94724020002 | |||||
SHATTOCK, Nicholas Simon Keith | Director | 1 Court Lane Dulwich SE21 7DH London | England | British | Solicitor | 43632680001 | ||||
STEARN, Richard James | Director | Portman Square W1H 6LY London 43-45 United Kingdom | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 94050800002 | ||||
WORTHINGTON, Rebecca Jane | Director | The Old Cottage 97 The High Street RG10 8DD Wargrave Berkshire | England | British | Accountant | 130493170001 | ||||
WYATT, Adrian Roger | Director | Broom Manor Cottered SG9 9QE Buntingford Hertfordshire | England | British | Director | 42858810002 | ||||
MIKJON LIMITED | Director designado corporativo | 50 Stratton Street W1X 5FL London | 900004920001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de QUOCUMQUE LIMITED?
Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quintain Limited | 06 abr 2016 | Great Portland Street W1W 5QZ London 180 United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
|
¿Tiene QUOCUMQUE LIMITED alguna carga?
Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
---|---|---|---|---|
Floating charge security agreement | Creado el 14 mar 2008 Entregado el 17 mar 2008 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company and each other chargor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción First floating charge all its assets see image for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
A security agreement | Creado el 04 feb 2008 Entregado el 15 feb 2008 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from each obligor to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción Assigns all rights under any hedging arrangements. By way of first floating charge all assets not otherwise ffectively mortgages charged or assigned by way of fixed mortgage charge or assignment. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
A security agreement | Creado el 29 ene 2008 Entregado el 07 feb 2008 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from each obligor to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción Assigns all rights under any hedging arrangements. By way of first floating charge all assets not otherwise effectively mortgages charged or assigned by way of fixed mortgage charge or assignment. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
A security agreement | Creado el 29 ene 2008 Entregado el 01 feb 2008 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción All rights under any hedging arrangements. By way of floating charge all assets not effectively mortgaged charged or assigned by way of fixed mortgage charge or assignment under the charge. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Security agreement | Creado el 22 oct 2007 Entregado el 25 oct 2007 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción The company assigns all of its rights under any hedging arrangements; a first floating charge all its assets not at any time otherwise effectively mortgaged charged or assigned by way of fixed mortgage. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Security agreement | Creado el 09 jun 2004 Entregado el 15 jun 2004 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from each chargor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción All rights under any hedging arrangements. By way of first floating charge all assets not effectively mortgaged, charged or assigned by way of fixed mortgage, charge or assignment. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Security agreement | Creado el 02 jun 2004 Entregado el 04 jun 2004 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from each chargor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción Floating charge all assets not effectively mortgaged, charged or assigned by way of fixed mortgage, charge or assignment under clause 2 of the deed. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0