INTEGRA COMPUTER SYSTEMS LIMITED

INTEGRA COMPUTER SYSTEMS LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración anual
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaINTEGRA COMPUTER SYSTEMS LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 03657126
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de INTEGRA COMPUTER SYSTEMS LIMITED?

    • Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra INTEGRA COMPUTER SYSTEMS LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Munro House
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Surrey
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de INTEGRA COMPUTER SYSTEMS LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    JBS COMPUTER SERVICES LIMITED05 feb 199905 feb 1999
    GW 1000 LIMITED27 oct 199827 oct 1998

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de INTEGRA COMPUTER SYSTEMS LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta28 feb 2013

    ¿Cuál es el estado de la última declaración anual para INTEGRA COMPUTER SYSTEMS LIMITED?

    Declaración anual
    Última declaración anual

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para INTEGRA COMPUTER SYSTEMS LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros

    6 páginas4.71

    Declaración de solvencia

    3 páginas4.70

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    1 páginas600

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo especial para la liquidación

    LRESSP

    Déclaration annuelle établie au 27 oct 2013 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital05 nov 2013

    Estado de capital el 05 nov 2013

    • Capital: GBP 900,156.74
    SH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 28 feb 2013

    6 páginasAA

    Nombramiento de Ms Vinodka Murria como director

    3 páginasAP01

    Nombramiento de Denise Williams como secretario

    3 páginasAP03

    Domicilio social registrado cambiado de * Booths Park 4 Chelford Road Knutsford Cheshire WA16 8GS England* el 25 mar 2013

    2 páginasAD01

    Cese del nombramiento de Kerry Crompton como director

    2 páginasTM01

    Nombramiento de Barbara Ann Firth como director

    3 páginasAP01

    Nombramiento de Mr Paul David Gibson como director

    3 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Richard Preedy como director

    2 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Neal Roberts como director

    2 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Neal Roberts como secretario

    2 páginasTM02

    Exercice comptable précédent raccourci du 30 abr 2013 au 28 feb 2013

    3 páginasAA01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 abr 2012

    7 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 27 oct 2012 avec liste complète des actionnaires

    7 páginasAR01

    Cambio de datos del director Richard Ian Preedy el 16 ago 2012

    3 páginasCH01

    Nombramiento de Richard Ian Preedy como director

    2 páginasAP01

    Cambio de datos del secretario Mr Neal Anthony Roberts el 16 may 2012

    2 páginasCH03

    Cambio de datos del director Mr Neal Anthony Roberts el 16 may 2012

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Ms Kerry Jane Crompton el 16 may 2012

    2 páginasCH01

    Domicilio social registrado cambiado de * Riding Court House Riding Court Road Datchet Slough Berkshire SL3 9JT United Kingdom* el 14 may 2012

    1 páginasAD01

    ¿Quiénes son los directivos de INTEGRA COMPUTER SYSTEMS LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    WILLIAMS, Denise
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Munro House
    Surrey
    United Kingdom
    Secretario
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Munro House
    Surrey
    United Kingdom
    British176951330001
    FIRTH, Barbara Ann
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Munro House
    Surrey
    United Kingdom
    Director
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Munro House
    Surrey
    United Kingdom
    United KingdomBritish73934790009
    GIBSON, Paul David
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Munro House
    Surrey
    United Kingdom
    Director
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Munro House
    Surrey
    United Kingdom
    United KingdomBritish192439290001
    MURRIA, Vinodka
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Munro House
    Surrey
    United Kingdom
    Director
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Munro House
    Surrey
    United Kingdom
    United KingdomBritish57998050002
    CHALLINGER, Sara
    Hollyoak 2a Cricket Hill
    Finchampstead
    RG40 3TN Wokingham
    Berkshire
    Secretario
    Hollyoak 2a Cricket Hill
    Finchampstead
    RG40 3TN Wokingham
    Berkshire
    British123713140001
    DEAKIN, David Raymond
    11 Witherford Way
    Selly Oak
    B29 4AY Birmingham
    Secretario
    11 Witherford Way
    Selly Oak
    B29 4AY Birmingham
    British77919810002
    FIRTH, Barbara Ann
    Bryher Cottage
    Lynx Hill
    KT24 5AX East Horsley
    Surrey
    Secretario
    Bryher Cottage
    Lynx Hill
    KT24 5AX East Horsley
    Surrey
    British73934790001
    ROBERTS, Neal Anthony
    Chelford Road
    WA16 8GS Knutsford
    Booths Park 4
    Cheshire
    England
    Secretario
    Chelford Road
    WA16 8GS Knutsford
    Booths Park 4
    Cheshire
    England
    British140194900001
    GW SECRETARIES LIMITED
    One Eleven Edmund Street
    B3 2HJ Birmingham
    West Midlands
    Secretario corporativo
    One Eleven Edmund Street
    B3 2HJ Birmingham
    West Midlands
    93128710001
    BARNETT, Gary Michael
    27 Gloucester Road
    WS5 3PL Walsall
    West Midlands
    Director
    27 Gloucester Road
    WS5 3PL Walsall
    West Midlands
    British27665970001
    BLASDALE, Brian John
    Springbrook House
    Spring Lane, Lapworth
    B94 5NS Solihull
    Director
    Springbrook House
    Spring Lane, Lapworth
    B94 5NS Solihull
    British25611010002
    BOAG, Colin Mckinnon
    26 Downlands Way
    South Wonston
    SO21 3HS Winchester
    Hampshire
    Director
    26 Downlands Way
    South Wonston
    SO21 3HS Winchester
    Hampshire
    United KingdomBritish40646640001
    BRAZIER, Barry Allen
    30 Knighton Road
    B74 4NX Sutton Coldfield
    West Midlands
    Director
    30 Knighton Road
    B74 4NX Sutton Coldfield
    West Midlands
    British62375560002
    CROMPTON, Kerry Jane
    Chelford Road
    WA16 8GS Knutsford
    Booths Park 4
    Cheshire
    England
    Director
    Chelford Road
    WA16 8GS Knutsford
    Booths Park 4
    Cheshire
    England
    United KingdomBritish158261930001
    DEMPSEY, Simon Joseph
    Main Road
    Wigginton
    B79 9DS Tamworth
    The Old Vicarage
    Staffs
    Director
    Main Road
    Wigginton
    B79 9DS Tamworth
    The Old Vicarage
    Staffs
    EnglandUnited Kingdom113103110003
    FIRTH, Barbara Ann
    Bryher Cottage
    Lynx Hill
    KT24 5AX East Horsley
    Surrey
    Director
    Bryher Cottage
    Lynx Hill
    KT24 5AX East Horsley
    Surrey
    EnglandBritish73934790001
    JONES, Malcolm David
    8 Hillwood Common Road
    B75 5QJ Sutton Coldfield
    West Midlands
    Director
    8 Hillwood Common Road
    B75 5QJ Sutton Coldfield
    West Midlands
    British73250170002
    LEUW, Martin Philip
    Riding Court Road
    Datchet
    SL3 9JT Slough
    Riding Court House
    Berkshire
    United Kingdom
    Director
    Riding Court Road
    Datchet
    SL3 9JT Slough
    Riding Court House
    Berkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish141644370001
    MURRIA, Vinodka
    Furran
    16 Barham Close
    KT13 9PR Weybridge
    Surrey
    Director
    Furran
    16 Barham Close
    KT13 9PR Weybridge
    Surrey
    United KingdomBritish57998050002
    PILECKA, Jolanta
    15 Mallard Place
    TW1 4SW Twickenham
    Middlesex
    Director
    15 Mallard Place
    TW1 4SW Twickenham
    Middlesex
    United KingdomPolish90593990001
    PREEDY, Richard Ian
    Chelford Road
    WA16 8GS Knutsford
    Booths Park 4
    Cheshire
    England
    Director
    Chelford Road
    WA16 8GS Knutsford
    Booths Park 4
    Cheshire
    England
    EnglandBritish123433610003
    ROBERTS, Neal Anthony
    Chelford Road
    WA16 8GS Knutsford
    Booths Park 4
    Cheshire
    England
    Director
    Chelford Road
    WA16 8GS Knutsford
    Booths Park 4
    Cheshire
    England
    EnglandBritish12470210004
    ST JOHN, Neil
    4 Broom Close
    Wath Upon Dearne
    S63 7JU Rotherham
    South Yorkshire
    Director
    4 Broom Close
    Wath Upon Dearne
    S63 7JU Rotherham
    South Yorkshire
    British71857040001
    VELUSSI, Luca
    Riding Court Road
    Datchet
    SL3 9JT Slough
    Riding Court House
    Berkshire
    United Kingdom
    Director
    Riding Court Road
    Datchet
    SL3 9JT Slough
    Riding Court House
    Berkshire
    United Kingdom
    United KingdomItalian113413330003
    WELLS, Colin Kenelm
    Applecross House
    WV15 6NB Alveley
    Salop
    Director
    Applecross House
    WV15 6NB Alveley
    Salop
    United KingdomBritish115361810001
    GW INCORPORATIONS LIMITED
    Windsor House
    3 Temple Row
    B2 5JR Birmingham
    West Midlands
    Director corporativo
    Windsor House
    3 Temple Row
    B2 5JR Birmingham
    West Midlands
    68279000001

    ¿Tiene INTEGRA COMPUTER SYSTEMS LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Debenture
    Creado el 02 oct 2007
    Entregado el 15 oct 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each obligor to the chargee or any of the other secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Citibank N.A., London as Security Trustee
    Transacciones
    • 15 oct 2007Registro de un cargo (395)
    • 25 ene 2012Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Deed of variation
    Creado el 05 dic 2000
    Entregado el 07 dic 2000
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    The terms of fixed and floating charge dated 27TH january 1999 were amended so that the definition of "loan notes" now reads "the £500,000 units of secured loan notes 2003 of £1 each issued by the company in favour of the lender". The parties confirmed that the loan notes,as re-defined, will fall within the definition of "principal sum" (being part of the amount secured) in the fixed and floating charge dated 27 january 1999
    Breve descripción
    As set out in the fixed and floating charge dated 27TH january 1999.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Development Capital Limited
    Transacciones
    • 07 dic 2000Registro de un cargo (395)
    • 09 jun 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Charge
    Creado el 22 mar 1999
    Entregado el 26 mar 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the agreement dated 19 march 1999
    Breve descripción
    A floating charge, all book debts full benefit of the rights and remedies charged assets.
    Personas con derecho
    • Ibm United Kingdom Financial Services Limited
    Transacciones
    • 26 mar 1999Registro de un cargo (395)
    • 20 feb 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creado el 27 ene 1999
    Entregado el 12 feb 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company formerly known as gw 1000 limited to the chargee pursuant to the terms of the charge
    Breve descripción
    L/H 5TH floor kingston house 438 high street west bromwich west midlands B70 9LD. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Lloyds Development Capital Limited
    Transacciones
    • 12 feb 1999Registro de un cargo (395)
    • 30 abr 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture deed
    Creado el 27 ene 1999
    Entregado el 11 feb 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company (formerly known as gw 1000 limited) to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Lloyds Bank PLC
    Transacciones
    • 11 feb 1999Registro de un cargo (395)
    • 09 jun 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    ¿Tiene INTEGRA COMPUTER SYSTEMS LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    31 ene 2014Inicio de la liquidación
    05 nov 2014Fecha de disolución
    Liquidación voluntaria de socios
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Sean Kenneth Croston
    Grant Thornton Uk Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    Profesional
    Grant Thornton Uk Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0