INTEGRA COMPUTER SYSTEMS LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | INTEGRA COMPUTER SYSTEMS LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 03657126 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | Sí |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de INTEGRA COMPUTER SYSTEMS LIMITED?
- Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas
¿Dónde se encuentra INTEGRA COMPUTER SYSTEMS LIMITED?
| Dirección de la sede social | Munro House Portsmouth Road KT11 1TF Cobham Surrey |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de INTEGRA COMPUTER SYSTEMS LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| JBS COMPUTER SERVICES LIMITED | 05 feb 1999 | 05 feb 1999 |
| GW 1000 LIMITED | 27 oct 1998 | 27 oct 1998 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de INTEGRA COMPUTER SYSTEMS LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 28 feb 2013 |
¿Cuál es el estado de la última declaración anual para INTEGRA COMPUTER SYSTEMS LIMITED?
| Declaración anual |
|
|---|
¿Cuáles son las últimas presentaciones para INTEGRA COMPUTER SYSTEMS LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaceta final disuelta tras la liquidación | 1 páginas | GAZ2 | ||||||||||
Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros | 6 páginas | 4.71 | ||||||||||
Declaración de solvencia | 3 páginas | 4.70 | ||||||||||
Nombramiento de un liquidador voluntario | 1 páginas | 600 | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Déclaration annuelle établie au 27 oct 2013 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 28 feb 2013 | 6 páginas | AA | ||||||||||
Nombramiento de Ms Vinodka Murria como director | 3 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Denise Williams como secretario | 3 páginas | AP03 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de * Booths Park 4 Chelford Road Knutsford Cheshire WA16 8GS England* el 25 mar 2013 | 2 páginas | AD01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Kerry Crompton como director | 2 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Barbara Ann Firth como director | 3 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Paul David Gibson como director | 3 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Richard Preedy como director | 2 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Neal Roberts como director | 2 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Neal Roberts como secretario | 2 páginas | TM02 | ||||||||||
Exercice comptable précédent raccourci du 30 abr 2013 au 28 feb 2013 | 3 páginas | AA01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 abr 2012 | 7 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 27 oct 2012 avec liste complète des actionnaires | 7 páginas | AR01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Richard Ian Preedy el 16 ago 2012 | 3 páginas | CH01 | ||||||||||
Nombramiento de Richard Ian Preedy como director | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cambio de datos del secretario Mr Neal Anthony Roberts el 16 may 2012 | 2 páginas | CH03 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Neal Anthony Roberts el 16 may 2012 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Ms Kerry Jane Crompton el 16 may 2012 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de * Riding Court House Riding Court Road Datchet Slough Berkshire SL3 9JT United Kingdom* el 14 may 2012 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de INTEGRA COMPUTER SYSTEMS LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WILLIAMS, Denise | Secretario | Portsmouth Road KT11 1TF Cobham Munro House Surrey United Kingdom | British | 176951330001 | ||||||
| FIRTH, Barbara Ann | Director | Portsmouth Road KT11 1TF Cobham Munro House Surrey United Kingdom | United Kingdom | British | 73934790009 | |||||
| GIBSON, Paul David | Director | Portsmouth Road KT11 1TF Cobham Munro House Surrey United Kingdom | United Kingdom | British | 192439290001 | |||||
| MURRIA, Vinodka | Director | Portsmouth Road KT11 1TF Cobham Munro House Surrey United Kingdom | United Kingdom | British | 57998050002 | |||||
| CHALLINGER, Sara | Secretario | Hollyoak 2a Cricket Hill Finchampstead RG40 3TN Wokingham Berkshire | British | 123713140001 | ||||||
| DEAKIN, David Raymond | Secretario | 11 Witherford Way Selly Oak B29 4AY Birmingham | British | 77919810002 | ||||||
| FIRTH, Barbara Ann | Secretario | Bryher Cottage Lynx Hill KT24 5AX East Horsley Surrey | British | 73934790001 | ||||||
| ROBERTS, Neal Anthony | Secretario | Chelford Road WA16 8GS Knutsford Booths Park 4 Cheshire England | British | 140194900001 | ||||||
| GW SECRETARIES LIMITED | Secretario corporativo | One Eleven Edmund Street B3 2HJ Birmingham West Midlands | 93128710001 | |||||||
| BARNETT, Gary Michael | Director | 27 Gloucester Road WS5 3PL Walsall West Midlands | British | 27665970001 | ||||||
| BLASDALE, Brian John | Director | Springbrook House Spring Lane, Lapworth B94 5NS Solihull | British | 25611010002 | ||||||
| BOAG, Colin Mckinnon | Director | 26 Downlands Way South Wonston SO21 3HS Winchester Hampshire | United Kingdom | British | 40646640001 | |||||
| BRAZIER, Barry Allen | Director | 30 Knighton Road B74 4NX Sutton Coldfield West Midlands | British | 62375560002 | ||||||
| CROMPTON, Kerry Jane | Director | Chelford Road WA16 8GS Knutsford Booths Park 4 Cheshire England | United Kingdom | British | 158261930001 | |||||
| DEMPSEY, Simon Joseph | Director | Main Road Wigginton B79 9DS Tamworth The Old Vicarage Staffs | England | United Kingdom | 113103110003 | |||||
| FIRTH, Barbara Ann | Director | Bryher Cottage Lynx Hill KT24 5AX East Horsley Surrey | England | British | 73934790001 | |||||
| JONES, Malcolm David | Director | 8 Hillwood Common Road B75 5QJ Sutton Coldfield West Midlands | British | 73250170002 | ||||||
| LEUW, Martin Philip | Director | Riding Court Road Datchet SL3 9JT Slough Riding Court House Berkshire United Kingdom | United Kingdom | British | 141644370001 | |||||
| MURRIA, Vinodka | Director | Furran 16 Barham Close KT13 9PR Weybridge Surrey | United Kingdom | British | 57998050002 | |||||
| PILECKA, Jolanta | Director | 15 Mallard Place TW1 4SW Twickenham Middlesex | United Kingdom | Polish | 90593990001 | |||||
| PREEDY, Richard Ian | Director | Chelford Road WA16 8GS Knutsford Booths Park 4 Cheshire England | England | British | 123433610003 | |||||
| ROBERTS, Neal Anthony | Director | Chelford Road WA16 8GS Knutsford Booths Park 4 Cheshire England | England | British | 12470210004 | |||||
| ST JOHN, Neil | Director | 4 Broom Close Wath Upon Dearne S63 7JU Rotherham South Yorkshire | British | 71857040001 | ||||||
| VELUSSI, Luca | Director | Riding Court Road Datchet SL3 9JT Slough Riding Court House Berkshire United Kingdom | United Kingdom | Italian | 113413330003 | |||||
| WELLS, Colin Kenelm | Director | Applecross House WV15 6NB Alveley Salop | United Kingdom | British | 115361810001 | |||||
| GW INCORPORATIONS LIMITED | Director corporativo | Windsor House 3 Temple Row B2 5JR Birmingham West Midlands | 68279000001 |
¿Tiene INTEGRA COMPUTER SYSTEMS LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Creado el 02 oct 2007 Entregado el 15 oct 2007 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from each obligor to the chargee or any of the other secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Deed of variation | Creado el 05 dic 2000 Entregado el 07 dic 2000 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada The terms of fixed and floating charge dated 27TH january 1999 were amended so that the definition of "loan notes" now reads "the £500,000 units of secured loan notes 2003 of £1 each issued by the company in favour of the lender". The parties confirmed that the loan notes,as re-defined, will fall within the definition of "principal sum" (being part of the amount secured) in the fixed and floating charge dated 27 january 1999 | |
Breve descripción As set out in the fixed and floating charge dated 27TH january 1999. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Charge | Creado el 22 mar 1999 Entregado el 26 mar 1999 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the agreement dated 19 march 1999 | |
Breve descripción A floating charge, all book debts full benefit of the rights and remedies charged assets. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Fixed and floating charge | Creado el 27 ene 1999 Entregado el 12 feb 1999 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company formerly known as gw 1000 limited to the chargee pursuant to the terms of the charge | |
Breve descripción L/H 5TH floor kingston house 438 high street west bromwich west midlands B70 9LD. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture deed | Creado el 27 ene 1999 Entregado el 11 feb 1999 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company (formerly known as gw 1000 limited) to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
¿Tiene INTEGRA COMPUTER SYSTEMS LIMITED algún caso de insolvencia?
| Número de expediente | Fechas | Tipo | Profesionales | Otro | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidación voluntaria de socios |
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0