SHUKCO 322 LTD

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración anual
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaSHUKCO 322 LTD
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 03661159
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de SHUKCO 322 LTD?

    • Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales

    ¿Dónde se encuentra SHUKCO 322 LTD?

    Dirección de la sede social
    Sita House
    Grenfell Road
    SL6 1ES Maidenhead
    Berkshire
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de SHUKCO 322 LTD?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    SITA MR SHEFFIELD LIMITED05 sept 200705 sept 2007
    EASCO (SHEFFIELD) LIMITED11 dic 199811 dic 1998
    ALLIEDCLEAR LIMITED04 nov 199804 nov 1998

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de SHUKCO 322 LTD?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2013

    ¿Cuál es el estado de la última declaración anual para SHUKCO 322 LTD?

    Declaración anual
    Última declaración anual

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para SHUKCO 322 LTD?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Cese del nombramiento de David Courtenay Palmer-Jones como director el 03 jun 2015

    1 páginasTM01

    Cambio de datos del director Mr Christophe Andre Bernard Chapron el 01 sept 2015

    2 páginasCH01

    Certificado de cambio de nombre

    Company name changed sita mr sheffield LIMITED\certificate issued on 14/07/15
    3 páginasCERTNM
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    change-of-name14 jul 2015

    Cambio de nombre por resolución

    NM01
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    change-of-name

    Resolución de cambio de nombre de la empresa el 03 jun 2015

    RES15

    legacy

    1 páginasSH20

    Estado de capital el 14 jul 2015

    • Capital: GBP 2
    4 páginasSH19

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06

    Resoluciones

    Resolutions
    10 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    incorporation

    Resolución de adopción de los Artículos de Asociación

    RES01

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    change-of-name

    Resolución de cambio de nombre de la empresa el 03 jun 2015

    RES15

    Déclaration annuelle établie au 01 dic 2014 avec liste complète des actionnaires

    3 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital09 dic 2014

    Estado de capital el 09 dic 2014

    • Capital: GBP 1,000
    SH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2013

    6 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 01 dic 2013 avec liste complète des actionnaires

    3 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital09 dic 2013

    Estado de capital el 09 dic 2013

    • Capital: GBP 1,000
    SH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2012

    9 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 01 dic 2012 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2011

    16 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 01 dic 2011 avec liste complète des actionnaires

    3 páginasAR01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2010

    18 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 01 dic 2010 avec liste complète des actionnaires

    3 páginasAR01

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resoluciones

    Appointed auditors 22/09/2010
    RES13

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2009

    19 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 01 dic 2009 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01

    Cambio de datos del director Mr David Palmer-Jones el 01 nov 2009

    2 páginasCH01

    ¿Quiénes son los directivos de SHUKCO 322 LTD?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    THOMPSON, Mark Hedley
    Sita House
    Grenfell Road
    SL6 1ES Maidenhead
    Berkshire
    Secretario
    Sita House
    Grenfell Road
    SL6 1ES Maidenhead
    Berkshire
    British135450680001
    CHAPRON, Christophe Andre Bernard
    Sita House
    Grenfell Road
    SL6 1ES Maidenhead
    Berkshire
    Director
    Sita House
    Grenfell Road
    SL6 1ES Maidenhead
    Berkshire
    EnglandFrench122645500006
    CUBITT, Richard
    23 Mill Road
    NR11 6DS Aylsham
    Secretario
    23 Mill Road
    NR11 6DS Aylsham
    British114403390001
    MCKENA-MAYES, Graham Arthur
    38 Bremer Road
    TW18 4HU Staines
    Middlesex
    Secretario
    38 Bremer Road
    TW18 4HU Staines
    Middlesex
    British91435430003
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secretario designado corporativo
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    BILLIG, Neil Jonathan
    5 Staitheway Road
    Wroxham
    NR12 8TH Norwich
    Norfolk
    Director
    5 Staitheway Road
    Wroxham
    NR12 8TH Norwich
    Norfolk
    British15677460004
    CUBITT, Richard
    23 Mill Road
    NR11 6DS Aylsham
    Director
    23 Mill Road
    NR11 6DS Aylsham
    EnglandBritish114403390001
    HARRISON, Richard
    15 Dalewood Avenue
    Beauchief
    S8 0EG Sheffield
    South Yorkshire
    Director
    15 Dalewood Avenue
    Beauchief
    S8 0EG Sheffield
    South Yorkshire
    British82759320001
    HJORT, Per-Anders
    Flat 76
    21 Sheldon Square
    W2 6DS Paddington London
    Director
    Flat 76
    21 Sheldon Square
    W2 6DS Paddington London
    Swedish121832680001
    MARKELL, Brian Stuart
    Bridge House Church Lane
    Ravenfield
    S65 4NG Rotherham
    South Yorkshire
    Director
    Bridge House Church Lane
    Ravenfield
    S65 4NG Rotherham
    South Yorkshire
    EnglandBritish11150720001
    PALMER-JONES, David Courtenay
    Sita House
    Grenfell Road
    SL6 1ES Maidenhead
    Berkshire
    Director
    Sita House
    Grenfell Road
    SL6 1ES Maidenhead
    Berkshire
    United KingdomBritish125070620001
    SERRUYS, Andre Paul
    The Old Rectory
    Whinburgh
    NR19 1QS Dereham
    Norfolk
    Director
    The Old Rectory
    Whinburgh
    NR19 1QS Dereham
    Norfolk
    British33476230001
    WINSTONE, Steven Dominic
    The Old Bank
    20 High Street Beighton
    S20 1HA Sheffield
    South Yorkshire
    Director
    The Old Bank
    20 High Street Beighton
    S20 1HA Sheffield
    South Yorkshire
    EnglandBritish125330840001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Director designado corporativo
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    ¿Tiene SHUKCO 322 LTD alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Debenture
    Creado el 06 sept 2005
    Entregado el 09 sept 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Hsbc Bank PLC
    Transacciones
    • 09 sept 2005Registro de un cargo (395)
    • 17 feb 2009Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 28 jul 2003
    Entregado el 31 jul 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 31 jul 2003Registro de un cargo (395)
    • 09 sept 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    A deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement
    Creado el 30 sept 2002
    Entregado el 08 oct 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Any sum or sums standing to the credit of any present or future account of the company with the bank.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 08 oct 2002Registro de un cargo (395)
    • 31 jul 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    A deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 30TH january 2001
    Creado el 29 may 2002
    Entregado el 01 jun 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with the bank.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 01 jun 2002Registro de un cargo (395)
    • 31 jul 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture deed
    Creado el 22 dic 1998
    Entregado el 30 dic 1998
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Lloyds Bank PLC
    Transacciones
    • 30 dic 1998Registro de un cargo (395)
    • 31 jul 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0