COMPUTER SOFTWARE LIMITED

COMPUTER SOFTWARE LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración anual
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaCOMPUTER SOFTWARE LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 03665527
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de COMPUTER SOFTWARE LIMITED?

    • Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra COMPUTER SOFTWARE LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Munro House
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Surrey
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de COMPUTER SOFTWARE LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    GUILDFORD MIDCO 2 LIMITED12 may 201012 may 2010
    COMPUTER SOFTWARE LIMITED12 jul 199912 jul 1999
    COMPUTER SOFTWARE HOLDINGS LIMITED26 mar 199926 mar 1999
    MAILCLEAR LIMITED11 nov 199811 nov 1998

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de COMPUTER SOFTWARE LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta28 feb 2013

    ¿Cuál es el estado de la última declaración anual para COMPUTER SOFTWARE LIMITED?

    Declaración anual
    Última declaración anual

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para COMPUTER SOFTWARE LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    GAZ2

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros

    6 páginas4.71

    Declaración de solvencia

    4 páginas4.70

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    1 páginas600

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo especial para la liquidación

    LRESSP

    Déclaration annuelle établie au 11 nov 2013 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital12 nov 2013

    Estado de capital el 12 nov 2013

    • Capital: GBP 464,523.75
    SH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 28 feb 2013

    7 páginasAA

    Renuncia del auditor

    2 páginasAUD

    Nombramiento de Denise Williams como secretario

    3 páginasAP03

    Nombramiento de Ms Vinodka Murria como director

    3 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Kerry Crompton como director

    2 páginasTM01

    Domicilio social registrado cambiado de * Booths Park 4 Chelford Road Knutsford Cheshire WA16 8GS England* el 25 mar 2013

    2 páginasAD01

    Cese del nombramiento de Richard Preedy como director

    2 páginasTM01

    Nombramiento de Mrs Barbara Ann Firth como director

    3 páginasAP01

    Nombramiento de Mr Paul David Gibson como director

    3 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Neal Roberts como director

    2 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Neal Roberts como secretario

    2 páginasTM02

    Exercice comptable précédent raccourci du 30 abr 2013 au 28 feb 2013

    3 páginasAA01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 abr 2012

    7 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 11 nov 2012 avec liste complète des actionnaires

    7 páginasAR01

    Cambio de datos del director Richard Ian Preedy el 16 ago 2012

    3 páginasCH01

    Nombramiento de Richard Ian Preedy como director

    2 páginasAP01

    Domicilio social registrado cambiado de * Riding Court House Riding Court Road Datchet Slough Berkshire SL3 9JT United Kingdom* el 14 may 2012

    1 páginasAD01

    Memorándum y Estatutos

    26 páginasMEM/ARTS

    Resoluciones

    Resolutions
    3 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    incorporation

    Resolución del Memorándum de Asociación

    RES01

    ¿Quiénes son los directivos de COMPUTER SOFTWARE LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    WILLIAMS, Denise
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Munro House
    Surrey
    United Kingdom
    Secretario
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Munro House
    Surrey
    United Kingdom
    British176951890001
    FIRTH, Barbara Ann
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Munro House
    Surrey
    United Kingdom
    Director
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Munro House
    Surrey
    United Kingdom
    United KingdomBritishFinance Director73934790009
    GIBSON, Paul David
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Munro House
    Surrey
    United Kingdom
    Director
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Munro House
    Surrey
    United Kingdom
    United KingdomBritishFcca192439290001
    MURRIA, Vinodka
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Munro House
    Surrey
    United Kingdom
    Director
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Munro House
    Surrey
    United Kingdom
    United KingdomBritishCeo57998050002
    CHALLINGER, Sara
    Hollyoak 2a Cricket Hill
    Finchampstead
    RG40 3TN Wokingham
    Berkshire
    Secretario
    Hollyoak 2a Cricket Hill
    Finchampstead
    RG40 3TN Wokingham
    Berkshire
    BritishCompany Secretary123713140001
    EDGELL, Malcolm John
    52 Moriconium Quay
    Lake Avenue
    BH15 4QP Poole
    Dorset
    Secretario
    52 Moriconium Quay
    Lake Avenue
    BH15 4QP Poole
    Dorset
    British33977500002
    FIRTH, Barbara Ann
    Bryher Cottage
    Lynx Hill
    KT24 5AX East Horsley
    Surrey
    Secretario
    Bryher Cottage
    Lynx Hill
    KT24 5AX East Horsley
    Surrey
    British73934790001
    HARDIE, Alistair Peter
    Waveney Cottage
    Hill Grove, Lurgashall
    GU28 9EW Petworth
    West Sussex
    Secretario
    Waveney Cottage
    Hill Grove, Lurgashall
    GU28 9EW Petworth
    West Sussex
    BritishDirector68788350001
    MAYTUM, Barry
    4 Saint Marks Road
    RG9 1LJ Henley On Thames
    Oxfordshire
    Secretario
    4 Saint Marks Road
    RG9 1LJ Henley On Thames
    Oxfordshire
    BritishProposed Director69845130001
    ROBERTS, Neal Anthony
    Chelford Road
    WA16 8GS Knutsford
    Booths Park 4
    Cheshire
    England
    Secretario
    Chelford Road
    WA16 8GS Knutsford
    Booths Park 4
    Cheshire
    England
    British140194900001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secretario designado corporativo
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    BAGGS, Michael Vincent
    23 Brodrick Road
    SW7 7DX London
    Director
    23 Brodrick Road
    SW7 7DX London
    United KingdomBritishDirector25974780001
    BARNES, Kenneth Roy
    29 St James Square
    BA1 2TT Bath
    Avon
    Director
    29 St James Square
    BA1 2TT Bath
    Avon
    BritishDirector33463930001
    CROMPTON, Kerry Jane
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Munro House
    Surrey
    Director
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Munro House
    Surrey
    United KingdomBritishLawyer158261930001
    CROSS, Neil Edward
    Ithaca Lower Park Road
    EX33 2LQ Braunton
    Devon
    Director
    Ithaca Lower Park Road
    EX33 2LQ Braunton
    Devon
    EnglandBritishDirector26042290002
    EDGELL, Malcolm John
    52 Moriconium Quay
    Lake Avenue
    BH15 4QP Poole
    Dorset
    Director
    52 Moriconium Quay
    Lake Avenue
    BH15 4QP Poole
    Dorset
    BritishFinance Director33977500002
    FIRTH, Barbara Ann
    Bryher Cottage
    Lynx Hill
    KT24 5AX East Horsley
    Surrey
    Director
    Bryher Cottage
    Lynx Hill
    KT24 5AX East Horsley
    Surrey
    EnglandBritishAccountant73934790001
    HARDIE, Alistair Peter
    Waveney Cottage
    Hill Grove, Lurgashall
    GU28 9EW Petworth
    West Sussex
    Director
    Waveney Cottage
    Hill Grove, Lurgashall
    GU28 9EW Petworth
    West Sussex
    EnglandBritishSoftware Development68788350001
    HOLLAND, Christopher
    Heathermount House
    Heathermount Drive
    RG45 6HL Crouthorne
    Berkshire
    Director
    Heathermount House
    Heathermount Drive
    RG45 6HL Crouthorne
    Berkshire
    BritishDirector77338810001
    JACKSON, Glenn Thomas
    Moss House
    SY14 7JJ Malpas
    Cheshire
    Director
    Moss House
    SY14 7JJ Malpas
    Cheshire
    EnglandBritishConsultant38721150004
    JACKSON, Michael Edward Wilson
    2 Castello Avenue
    Putney
    SW15 6EA London
    Director
    2 Castello Avenue
    Putney
    SW15 6EA London
    United KingdomBritishVenture Capitalist40521530001
    LEUW, Martin Philip
    Riding Court Road
    Datchet
    SL3 9JT Slough
    Riding Court House
    Berkshire
    United Kingdom
    Director
    Riding Court Road
    Datchet
    SL3 9JT Slough
    Riding Court House
    Berkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director141644370001
    LOWE, David Andrew
    Boreley House
    Boreley
    WR9 0HU Ombersley
    Worcestershire
    Director
    Boreley House
    Boreley
    WR9 0HU Ombersley
    Worcestershire
    BritishAccountant10441050001
    MAYTUM, Barry
    4 Saint Marks Road
    RG9 1LJ Henley On Thames
    Oxfordshire
    Director
    4 Saint Marks Road
    RG9 1LJ Henley On Thames
    Oxfordshire
    UkBritishProposed Director69845130001
    MURRIA, Vinodka
    Furran
    16 Barham Close
    KT13 9PR Weybridge
    Surrey
    Director
    Furran
    16 Barham Close
    KT13 9PR Weybridge
    Surrey
    United KingdomBritishDirector57998050002
    PILECKA, Jolanta
    15 Mallard Place
    TW1 4SW Twickenham
    Middlesex
    Director
    15 Mallard Place
    TW1 4SW Twickenham
    Middlesex
    United KingdomPolishDirector90593990001
    PINNING, Stephen Peter
    79a Shepherds Hill
    Highgate
    N6 5RG London
    Director
    79a Shepherds Hill
    Highgate
    N6 5RG London
    BritishDirector14848160001
    PREEDY, Richard Ian
    Chelford Road
    WA16 8GS Knutsford
    Booths Park 4
    Cheshire
    England
    Director
    Chelford Road
    WA16 8GS Knutsford
    Booths Park 4
    Cheshire
    England
    EnglandBritishAccountant123433610003
    ROBERTS, Neal Anthony
    Chelford Road
    WA16 8GS Knutsford
    Booths Park 4
    Cheshire
    England
    Director
    Chelford Road
    WA16 8GS Knutsford
    Booths Park 4
    Cheshire
    England
    EnglandBritishDirector12470210004
    TAYLOR, David John
    16 Wheeler Avenue
    Penn
    HP10 8EN High Wycombe
    Buckinghamshire
    Director
    16 Wheeler Avenue
    Penn
    HP10 8EN High Wycombe
    Buckinghamshire
    EnglandBritishDirector91573380001
    VELUSSI, Luca
    123 Hepworth Court
    30 Gatliff Road
    SW1W 8QP London
    Director
    123 Hepworth Court
    30 Gatliff Road
    SW1W 8QP London
    United KingdomItalianDirector113413330002
    WELLS, Colin Kenelm
    Applecross House
    WV15 6NB Alveley
    Salop
    Director
    Applecross House
    WV15 6NB Alveley
    Salop
    United KingdomBritishDirector115361810001
    CLARKS NOMINEES LIMITED
    Great Western House
    Station Road
    RG1 1JX Reading
    Berkshire
    Director corporativo
    Great Western House
    Station Road
    RG1 1JX Reading
    Berkshire
    38350670001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Director designado corporativo
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    ¿Tiene COMPUTER SOFTWARE LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Debenture
    Creado el 02 oct 2007
    Entregado el 15 oct 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each obligor to the chargee or any of the other secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Citibank N.A.,London as Security Trustee
    Transacciones
    • 15 oct 2007Registro de un cargo (395)
    • 25 ene 2012Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Guarantee & debenture
    Creado el 27 jul 2004
    Entregado el 07 ago 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 07 ago 2004Registro de un cargo (395)
    • 09 jun 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 07 oct 2002
    Entregado el 16 oct 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the borrower to the security trsutee and/or any lender on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Elderstreet Capital Partners Nominees Limited (The Security Trustee)
    Transacciones
    • 16 oct 2002Registro de un cargo (395)
    • 09 ago 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 06 dic 2001
    Entregado el 12 dic 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 12 dic 2001Registro de un cargo (395)
    • 09 jun 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Charge over credit balances
    Creado el 10 may 2000
    Entregado el 12 may 2000
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    The sum of £45,000 held on an account with the bank together with interest thereon.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 12 may 2000Registro de un cargo (395)
    • 04 jul 2001Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creado el 16 dic 1998
    Entregado el 23 dic 1998
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 23 dic 1998Registro de un cargo (395)
    • 04 jul 2001Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    ¿Tiene COMPUTER SOFTWARE LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    31 ene 2014Inicio de la liquidación
    05 nov 2014Fecha de disolución
    Liquidación voluntaria de socios
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Sean Kenneth Croston
    Grant Thornton Uk Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    Profesional
    Grant Thornton Uk Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0