GATE GOURMET GATWICK LIMITED

GATE GOURMET GATWICK LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración anual
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaGATE GOURMET GATWICK LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 03669272
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de GATE GOURMET GATWICK LIMITED?

    • Actividades de catering para eventos (56210) / Actividades de alojamiento y de servicios de comida

    ¿Dónde se encuentra GATE GOURMET GATWICK LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Heathrow West
    Building 1071 Southampton Road
    TW6 3AQ Heathrow Airport Hounslow
    Middlesex
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de GATE GOURMET GATWICK LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    GATE GOURMET GATWICK (1998) LIMITED12 nov 199812 nov 1998

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de GATE GOURMET GATWICK LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2014

    ¿Cuál es el estado de la última declaración anual para GATE GOURMET GATWICK LIMITED?

    Declaración anual
    Última declaración anual

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para GATE GOURMET GATWICK LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01
    A4GKTWHT

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2014

    7 páginasAA
    A4CVFNHD

    Déclaration annuelle établie au 30 oct 2014 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital11 nov 2014

    Estado de capital el 11 nov 2014

    • Capital: GBP 100
    SH01
    X3KEM4UB

    Cancelación total de la carga 4

    2 páginasMR04
    X3F4QXCJ

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2013

    7 páginasAA
    A3BA19MQ

    Déclaration annuelle établie au 30 oct 2013 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital03 nov 2013

    Estado de capital el 03 nov 2013

    • Capital: GBP 4,000,001
    SH01
    X2KE018G

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2012

    7 páginasAA
    L2HPNWKB

    Cese del nombramiento de Pieter Van Niekerk como director

    1 páginasTM01
    X2D79WAI

    Déclaration annuelle établie au 30 oct 2012 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    X1M4DKH4

    Nombramiento de Mr Sreekumar Nair como secretario

    1 páginasAP03
    X1M4DI6H

    Cese del nombramiento de Owais Aziz como secretario

    1 páginasTM02
    X1M4DHGX

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2011

    7 páginasAA
    L1IFDX5S

    Resoluciones

    Resolutions
    16 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    incorporation

    Resolución del Memorándum de Asociación

    RES01

    Déclaration annuelle établie au 30 oct 2011 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    XBEJ5Z5E

    Nombramiento de Mr Owais Aziz como secretario

    1 páginasAP03
    XBE10Z5R

    Nombramiento de Mr Mark Andrew Burton como director

    2 páginasAP01
    XB9OFZ5O

    Cese del nombramiento de Mark Burton como secretario

    1 páginasTM02
    XB9JLZ5P

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2010

    7 páginasAA
    A4D19XZX

    Déclaration annuelle établie au 30 oct 2010 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    XXA8TP0U

    Cambio de datos del director Thomas William Fountain el 25 oct 2010

    2 páginasCH01
    XQZSJOJ4

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2009

    7 páginasAA
    AMGIZMM1

    Déclaration annuelle établie au 30 oct 2009 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    XDXNMFNI

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2008

    7 páginasAA
    ANWGWE3M

    ¿Quiénes son los directivos de GATE GOURMET GATWICK LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    NAIR, Sreekumar
    Heathrow West
    Building 1071 Southampton Road
    TW6 3AQ Heathrow Airport Hounslow
    Middlesex
    Secretario
    Heathrow West
    Building 1071 Southampton Road
    TW6 3AQ Heathrow Airport Hounslow
    Middlesex
    173789720001
    BURTON, Mark Andrew, Mr.
    Heathrow West
    Building 1071 Southampton Road
    TW6 3AQ Heathrow Airport Hounslow
    Middlesex
    Director
    Heathrow West
    Building 1071 Southampton Road
    TW6 3AQ Heathrow Airport Hounslow
    Middlesex
    EnglandBritishChartered Accountant163432930001
    FOUNTAIN, Thomas William
    Heathrow West
    Building 1071 Southampton Road
    TW6 3AQ Heathrow Airport Hounslow
    Middlesex
    Director
    Heathrow West
    Building 1071 Southampton Road
    TW6 3AQ Heathrow Airport Hounslow
    Middlesex
    United KingdomBritishChartered Accountant136880590001
    AZIZ, Owais
    Heathrow West
    Building 1071 Southampton Road
    TW6 3AQ Heathrow Airport Hounslow
    Middlesex
    Secretario
    Heathrow West
    Building 1071 Southampton Road
    TW6 3AQ Heathrow Airport Hounslow
    Middlesex
    164529380001
    BRADLEY, Anne Teresa
    61 Lime Grove
    UB3 1JL Hayes
    Middlesex
    Secretario
    61 Lime Grove
    UB3 1JL Hayes
    Middlesex
    BritishCorporate Finance Officer77833020001
    BURTON, Mark Andrew
    Bushy Park Road
    TW11 9DG Teddington
    40
    Middlesex
    Secretario
    Bushy Park Road
    TW11 9DG Teddington
    40
    Middlesex
    BritishChartered Accountant136879670001
    COX, Graeme
    6 Kennedy Avenue
    RH19 2DE East Grinstead
    West Sussex
    Secretario
    6 Kennedy Avenue
    RH19 2DE East Grinstead
    West Sussex
    British59162650001
    ELLIS, Stephen
    Westacre House
    North Street
    SL4 4TE Winkfield
    Berkshire
    Secretario
    Westacre House
    North Street
    SL4 4TE Winkfield
    Berkshire
    AmericanFinance Director88353120001
    JONES, Michael John
    9 Norman Avenue
    TW1 2LY Twickenham
    Middlesex
    Secretario
    9 Norman Avenue
    TW1 2LY Twickenham
    Middlesex
    United KingdomChartered Accountant1131560001
    KARAM, Michel
    21 Burnthouse Gardens
    RG42 3XY Warfield
    Berkshire
    Secretario
    21 Burnthouse Gardens
    RG42 3XY Warfield
    Berkshire
    IrishFinance Director75385180001
    VENTURINI, Diane Patricia
    76 Evelyn Crescent
    TW16 6LZ Sunbury On Thames
    Middlesex
    Secretario
    76 Evelyn Crescent
    TW16 6LZ Sunbury On Thames
    Middlesex
    British94640370002
    WOOD, Stephen Wallace
    3 Whitney Lane
    West Simsbury
    Connecticut 06092-2411
    Usa
    Secretario
    3 Whitney Lane
    West Simsbury
    Connecticut 06092-2411
    Usa
    AmericanGeneral Counsel103615180001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secretario designado corporativo
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    BACHMANN, Rudolf
    3c Laleham Road
    TW18 2DS Staines
    Middlesex
    Director
    3c Laleham Road
    TW18 2DS Staines
    Middlesex
    SwissVice President Md79733150001
    BANDMANN, Ralph Jurgen
    Windyridge
    34 Loudhams Road
    HP7 9NX Little Chalfont
    Buckinghamshire
    Director
    Windyridge
    34 Loudhams Road
    HP7 9NX Little Chalfont
    Buckinghamshire
    BritishVice President Managing Direct75206880001
    BORN, Eric Martin
    Chestnut Barn
    Crowsley
    RG9 4JL Henley On Thames
    Oxfordshire
    Director
    Chestnut Barn
    Crowsley
    RG9 4JL Henley On Thames
    Oxfordshire
    United KingdomSwissManaging Director159179730001
    BORN, Eric Martin
    Chestnut Barn
    Crowsley
    RG9 4JL Henley On Thames
    Oxfordshire
    Director
    Chestnut Barn
    Crowsley
    RG9 4JL Henley On Thames
    Oxfordshire
    United KingdomSwissManaging Director159179730001
    DHILLON, Ravinder Singh
    72 Montrose Avenue
    DA15 9DS Sidcup
    Kent
    Director
    72 Montrose Avenue
    DA15 9DS Sidcup
    Kent
    BritishFinance Director100315580001
    ELLIS, Stephen
    Westacre House
    North Street
    SL4 4TE Winkfield
    Berkshire
    Director
    Westacre House
    North Street
    SL4 4TE Winkfield
    Berkshire
    AmericanFinance Director88353120001
    GREVENER, Hartvig
    Zumikerstrasse 20
    Zollikon
    Ch 8702
    Switzerland
    Director
    Zumikerstrasse 20
    Zollikon
    Ch 8702
    Switzerland
    GermanVice President Of Gate Gourmet75206560001
    GREY, Jonathan Guthrie
    Orchard Cottage
    Gaston Lane
    RG29 1RH South Warnborough
    Hampshire
    Director
    Orchard Cottage
    Gaston Lane
    RG29 1RH South Warnborough
    Hampshire
    United KingdomBritishAccountant91238330001
    HERASIMTSCHUK, Walter
    Sylvan House
    Middleton Road
    GU15 3TU Camberley
    Surrey
    Director
    Sylvan House
    Middleton Road
    GU15 3TU Camberley
    Surrey
    UsManaging Director36718470002
    JONES, Michael John
    9 Norman Avenue
    TW1 2LY Twickenham
    Middlesex
    Director
    9 Norman Avenue
    TW1 2LY Twickenham
    Middlesex
    EnglandUnited KingdomChartered Accountant1131560001
    KARAM, Michel
    21 Burnthouse Gardens
    RG42 3XY Warfield
    Berkshire
    Director
    21 Burnthouse Gardens
    RG42 3XY Warfield
    Berkshire
    IrishFinance Director75385180001
    LUCHSINGER, Martin Ulrich
    Waesserwiesen Strasse 3
    CH 8408 Winterthur
    Switzerland
    Director
    Waesserwiesen Strasse 3
    CH 8408 Winterthur
    Switzerland
    SwissRegional Vice President72493700002
    SCHIFTER, Richard Paul
    3465 Macomb Street Nw
    Washington Dc
    20036
    Usa
    Director
    3465 Macomb Street Nw
    Washington Dc
    20036
    Usa
    AmericanInvestor103615320001
    SIEBENHAAR, Stefan
    Usterstrasse 57
    Illnaw 8303
    FOREIGN Switzerland
    Director
    Usterstrasse 57
    Illnaw 8303
    FOREIGN Switzerland
    SwissAccountant59162800001
    STENT TORRIANI, Jonathan Edward
    Obstgartenstrasse 18
    Kloten
    Ch 8302
    Switzerland
    Director
    Obstgartenstrasse 18
    Kloten
    Ch 8302
    Switzerland
    CanadianPresident Division Europe75206530001
    VAN NIEKERK, Pieter
    Geraldine Road
    W4 3PA Chiswick
    8
    Middlesex
    Director
    Geraldine Road
    W4 3PA Chiswick
    8
    Middlesex
    United KingdomAmericanManaging Director136880100001
    WOOD, Stephen Wallace
    3 Whitney Lane
    West Simsbury
    Connecticut 06092-2411
    Usa
    Director
    3 Whitney Lane
    West Simsbury
    Connecticut 06092-2411
    Usa
    AmericanGeneral Counsel103615180001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Director designado corporativo
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Director designado corporativo
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001

    ¿Tiene GATE GOURMET GATWICK LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Debenture
    Creado el 31 may 2007
    Entregado el 18 jun 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from a non-us borrower, luxco iii and a non-us subsidiary under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Goldman Sachs Credit Partners, L.P. the Non-Us Collateral Agent on Behalf of All of the Securedparties
    Transacciones
    • 18 jun 2007Registro de un cargo (395)
    • 27 ago 2014Satisfacción de una carga (MR04)
    Debenture
    Creado el 09 mar 2006
    Entregado el 22 mar 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from a non-us borrower, luxco iii, a non-us subsidiary and a non-us subsidiary under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Goldman Sachs Credit Partners, L.P. (The Non-Us Collateral Agent)
    Transacciones
    • 22 mar 2006Registro de un cargo (395)
    • 12 jun 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture in counterparts
    Creado el 27 mar 2003
    Entregado el 01 abr 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All obligations and liabilities due or to become due from any restricted obligor to any secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Citicorp Trustee Company Limited,London,as Trustee for the Secured Parties
    Transacciones
    • 01 abr 2003Registro de un cargo (395)
    • 04 jun 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 19 dic 2002
    Entregado el 06 ene 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from any restricted obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    F/H property k/a ranworth flight kitchen charlwood road horley surrey unit number V046 operating building. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Citicorp Trustee Company Limited in Its Capacity as Trustee for the Secured Parties and Itsassignees, Transferees and Successors from Timeto Time
    Transacciones
    • 06 ene 2003Registro de un cargo (395)
    • 04 jun 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0