HOWDEN NORTH AMERICAN PROPERTY & CASUALTY LIMITED

HOWDEN NORTH AMERICAN PROPERTY & CASUALTY LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaHOWDEN NORTH AMERICAN PROPERTY & CASUALTY LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 03671042
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de HOWDEN NORTH AMERICAN PROPERTY & CASUALTY LIMITED?

    • Seguros no de vida (65120) / Actividades financieras y de seguros

    ¿Dónde se encuentra HOWDEN NORTH AMERICAN PROPERTY & CASUALTY LIMITED?

    Dirección de la sede social
    16 Eastcheap
    EC3M 1BD London
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de HOWDEN NORTH AMERICAN PROPERTY & CASUALTY LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    HEALTHCARE INTERNATIONAL INSURANCE AND REINSURANCE SERVICES LIMITED30 dic 199830 dic 1998
    COMPLETE MEDICAL SERVICES LIMITED03 dic 199803 dic 1998
    LAW 1001 LIMITED20 nov 199820 nov 1998

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de HOWDEN NORTH AMERICAN PROPERTY & CASUALTY LIMITED?

    Vencido
    Próximas cuentas
    Próximo período contable finaliza el30 sept 2016
    Próximas cuentas vencen el30 jun 2017
    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta30 sept 2015

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para HOWDEN NORTH AMERICAN PROPERTY & CASUALTY LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Cese del nombramiento de Peter David Smith como director el 30 nov 2016

    1 páginasTM01

    Declaración de confirmación presentada el 22 nov 2016 con actualizaciones

    6 páginasCS01

    Nombramiento de Andrew John Moore como secretario el 27 sept 2016

    2 páginasAP03

    Cese del nombramiento de Matt Blake como secretario el 27 sept 2016

    1 páginasTM02

    Estado de capital el 28 sept 2016

    • Capital: GBP 1
    3 páginasSH19

    legacy

    1 páginasSH20

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06

    Cancelación total de la carga 036710420004

    1 páginasMR04

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 sept 2015

    21 páginasAA

    Todo el bien o empresa ha sido liberado de la carga 036710420004

    1 páginasMR05

    Déclaration annuelle établie au 20 nov 2015 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital06 ene 2016

    Estado de capital el 06 ene 2016

    • Capital: GBP 10,000
    SH01

    Cese del nombramiento de Rinku Patel como director el 31 jul 2015

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Peter David Smith como director el 31 jul 2015

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Adrian Colosso como director el 31 jul 2015

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr Rinku Patel como director el 31 jul 2015

    2 páginasAP01

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 sept 2014

    19 páginasAA

    Registro de la carga 036710420004, creada el 29 abr 2015

    39 páginasMR01

    Cancelación total de la carga 036710420003

    4 páginasMR04

    Déclaration annuelle établie au 20 nov 2014 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital29 ene 2015

    Estado de capital el 29 ene 2015

    • Capital: GBP 10,000
    SH01

    Cese del nombramiento de Amanda Jane Emilia Massie como secretario el 01 may 2014

    1 páginasTM02

    Nombramiento de Mr Matt Blake como secretario el 01 may 2014

    2 páginasAP03

    ¿Quiénes son los directivos de HOWDEN NORTH AMERICAN PROPERTY & CASUALTY LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    MOORE, Andrew John
    Eastcheap
    EC3M 1BD London
    16
    Secretario
    Eastcheap
    EC3M 1BD London
    16
    215225290001
    PLUMMER, John
    Lamont Road
    SW10 OHL London
    8
    England
    England
    Director
    Lamont Road
    SW10 OHL London
    8
    England
    England
    UkBritish147124850003
    BLAKE, Matt
    Eastcheap
    EC3M 1BD London
    16
    Secretario
    Eastcheap
    EC3M 1BD London
    16
    192427440001
    MASSIE, Amanda Jane Emilia
    Eastcheap
    EC3M 1BD London
    16
    Secretario
    Eastcheap
    EC3M 1BD London
    16
    188836160001
    PALLOT, Hugh Glen
    143 Gresham Road
    TW18 2AG Staines
    Middlesex
    Secretario
    143 Gresham Road
    TW18 2AG Staines
    Middlesex
    British14485660002
    PIGRAM, Ivor
    93 Kingsfield Road
    Oxhey
    WD19 4TP Watford
    Hertfordshire
    Secretario
    93 Kingsfield Road
    Oxhey
    WD19 4TP Watford
    Hertfordshire
    British993440001
    TJG SECRETARIES LIMITED
    Carmelite
    50 Victoria Embankment Blackfriars
    EC4Y 0DX London
    Secretario corporativo
    Carmelite
    50 Victoria Embankment Blackfriars
    EC4Y 0DX London
    61729550001
    AHEDO, Francisco Jose
    Paseo Poseidon No 12
    Madrid 28220
    FOREIGN Spain
    Director
    Paseo Poseidon No 12
    Madrid 28220
    FOREIGN Spain
    SpainBritish125349900001
    BRAGOLI, Andrea
    57 Meadway
    Southgate
    N14 6NJ London
    Director
    57 Meadway
    Southgate
    N14 6NJ London
    British55145700001
    COLES, Timothy Crispin Fitzgerald
    Forest Grange
    RH13 6HX Horsham
    Hurstwood House
    West Sussex
    Director
    Forest Grange
    RH13 6HX Horsham
    Hurstwood House
    West Sussex
    EnglandBritish90464540003
    COLOSSO, Adrian
    Eastcheap
    EC3M 1BD London
    16
    Director
    Eastcheap
    EC3M 1BD London
    16
    EnglandBritish4555310002
    DAVIDOFF, Rony
    3 Hamelacha Street
    Tel Aviv
    67215
    Israel
    Director
    3 Hamelacha Street
    Tel Aviv
    67215
    Israel
    Israeli52788780007
    ELIAS, Richard Joseph Raymond
    24 Bevis Marks
    EC3A 7JB London
    Bevis Marks House
    United Kingdom
    Director
    24 Bevis Marks
    EC3A 7JB London
    Bevis Marks House
    United Kingdom
    EnglandBritish18192620002
    FARMER, Paul Robert
    10 Braintree Road
    CM8 2DD Witham
    Essex
    Director
    10 Braintree Road
    CM8 2DD Witham
    Essex
    United KingdomBritish46071820001
    HOWDEN, David Philip
    The Old Rectory
    Brill Road Ludgershall
    HP18 9PG Aylesbury
    Buckinghamshire
    Director
    The Old Rectory
    Brill Road Ludgershall
    HP18 9PG Aylesbury
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish75271140001
    KAREV, Eyal
    Apartment 10a 112 West 72nd Street
    New York
    New York 10023
    Usa
    Director
    Apartment 10a 112 West 72nd Street
    New York
    New York 10023
    Usa
    Israeli62908060001
    PATEL, Rinku
    Eastcheap
    EC3M 1BD London
    16
    Director
    Eastcheap
    EC3M 1BD London
    16
    EnglandBritish200346400001
    SMITH, Alan
    The Croft
    Green Lane Ardleigh
    CO7 7PB Colchester
    Essex
    Director
    The Croft
    Green Lane Ardleigh
    CO7 7PB Colchester
    Essex
    United KingdomBritish62859550001
    SMITH, Peter David
    Eastcheap
    EC3M 1BD London
    16
    Director
    Eastcheap
    EC3M 1BD London
    16
    United KingdomBritish201889340001
    WYLIE, Jacqueline
    Eastcheap
    EC3M 1BD London
    16
    United Kingdom
    Director
    Eastcheap
    EC3M 1BD London
    16
    United Kingdom
    United KingdomBritish106921840001
    HUNTSMOOR LIMITED
    Carmelite
    50 Victoria Embankment Blackfriars
    EC4Y 0DX London
    Director designado corporativo
    Carmelite
    50 Victoria Embankment Blackfriars
    EC4Y 0DX London
    900008150001
    HUNTSMOOR NOMINEES LIMITED
    Carmelite
    50 Victoria Embankment Blackfriars
    EC4Y 0DX London
    Director designado corporativo
    Carmelite
    50 Victoria Embankment Blackfriars
    EC4Y 0DX London
    900008160001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de HOWDEN NORTH AMERICAN PROPERTY & CASUALTY LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Eastcheap
    EC3M 1BD London
    16
    United Kingdom
    06 jun 2016
    Eastcheap
    EC3M 1BD London
    16
    United Kingdom
    No
    Forma jurídicaLimited By Shares
    País de registroUnited Kingdom
    Autoridad legalUnited Kingdom
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro06249799
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.

    ¿Tiene HOWDEN NORTH AMERICAN PROPERTY & CASUALTY LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    A registered charge
    Creado el 29 abr 2015
    Entregado el 07 may 2015
    Satisfecho en su totalidad
    Breve descripción
    All intellectual property, meaning any patent, trademarks, service marks, designs, business names, copyrights, database rights, etc. and the benefit of all applications and rights to use such assets of each chargor.
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Morgan Stanley Senior Funding, Inc
    Transacciones
    • 07 may 2015Registro de una carga (MR01)
    • 11 feb 2016Todo el bien o empresa ha sido liberado de la carga (MR05)
    • 12 jul 2016Satisfacción de una carga (MR04)
    A registered charge
    Creado el 17 oct 2013
    Entregado el 04 nov 2013
    Satisfecho en su totalidad
    Breve descripción
    Notification of addition to or amendment of charge.
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • J.P. Morgan Europe Limited (And Its Successors in Title, Permitted Assignees and Permitted Transferees)
    Transacciones
    • 04 nov 2013Registro de una carga (MR01)
    • 02 may 2015Satisfacción de una carga (MR04)
    Group debenture
    Creado el 31 may 2012
    Entregado el 08 jun 2012
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each present or future member of the group to the chargee and/or the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Hsbc Corporate Trustee Company (UK) Limited
    Transacciones
    • 08 jun 2012Registro de un cargo (MG01)
    • 18 oct 2013Satisfacción de una carga (MR04)
    Debenture
    Creado el 01 abr 2010
    Entregado el 14 abr 2010
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personas con derecho
    • Hsbc Bank PLC
    Transacciones
    • 14 abr 2010Registro de un cargo (MG01)
    • 11 jul 2012Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0