SOLARSOFT BUSINESS SYSTEMS LIMITED

SOLARSOFT BUSINESS SYSTEMS LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración anual
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaSOLARSOFT BUSINESS SYSTEMS LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 03674664
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de SOLARSOFT BUSINESS SYSTEMS LIMITED?

    • Desarrollo de software para negocios y hogares (62012) / Información y comunicación

    ¿Dónde se encuentra SOLARSOFT BUSINESS SYSTEMS LIMITED?

    Dirección de la sede social
    C/O Epicor Software Uk Limited No. 1 The Arena
    Downshire Way
    RG12 1PU Bracknell
    Berkshire
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de SOLARSOFT BUSINESS SYSTEMS LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    XKO SOFTWARE LIMITED03 abr 200003 abr 2000
    XKO (KSE COMPUTERS) LIMITED12 mar 199912 mar 1999
    XKO LIMITED24 dic 199824 dic 1998
    HILLGATE ( 12 ) LIMITED26 nov 199826 nov 1998

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de SOLARSOFT BUSINESS SYSTEMS LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta30 sept 2013

    ¿Cuál es el estado de la última declaración anual para SOLARSOFT BUSINESS SYSTEMS LIMITED?

    Declaración anual
    Última declaración anual

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para SOLARSOFT BUSINESS SYSTEMS LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    2 páginasDS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 sept 2013

    36 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 25 ene 2014 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital11 feb 2014

    Estado de capital el 11 feb 2014

    • Capital: GBP 500,006
    SH01

    Exercice comptable en cours prolongé du 31 mar 2013 au 30 sept 2013

    3 páginasAA01

    Nombramiento de Mr Richard John Clark como director el 06 jun 2013

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de John Charles Roy Brims como director el 06 jun 2013

    1 páginasTM01

    Domicilio social registrado cambiado de Solarsoft House Crockford Lane Hampshire Int Business Park Basingstoke Hampshire RG24 8WH United Kingdom el 24 abr 2013

    1 páginasAD01

    Nombramiento de Mr Yu-Ho Cheung como secretario el 28 feb 2013

    2 páginasAP03

    Déclaration annuelle établie au 25 ene 2013 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01

    Cambio de datos del director Mr Yu-Ho Cheung el 01 nov 2012

    2 páginasCH01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2012

    34 páginasAA

    Cese del nombramiento de Nicholas Kaiser como secretario el 12 oct 2012

    2 páginasTM02

    Cese del nombramiento de David Michael Mcgovern como director el 12 oct 2012

    2 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Shawn Allister Mcmorran como director el 12 oct 2012

    2 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Nicholas Kaiser como director el 12 oct 2012

    2 páginasTM01

    Nombramiento de John Charles Roy Brims como director el 12 oct 2012

    3 páginasAP01

    Nombramiento de John Ireland como director el 12 oct 2012

    3 páginasAP01

    Nombramiento de Mr Yu-Ho Cheung como director el 12 oct 2012

    3 páginasAP01

    legacy

    3 páginasMG02

    legacy

    3 páginasMG02

    legacy

    3 páginasMG02

    Déclaration annuelle établie au 25 ene 2012 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2011

    43 páginasAA

    ¿Quiénes son los directivos de SOLARSOFT BUSINESS SYSTEMS LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    CHEUNG, Yu-Ho
    The Arena
    Downshire Way
    RG12 1PU Bracknell
    No 1
    Berkshire
    England
    Secretario
    The Arena
    Downshire Way
    RG12 1PU Bracknell
    No 1
    Berkshire
    England
    176258770001
    CHEUNG, Yu-Ho, Mr.
    Downshire Way
    RG12 1PU Bracknell
    No 1 The Arena
    Berkshire
    United Kingdom
    Director
    Downshire Way
    RG12 1PU Bracknell
    No 1 The Arena
    Berkshire
    United Kingdom
    EnglandBritishSolicitor129862370004
    CLARK, Richard John
    The Arena
    Downshire Way
    RG12 1PU Bracknell
    No 1
    Berkshire
    England
    Director
    The Arena
    Downshire Way
    RG12 1PU Bracknell
    No 1
    Berkshire
    England
    EnglandBritishAccountant91263440001
    IRELAND, John David
    18101, Suite 1600
    Von Karman Ave
    Irvine
    California 92612
    United States
    Director
    18101, Suite 1600
    Von Karman Ave
    Irvine
    California 92612
    United States
    United StatesAmericanNone129773050001
    BEART, Simon Delaval
    43 Fentiman Road
    SW8 1LH London
    Secretario
    43 Fentiman Road
    SW8 1LH London
    British28376970001
    GOOD, Thomas William
    The Garden House
    Hatton Hill
    GU20 6AD Windlesham
    Surrey
    Secretario
    The Garden House
    Hatton Hill
    GU20 6AD Windlesham
    Surrey
    BritishFinance Director21310620009
    KAISER, Nicholas
    Reondo Beach
    California
    90278
    2111 Huntington Unit B
    Usa
    Secretario
    Reondo Beach
    California
    90278
    2111 Huntington Unit B
    Usa
    United StatesPrincipal169823340001
    KIMBER, Robert Charles
    8 Beauchamp Road
    KT8 0PA East Molesey
    Surrey
    Secretario
    8 Beauchamp Road
    KT8 0PA East Molesey
    Surrey
    BritishChartered Accountant39744090003
    SMITH, Andrew John
    Flat 2
    80 Woodside
    SW19 7QH Wimbledon
    London
    Secretario
    Flat 2
    80 Woodside
    SW19 7QH Wimbledon
    London
    BritishChartered Accountant65907810003
    HILLGATE SECRETARIAL LIMITED
    7th Floor Hillgate House
    26 Old Bailey
    EC4M 7HW London
    Secretario corporativo
    7th Floor Hillgate House
    26 Old Bailey
    EC4M 7HW London
    62127560001
    BEART, Simon Delaval
    63 Albert Bridge Road
    SW11 4QA London
    Director
    63 Albert Bridge Road
    SW11 4QA London
    EnglandBritishChartered Accountant28376970002
    BEVERLEY, Brian Craig
    Falcon House
    35 Regent Avenue
    FY8 4AG Lytham St. Annes
    Lancashire
    Director
    Falcon House
    35 Regent Avenue
    FY8 4AG Lytham St. Annes
    Lancashire
    BritishIt Consultant38805130002
    BLAXILL, Alistair John Charles
    Little Orchard
    Ash Green Road
    GU12 6JQ Ash Green
    Surrey
    Director
    Little Orchard
    Ash Green Road
    GU12 6JQ Ash Green
    Surrey
    BritishCompany Director72370340001
    BRIMS, John Charles Roy
    Downshire Way
    RG12 1PU Bracknell
    No 1 The Arena
    Berkshire
    United Kingdom
    Director
    Downshire Way
    RG12 1PU Bracknell
    No 1 The Arena
    Berkshire
    United Kingdom
    EnglandBritishAccountant72118430001
    EGLINTON, John Kenley
    13 Tovey Close
    London Colney
    AL2 1LF St Albans
    Hertfordshire
    Director
    13 Tovey Close
    London Colney
    AL2 1LF St Albans
    Hertfordshire
    BritishDirector77348740003
    GOOD, Thomas William
    The Garden House
    Hatton Hill
    GU20 6AD Windlesham
    Surrey
    Director
    The Garden House
    Hatton Hill
    GU20 6AD Windlesham
    Surrey
    United KingdomBritishFinance Director21310620009
    JEFFERY, Diana
    10 Gordon Close
    KT16 9PR Chertsey
    Surrey
    Director
    10 Gordon Close
    KT16 9PR Chertsey
    Surrey
    BritishAccountant79899870001
    KAISER, Nicholas
    Reondo Beach
    California
    90278
    2111 Huntington Unit B
    Usa
    Director
    Reondo Beach
    California
    90278
    2111 Huntington Unit B
    Usa
    UsaUnited StatesPrincipal169823340001
    KIMBER, Robert Charles
    8 Beauchamp Road
    KT8 0PA East Molesey
    Surrey
    Director
    8 Beauchamp Road
    KT8 0PA East Molesey
    Surrey
    United KingdomBritishChartered Accountant39744090003
    KIRKWOOD, Ian David
    Farthings
    Hillside Road
    LU7 8BU Leighton Buzzard
    Bedfordshire
    Director
    Farthings
    Hillside Road
    LU7 8BU Leighton Buzzard
    Bedfordshire
    BritishSales Director67887240001
    MCGOVERN, David Michael
    631 14th Street
    Manhattan Street
    California 90266
    United States Of America
    Director
    631 14th Street
    Manhattan Street
    California 90266
    United States Of America
    United StatesManaging Director98063980001
    MCMORRAN, Shawn Allister
    Lintotts
    Gay Street
    RH20 2HH West Chiltington
    West Sussex
    Director
    Lintotts
    Gay Street
    RH20 2HH West Chiltington
    West Sussex
    United KingdomCanadianBusiness Consultant88147450003
    SARGEANT, David Ian
    Mcalmont Ridge Huxley Close
    GU7 2AR Godalming
    Surrey
    Director
    Mcalmont Ridge Huxley Close
    GU7 2AR Godalming
    Surrey
    United KingdomBritishDirector27857670004
    SAWYER, Lars
    115 Northey Avenue
    SM2 7HQ Sutton
    Surrey
    Director
    115 Northey Avenue
    SM2 7HQ Sutton
    Surrey
    United KingdomBritishCompany Director108539630001
    SCHAFER, Christopher Ian
    11 Osborne Road
    RG40 1TL Wokingham
    Berkshire
    Director
    11 Osborne Road
    RG40 1TL Wokingham
    Berkshire
    BritishSales Director67887290002
    SMITH, Andrew John
    Flat 2
    80 Woodside
    SW19 7QH Wimbledon
    London
    Director
    Flat 2
    80 Woodside
    SW19 7QH Wimbledon
    London
    BritishChartered Accountant65907810003
    SYMONS, John Richard
    3 Grosvenor Court
    Blackwater
    GU17 9JL Camberley
    Surrey
    Director
    3 Grosvenor Court
    Blackwater
    GU17 9JL Camberley
    Surrey
    BritishDirector9591160004
    WEGUELIN, Christopher John
    36 Gaskell Close
    Holybourne
    GU34 4HE Alton
    Hampshire
    Director
    36 Gaskell Close
    Holybourne
    GU34 4HE Alton
    Hampshire
    BritishDirector67887270001
    HILLGATE NOMINEES LIMITED
    7th Floor
    26 Old Bailey
    EC4M 7HW London
    Director corporativo
    7th Floor
    26 Old Bailey
    EC4M 7HW London
    87692860001
    HILLGATE SECRETARIAL LIMITED
    7th Floor Hillgate House
    26 Old Bailey
    EC4M 7HW London
    Director corporativo
    7th Floor Hillgate House
    26 Old Bailey
    EC4M 7HW London
    62127560001

    ¿Tiene SOLARSOFT BUSINESS SYSTEMS LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Debenture
    Creado el 08 jul 2011
    Entregado el 26 jul 2011
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the obligors to the finance parties; all bank product obligations; and all obligations of each borrower under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Tpg Specialty Lending, Inc.
    Transacciones
    • 26 jul 2011Registro de un cargo (MG01)
    • 23 nov 2012Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Debenture
    Creado el 23 ene 2008
    Entregado el 07 feb 2008
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the obligors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • D.B.Zwirn Special Opportunities Fund L.P as Administrative Agent and Trustee for the Financeparties (The Agent)
    Transacciones
    • 07 feb 2008Registro de un cargo (395)
    • 23 feb 2012Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Debenture
    Creado el 22 mar 2007
    Entregado el 04 abr 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the obligors and each borrower to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Wells Fargo Foothill,Inc as Trustee and Administrative Agent for the Finance Parties
    Transacciones
    • 04 abr 2007Registro de un cargo (395)
    • 03 abr 2012Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Accession deed
    Creado el 06 dic 2006
    Entregado el 15 dic 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from any chargor to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Capitalsource Finance Llc
    Transacciones
    • 15 dic 2006Registro de un cargo (395)
    • 08 feb 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 05 sept 2005
    Entregado el 09 sept 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 09 sept 2005Registro de un cargo (395)
    • 21 oct 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture amendment deed amending a debenture dated 30 april 1999
    Creado el 01 dic 2004
    Entregado el 04 dic 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 04 dic 2004Registro de un cargo (395)
    • 17 sept 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Charge of securities (UK)
    Creado el 01 dic 2004
    Entregado el 04 dic 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    By way of fixed charge any stocks shares bonds warrants or securities (certified or uncertified) together with all income derived from and rights attaching the same.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 04 dic 2004Registro de un cargo (395)
    • 17 sept 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture amendment deed
    Creado el 16 ene 2004
    Entregado el 03 feb 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 03 feb 2004Registro de un cargo (395)
    • 17 sept 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Rent deposit deed
    Creado el 02 nov 2000
    Entregado el 07 nov 2000
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the provisions of a lease dated 2ND november 2000
    Breve descripción
    The sum of £18,379.64 deposited with the mortgagees solicitors.
    Personas con derecho
    • Astrex Limited
    Transacciones
    • 07 nov 2000Registro de un cargo (395)
    • 21 oct 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 02 mar 1999
    Entregado el 15 mar 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 15 mar 1999Registro de un cargo (395)
    • 17 sept 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0