TIDE6 LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración anual
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaTIDE6 LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 03698167
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de TIDE6 LIMITED?

    • Actividades de consultoría en tecnología de la información (62020) / Información y comunicación

    ¿Dónde se encuentra TIDE6 LIMITED?

    Dirección de la sede social
    8 Princes Parade
    L3 1QH Liverpool
    Merseyside
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de TIDE6 LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    INTUITA LIMITED31 may 200131 may 2001
    ANITE B2B LIMITED29 mar 200029 mar 2000
    ANITE MANUFACTURING & DISTRIBUTION SYSTEMS LIMITED20 ene 199920 ene 1999

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de TIDE6 LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta30 sept 2014

    ¿Cuál es el estado de la última declaración anual para TIDE6 LIMITED?

    Declaración anual
    Última declaración anual

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para TIDE6 LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros

    6 páginas4.71

    Déclaration annuelle établie au 20 ene 2016 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital17 feb 2016

    Estado de capital el 17 feb 2016

    • Capital: GBP 1,000,002
    SH01

    Domicilio social registrado cambiado de North Park Newcastle upon Tyne Tyne & Wear NE13 9AA a 8 Princes Parade Liverpool Merseyside L3 1QH el 30 jul 2015

    2 páginasAD01

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    2 páginas600

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo especial para la liquidación el 13 jul 2015

    LRESSP

    Declaración de solvencia

    5 páginas4.70

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06
    capital

    Resoluciones

    Cancel capital contribution reserve 22/06/2015
    RES13

    legacy

    1 páginasSH20

    Estado de capital el 24 jun 2015

    • Capital: GBP 1
    4 páginasSH19

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Nombramiento de Mr Mark Parry como director el 18 jun 2015

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Alastair John Mitchell como director el 18 jun 2015

    1 páginasTM01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 sept 2014

    6 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 20 ene 2015 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital20 ene 2015

    Estado de capital el 20 ene 2015

    • Capital: GBP 1,000,002
    SH01

    Nombramiento de Mr Mark Parry como secretario el 31 jul 2014

    2 páginasAP03

    Cese del nombramiento de Louise Hall como secretario el 31 jul 2014

    1 páginasTM02

    Déclaration annuelle établie au 20 ene 2014 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital06 feb 2014

    Estado de capital el 06 feb 2014

    • Capital: GBP 1,000,002
    SH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 sept 2013

    5 páginasAA

    Certificado de cambio de nombre

    Company name changed intuita LIMITED\certificate issued on 16/05/13
    2 páginasCERTNM
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    change-of-name16 may 2013

    Resolución de cambio de nombre de la empresa el 30 abr 2013

    RES15

    Aviso de cambio de nombre

    2 páginasCONNOT

    Déclaration annuelle établie au 20 ene 2013 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 sept 2012

    6 páginasAA

    Nombramiento de Brendan Peter Flattery como director

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Adrienne Mcfarland como director

    1 páginasTM01

    ¿Quiénes son los directivos de TIDE6 LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    PARRY, Mark
    Princes Parade
    L3 1QH Liverpool
    8
    Merseyside
    Secretario
    Princes Parade
    L3 1QH Liverpool
    8
    Merseyside
    190492240001
    FLATTERY, Brendan Peter
    Princes Parade
    L3 1QH Liverpool
    8
    Merseyside
    Director
    Princes Parade
    L3 1QH Liverpool
    8
    Merseyside
    United KingdomBritishManaging Director168203410001
    PARRY, Mark
    Princes Parade
    L3 1QH Liverpool
    8
    Merseyside
    Director
    Princes Parade
    L3 1QH Liverpool
    8
    Merseyside
    United KingdomBritishSolicitor198658460001
    DANIEL, Lisa Katherine
    17 Arliss Avenue
    Levenshulme
    M19 2PD Manchester
    Secretario
    17 Arliss Avenue
    Levenshulme
    M19 2PD Manchester
    British75220310001
    HALL, Louise
    Beechgrove
    Acklington
    NE65 9BY Morpeth
    Northumberland
    Secretario
    Beechgrove
    Acklington
    NE65 9BY Morpeth
    Northumberland
    BritishCompany Secretary77212940004
    HEMMING, Vivienne Ruth
    25 Saint Johns Road
    OX10 9AW Wallingford
    Oxon
    Secretario
    25 Saint Johns Road
    OX10 9AW Wallingford
    Oxon
    British41962390006
    MERCER, Jane
    2 Corner Brook
    Lostock
    BL6 4GX Bolton
    Lancashire
    Secretario
    2 Corner Brook
    Lostock
    BL6 4GX Bolton
    Lancashire
    BritishSecretary109573410001
    PHILLIPS, David Alan
    16 Ryhill Way
    Lower Earley
    RG6 4AZ Reading
    Berkshire
    Secretario
    16 Ryhill Way
    Lower Earley
    RG6 4AZ Reading
    Berkshire
    BritishAccountant54616920001
    WENMAN, Nicholas Edward
    Weston Lodge
    The Street
    GU5 9AE Albury
    Surrey
    Secretario
    Weston Lodge
    The Street
    GU5 9AE Albury
    Surrey
    BritishDirector76556460002
    HALLMARK SECRETARIES LIMITED
    120 East Road
    N1 6AA London
    Secretario designado corporativo
    120 East Road
    N1 6AA London
    900004100001
    BEATON, Richard L'Estrange
    Prestbury Hall
    The Village
    SK10 4BN Prestbury
    Cheshire
    Director
    Prestbury Hall
    The Village
    SK10 4BN Prestbury
    Cheshire
    EnglandBritishCompany Director97291590001
    BYRNE, Kevin Barry
    23 Corkland Road
    M21 8UP Manchester
    Lancashire
    Director
    23 Corkland Road
    M21 8UP Manchester
    Lancashire
    BritishManager76778240001
    HAWKINS, John Eric
    Craven House
    Hamstead Marshall
    RG20 0JG Newbury
    Berkshire
    Director
    Craven House
    Hamstead Marshall
    RG20 0JG Newbury
    Berkshire
    EnglandBritishChief Executive53688120001
    HUNT, Simon Anthony
    Apt 31 21 Sheldon Square
    Paddington Central
    W2 6DS London
    Director
    Apt 31 21 Sheldon Square
    Paddington Central
    W2 6DS London
    BritishChartered Accountant118771650001
    MAY, Gavin Disney
    North Park Avenue
    NE13 9AA Newcastle Upon Tyne
    Tyne And Wear
    Director
    North Park Avenue
    NE13 9AA Newcastle Upon Tyne
    Tyne And Wear
    EnglandBritishDirector85874690001
    MCFARLAND, Adrienne Ann
    Park
    NE13 9AA Newcastle Upon Tyne
    North
    Tyne & Wear
    England
    Director
    Park
    NE13 9AA Newcastle Upon Tyne
    North
    Tyne & Wear
    England
    United KingdomBritishHuman Resources Director125854290002
    MITCHELL, Alastair John
    Park
    NE13 9AA Newcastle Upon Tyne
    North
    Tyne & Wear
    England
    Director
    Park
    NE13 9AA Newcastle Upon Tyne
    North
    Tyne & Wear
    England
    United KingdomBritishDirector79762180002
    PHILLIPS, David Alan
    16 Ryhill Way
    Lower Earley
    RG6 4AZ Reading
    Berkshire
    Director
    16 Ryhill Way
    Lower Earley
    RG6 4AZ Reading
    Berkshire
    BritishAccountant54616920001
    STOBART, Paul Lancelot
    North Park Avenue
    NE13 9AA Newcastle Upon Tyne
    Tyne And Wear
    Director
    North Park Avenue
    NE13 9AA Newcastle Upon Tyne
    Tyne And Wear
    EnglandBritishDirector175694060001
    WENMAN, Nicholas Edward
    Weston Lodge
    The Street
    GU5 9AE Albury
    Surrey
    Director
    Weston Lodge
    The Street
    GU5 9AE Albury
    Surrey
    EnglandBritishDirector76556460002
    HALLMARK REGISTRARS LIMITED
    120 East Road
    N1 6AA London
    Director designado corporativo
    120 East Road
    N1 6AA London
    900004090001

    ¿Tiene TIDE6 LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Composite guarantee and debenture
    Creado el 22 dic 2006
    Entregado el 10 ene 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and each other charging company and any other present or future subsidiary of the parent or of any charging company to the secured parties or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Inflexion Private Equity Partners LLP (Security Trustee)
    Transacciones
    • 10 ene 2007Registro de un cargo (395)
    • 30 abr 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Creado el 22 dic 2006
    Entregado el 06 ene 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company, each guarantor to the secured parties or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Richard Beaton (Security Trustee)
    Transacciones
    • 06 ene 2007Registro de un cargo (395)
    • 30 abr 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Creado el 22 dic 2006
    Entregado el 06 ene 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the charging company, each guarantor to the secured parties or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Jane Mercer (Sercurity Trustee)
    Transacciones
    • 06 ene 2007Registro de un cargo (395)
    • 30 abr 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 22 dic 2006
    Entregado el 29 dic 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Hsbc Bank PLC
    Transacciones
    • 29 dic 2006Registro de un cargo (395)
    • 30 abr 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Collateral debenture
    Creado el 21 dic 2005
    Entregado el 10 ene 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company intuita software limited and evision limited to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Yfm Private Equity Limited
    Transacciones
    • 10 ene 2006Registro de un cargo (395)
    • 18 ene 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 07 dic 2005
    Entregado el 17 dic 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 17 dic 2005Registro de un cargo (395)
    • 18 ene 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    An omnibus guarantee and set-off agreement dated 29 june 2005
    Creado el 29 jun 2005
    Entregado el 08 jul 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of present or future accounts of the companies or any of them with the bank whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 08 jul 2005Registro de un cargo (395)
    • 09 dic 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    An omnibus guarantee and set-off agreement
    Creado el 16 jun 2005
    Entregado el 18 jun 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Any sums or sums standing to the credit if any one or more of any present of future accounts of the company with the bank whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 18 jun 2005Registro de un cargo (395)
    • 09 dic 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Deposit agreement to secure own liabilities
    Creado el 16 jun 2005
    Entregado el 18 jun 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    All such rights to the repayment of the deposit meaning the debt(s) on the account(s) described in the schedule being the account with the bank denominated in sterling designated lloyds tsb bank PLC re intuita limited and numbered 06614212 and any account(s) for the time being replacing the same and all interest owing in respect thereof and all deposits with the banks treasury division in the name of the bank re the company.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 18 jun 2005Registro de un cargo (395)
    • 09 dic 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture deed
    Creado el 01 nov 2004
    Entregado el 04 nov 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 04 nov 2004Registro de un cargo (395)
    • 09 dic 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Fixed and floating security document
    Creado el 08 dic 2000
    Entregado el 21 dic 2000
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All present and future moneys debts and liabilities due owing or incurred by the company to any finance party under or in connection with any finance document (in each case whether alone or jointly or jointly or severally with any other person whether actually or contingently and whether as principal surety or otherwise)
    Breve descripción
    The property as described in the schedule attached to the form 395 all other real property all book debts bank accounts investments uncalled capital and goodwill intellectual property plant and machinery insurances please refer to form 395 for full details.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 21 dic 2000Registro de un cargo (395)
    • 23 may 2001Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Deed of amendment and restatement (for amending and restating a guarantee & debenture dated 6 october 1995)
    Creado el 09 abr 1999
    Entregado el 21 abr 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Lloyds Bank PLC
    Transacciones
    • 21 abr 1999Registro de un cargo (395)
    • 10 abr 2001Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    ¿Tiene TIDE6 LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    07 jun 2016Fecha de disolución
    13 jul 2015Inicio de la liquidación
    Liquidación voluntaria de socios
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    John David Thomas Milsom
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Profesional
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Brian Green
    8 Princes Parade
    L3 1QH Liverpool
    Profesional
    8 Princes Parade
    L3 1QH Liverpool

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0