NPS (UK7) LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaNPS (UK7) LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 03698175
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de NPS (UK7) LIMITED?

    • Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra NPS (UK7) LIMITED?

    Dirección de la sede social
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de NPS (UK7) LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    NORTHGATE GOVERNMENT SYSTEMS LIMITED09 ene 200909 ene 2009
    ANITE GOVERNMENT SYSTEMS LIMITED20 ene 199920 ene 1999

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de NPS (UK7) LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta30 abr 2018

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para NPS (UK7) LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros

    6 páginasLIQ13

    Domicilio social registrado cambiado de Peoplebuilding 2 Peoplebuilding Estate Maylands Avenue Hemel Hempstead Hertfordshire HP2 4NW a 15 Canada Square London E14 5GL el 03 may 2019

    2 páginasAD01

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    3 páginas600

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo especial para la liquidación el 03 abr 2019

    LRESSP

    Declaración de solvencia

    5 páginasLIQ01

    Declaración de confirmación presentada el 20 ene 2019 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    Cuentas de microempresa preparadas hasta el 30 abr 2018

    2 páginasAA

    Exercice comptable en cours raccourci du 30 abr 2019 au 31 mar 2019

    1 páginasAA01

    Cese del nombramiento de Ian Michael Noble como director el 06 ago 2018

    1 páginasTM01

    Cambio de datos del director Mr Stephen James Callaghan el 06 ago 2018

    2 páginasCH01

    Cuentas no auditadas abreviadas presentadas hasta el 30 abr 2017

    7 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 20 ene 2018 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    Declaración de confirmación presentada el 20 ene 2017 con actualizaciones

    5 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 abr 2016

    4 páginasAA

    Cese del nombramiento de Andrew Coll como director el 06 dic 2016

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Ian Michael Noble como director el 06 dic 2016

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr Stephen James Callaghan como director el 10 oct 2016

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de David John Meaden como director el 10 oct 2016

    1 páginasTM01

    Déclaration annuelle établie au 20 ene 2016 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital18 feb 2016

    Estado de capital el 18 feb 2016

    • Capital: GBP 4,500,002
    SH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 abr 2015

    4 páginasAA

    Certificado de cambio de nombre

    Company name changed northgate government systems LIMITED\certificate issued on 16/06/15
    3 páginasCERTNM
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    change-of-name16 jun 2015

    Cambio de nombre por resolución

    NM01
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    change-of-name

    Resolución de cambio de nombre de la empresa el 09 jun 2015

    RES15

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 abr 2014

    4 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 20 ene 2015 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital28 ene 2015

    Estado de capital el 28 ene 2015

    • Capital: GBP 4,500,002
    SH01

    Nombramiento de David John Meaden como director el 22 dic 2014

    2 páginasAP01

    ¿Quiénes son los directivos de NPS (UK7) LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    PINSENT MASONS SECRETARIAL LIMITED
    Park Row
    LS1 5AB Leeds
    1
    United Kingdom
    Secretario corporativo
    Park Row
    LS1 5AB Leeds
    1
    United Kingdom
    Tipo de identificaciónEEE
    Número de registro2318923
    76579530001
    CALLAGHAN, Stephen James
    Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Director
    Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish201347710052
    COUTTS, Cheryl Jane
    6 Esmond Road
    W4 1JQ Chiswick
    London
    Secretario
    6 Esmond Road
    W4 1JQ Chiswick
    London
    British12016130002
    COX, Melanie Rachel
    1 The Green
    Bisham
    SL7 1RY Marlow
    Buckinghamshire
    Secretario
    1 The Green
    Bisham
    SL7 1RY Marlow
    Buckinghamshire
    British96139050001
    HEMMING, Vivienne Ruth
    25 Saint Johns Road
    OX10 9AW Wallingford
    Oxon
    Secretario
    25 Saint Johns Road
    OX10 9AW Wallingford
    Oxon
    British41962390006
    HUMPHREY, Christopher John
    Well House
    School Lane, Northend
    BA1 7EP Bath
    Somerset
    Secretario
    Well House
    School Lane, Northend
    BA1 7EP Bath
    Somerset
    British32877720003
    PHILLIPS, David Alan
    16 Ryhill Way
    Lower Earley
    RG6 4AZ Reading
    Berkshire
    Secretario
    16 Ryhill Way
    Lower Earley
    RG6 4AZ Reading
    Berkshire
    British54616920001
    RICHARDSON, John David
    Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    Secretario
    Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    British128558470001
    SADLER, John Michael
    14 Highlands Close
    SL9 0DR Chalfont St Peter
    Buckinghamshire
    Secretario
    14 Highlands Close
    SL9 0DR Chalfont St Peter
    Buckinghamshire
    British78431540001
    SCHENCK, Daniel William
    Peoplebuilding 2, Peoplebuilding Estate
    Marylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    3rd Floor
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Secretario
    Peoplebuilding 2, Peoplebuilding Estate
    Marylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    3rd Floor
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Usa181204960001
    HALLMARK SECRETARIES LIMITED
    120 East Road
    N1 6AA London
    Secretario designado corporativo
    120 East Road
    N1 6AA London
    900004100001
    AL-SALEH, Adel Bedry
    Peoplebuilding 2, Peoplebuilding Estate
    Marylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    3rd Floor
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Director
    Peoplebuilding 2, Peoplebuilding Estate
    Marylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    3rd Floor
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United StatesAmerican165900220001
    BASS, Neil Anthony
    31 Archery Fields
    RG29 1AE Odiham
    Hampshire
    Director
    31 Archery Fields
    RG29 1AE Odiham
    Hampshire
    EnglandBritish70199330002
    BODHA, James Sanjay
    Rook How
    22 Elm Tree Road
    WA13 0NB Lymm
    Cheshire
    Director
    Rook How
    22 Elm Tree Road
    WA13 0NB Lymm
    Cheshire
    EnglandBritish93657140001
    CARTER, Bernard
    Acorns
    Oaklea Drive, Eversley
    RG27 0QZ Hook
    Hampshire
    Director
    Acorns
    Oaklea Drive, Eversley
    RG27 0QZ Hook
    Hampshire
    British63565990001
    COLL, Andrew
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Director
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    EnglandBritish237260100001
    GIBSON, John Leonard
    Ivydene
    Delly End
    OX29 9XD Hailey
    Oxfordshire
    Director
    Ivydene
    Delly End
    OX29 9XD Hailey
    Oxfordshire
    British104554430001
    HAWKINS, John Eric
    Craven House
    Hamstead Marshall
    RG20 0JG Newbury
    Berkshire
    Director
    Craven House
    Hamstead Marshall
    RG20 0JG Newbury
    Berkshire
    EnglandBritish53688120001
    HUMPHREY, Christopher John
    Well House
    School Lane, Northend
    BA1 7EP Bath
    Somerset
    Director
    Well House
    School Lane, Northend
    BA1 7EP Bath
    Somerset
    United KingdomBritish32877720003
    HUNT, Simon Anthony
    Apt 31 21 Sheldon Square
    Paddington Central
    W2 6DS London
    Director
    Apt 31 21 Sheldon Square
    Paddington Central
    W2 6DS London
    British118771650001
    MCCANN, James
    32 Carter Close
    SL4 3QX Windsor
    Berkshire
    Director
    32 Carter Close
    SL4 3QX Windsor
    Berkshire
    British69923680001
    MCINTYRE, Neil, Dr
    Pant Yr Eos Farm
    Henllys
    NP44 7AS Cwmbran
    Gwent
    Director
    Pant Yr Eos Farm
    Henllys
    NP44 7AS Cwmbran
    Gwent
    British63566030002
    MEADEN, David John
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Director
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish193740420001
    NOBLE, Ian Michael
    Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Director
    Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    EnglandBritish199843940001
    PHILLIPS, David Alan
    16 Ryhill Way
    Lower Earley
    RG6 4AZ Reading
    Berkshire
    Director
    16 Ryhill Way
    Lower Earley
    RG6 4AZ Reading
    Berkshire
    British54616920001
    ROWLEY, Stephen Paul, Mr.
    Hadleigh 16 Sandown Road
    KT10 9TU Esher
    Surrey
    Director
    Hadleigh 16 Sandown Road
    KT10 9TU Esher
    Surrey
    United KingdomBritish93738770001
    SLOGGETT, David Raymond, Dr
    12 Mcnaughton Close
    GU14 0PX Farnborough
    Hampshire
    Director
    12 Mcnaughton Close
    GU14 0PX Farnborough
    Hampshire
    British34112730001
    STIER, John Robert
    Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Director
    Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish78901530003
    STONE, Christopher Michael Renwick
    Peoplebuilding 2, Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    Director
    Peoplebuilding 2, Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    United KingdomBritish66955690003
    TAIT, Ian
    Field House
    Evesham Road
    WR10 2QR Fladbury
    Worcestershire
    Director
    Field House
    Evesham Road
    WR10 2QR Fladbury
    Worcestershire
    United KingdomBritish76976490001
    THORPE, David Allan
    Bobble Barn Farmhouse
    GL54 2ND Little Rissington
    Gloucestershire
    Director
    Bobble Barn Farmhouse
    GL54 2ND Little Rissington
    Gloucestershire
    United KingdomBritish77702540001
    TYRRELL, Simon Robert Edgar
    Larks
    15 Burstead Close
    KT11 2NL Cobham
    Surrey
    Director
    Larks
    15 Burstead Close
    KT11 2NL Cobham
    Surrey
    EnglandBritish77284710002
    HALLMARK REGISTRARS LIMITED
    120 East Road
    N1 6AA London
    Director designado corporativo
    120 East Road
    N1 6AA London
    900004090001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de NPS (UK7) LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    06 abr 2016
    Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    No
    Forma jurídicaLimited By Shares
    País de registroEngland And Wales
    Autoridad legalUnited Kingdom (England And Wales)
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro03495019
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.

    ¿Tiene NPS (UK7) LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    A deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 28 november 2006
    Creado el 16 feb 2007
    Entregado el 01 mar 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Any sum or sums from time to time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name (s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 01 mar 2007Registro de un cargo (395)
    • 31 oct 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    A deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 28 november 2006
    Creado el 15 feb 2007
    Entregado el 01 mar 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Any sum or sums from time to time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name (s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 01 mar 2007Registro de un cargo (395)
    • 31 oct 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Omnibus guarantee and set-off agreement
    Creado el 28 nov 2006
    Entregado el 30 nov 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Any sum or sums standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 30 nov 2006Registro de un cargo (395)
    • 31 oct 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    A deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 9TH december 2002
    Creado el 28 feb 2006
    Entregado el 02 mar 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Any sum or sums from time to time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name (s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 02 mar 2006Registro de un cargo (395)
    • 31 oct 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    An omnibus letter of set-off
    Creado el 09 dic 2002
    Entregado el 13 dic 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 13 dic 2002Registro de un cargo (395)
    • 31 oct 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Fixed and floating security document
    Creado el 10 may 2002
    Entregado el 24 may 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All moneys,debts and liabilities due or to become due from the company to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC,as Security Trustee for the Finance Parties
    Transacciones
    • 24 may 2002Registro de un cargo (395)
    • 04 jul 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Fixed and floating security document
    Creado el 08 dic 2000
    Entregado el 21 dic 2000
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All present and future moneys debts and liabilities due owing or incurred by the company to any finance party under or in connection with any finance document (in each case whether alone or jointly or jointly or severally with any other person whether actually or contingently and whether as principal surety or otherwise)
    Breve descripción
    The property as described in the schedule attached to the form 395 all other real property all book debts bank accounts investments uncalled capital and goodwill intellectual property plant and machinery insurances please refer to form 395 for full details.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 21 dic 2000Registro de un cargo (395)
    • 23 may 2001Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Deed of amendment and restatement (for amending and restating a guarantee & debenture dated 6 october 1995)
    Creado el 09 abr 1999
    Entregado el 21 abr 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Lloyds Bank PLC
    Transacciones
    • 21 abr 1999Registro de un cargo (395)
    • 10 abr 2001Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    ¿Tiene NPS (UK7) LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    03 abr 2019Inicio de la liquidación
    01 feb 2020Fecha de disolución
    Liquidación voluntaria de socios
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Nicholas James Timpson
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Profesional
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Mark Jeremy Orton
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Profesional
    15 Canada Square
    E14 5GL London

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0