PHILLIPS 66 EUROPEAN POWER LIMITED
Visión general
Nombre de la empresa | PHILLIPS 66 EUROPEAN POWER LIMITED |
---|---|
Estado de la empresa | Disuelta |
Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
Número de empresa | 03714490 |
Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
Fecha de constitución | |
Fecha de cese |
Resumen
Tiene PSCs súper seguros | No |
---|---|
Tiene gravámenes | Sí |
Tiene historial de insolvencia | No |
La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de PHILLIPS 66 EUROPEAN POWER LIMITED?
- Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas
¿Dónde se encuentra PHILLIPS 66 EUROPEAN POWER LIMITED?
Dirección de la sede social | 7th Floor 200-202 Aldersgate Street EC1A 4HD London |
---|---|
Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de PHILLIPS 66 EUROPEAN POWER LIMITED?
Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
---|---|---|
CONOCOPHILLIPS EUROPEAN POWER LIMITED | 21 nov 2002 | 21 nov 2002 |
CONOCO GLOBAL POWER EUROPE LIMITED | 19 mar 1999 | 19 mar 1999 |
PROOFALLIED LIMITED | 17 feb 1999 | 17 feb 1999 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de PHILLIPS 66 EUROPEAN POWER LIMITED?
Últimas cuentas | |
---|---|
Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2021 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para PHILLIPS 66 EUROPEAN POWER LIMITED?
Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||
La acción de exclusión voluntaria ha sido suspendida | 1 páginas | SOAS(A) | ||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 2 páginas | DS01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 07 nov 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2021 | 4 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 07 nov 2021 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Segunda presentación para el nombramiento de Mr Gary Stuart Taylor como director | 3 páginas | RP04AP01 | ||
legacy | páginas | ANNOTATION | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2020 | 4 páginas | AA | ||
Cambio de datos del director Gary Stuart Taylor el 01 ene 2018 | 2 páginas | CH01 | ||
Cambio de datos del director Mr. Neal Andrew Holland el 01 ene 2018 | 2 páginas | CH01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2019 | 5 páginas | AA | ||
Nombramiento de Mrs Nina Elizabeth Mcknight como director el 18 nov 2020 | 2 páginas | AP01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 07 nov 2020 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 07 nov 2019 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2018 | 18 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 07 nov 2018 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||
Nombramiento de Anna Janaszek como secretario el 31 oct 2018 | 2 páginas | AP03 | ||
Cese del nombramiento de Michelle Ann Dunne como secretario el 31 oct 2018 | 1 páginas | TM02 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2017 | 18 páginas | AA | ||
Nombramiento de Leslie Leroy Jenkins como director el 31 ago 2018 | 2 páginas | AP01 | ||
Cessation de Phillips 66 Development Holdings Ltd. en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 31 jul 2018 | 1 páginas | PSC07 | ||
Notification de Phillips 66 Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 31 jul 2018 | 2 páginas | PSC02 | ||
Cese del nombramiento de Michael John Lambert como director el 31 ago 2018 | 1 páginas | TM01 | ||
¿Quiénes son los directivos de PHILLIPS 66 EUROPEAN POWER LIMITED?
Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GENNINGS, Sarah | Secretario | 200-202 Aldersgate Street EC1A 4HD London 7th Floor | 242493730001 | |||||||
JANASZEK, Anna | Secretario | 200-202 Aldersgate Street EC1A 4HD London 7th Floor | 252165470001 | |||||||
WHITE, Ruth Maretta | Secretario | Portman House 2 Portman Street W1H 6DU London Portman House England | British | 77348470004 | ||||||
HOLLAND, Neal Andrew, Mr. | Director | 200-202 Aldersgate Street EC1A 4HD London 7th Floor | United Kingdom | British | Manager, Accounting | 214757150001 | ||||
JENKINS, Leslie Leroy | Director | 200-202 Aldersgate Street EC1A 4HD London 7th Floor | United Kingdom | American | Manager, Finance | 250318200001 | ||||
MCKNIGHT, Nina Elizabeth | Director | 200-202 Aldersgate Street EC1A 4HD London 7th Floor | England | British | Finance Manager | 276688540001 | ||||
TAYLOR, Gary Stuart | Director | 200-202 Aldersgate Street EC1A 4HD London 7th Floor | England | British | Tax And Treasury Manager | 288343630001 | ||||
COLLINS, Derryl Lynn | Secretario | 18 Montagu Court 27-29 Montagu Square W1H 1RE London | British | 60921910004 | ||||||
COOK, Thomas Edward | Secretario | Kinross 3 Manor Lane SL9 9NH Gerrards Cross Buckinghamshire | American | Lawyer | 85934540001 | |||||
DUNNE, Michelle Ann | Secretario | 200-202 Aldersgate Street EC1A 4HD London 7th Floor | 190659530001 | |||||||
EDWARDS, Christopher James | Secretario | 39 Blandford Road W4 1DX London | British | 60806320002 | ||||||
STIRRUP, Edith Jeannie | Secretario | 200-202 Aldersgate Street EC1A 4HD London 7th Floor England | Other | 92055740001 | ||||||
SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Secretario designado corporativo | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||
ARMISTEAD, George Huvelle | Director | Portman House 2 Portman Street W1H 6DU London | England | United States | Business Development Manager | 102324360002 | ||||
BLAKEMORE, David Robert | Director | 200-202 Aldersgate Street EC1A 4HD London 7th Floor England | England | British | Manager Administrative Services | 150290970001 | ||||
BRIGNALL, David | Director | 2 Portman Street W1H 6DU London Portman House England | England | British | Ichp Manager | 279126920001 | ||||
COLLINS, Derryl Lynn | Director | 18 Montagu Court 27-29 Montagu Square W1H 1RE London | British | Lawyer | 60921910004 | |||||
COOK, Thomas Edward | Director | Kinross 3 Manor Lane SL9 9NH Gerrards Cross Buckinghamshire | American | Lawyer | 85934540001 | |||||
DAVIDSON, John Esson | Director | 200-202 Aldersgate Street EC1A 4HD London 7th Floor | England | British | Manager, Business Development | 196485140001 | ||||
GALBRAITH, John Peter | Director | 22 Hacketts Lane GU22 8PP Woking Surrey | British | Business Executive | 63304120001 | |||||
HUNTINGTON, Dale Anthony | Director | Portman House 2 Portman Street W1H 6DU London | British | Business Executive | 99326650001 | |||||
LAMBERT, Michael John | Director | 200-202 Aldersgate Street EC1A 4HD London 7th Floor | England | British | Finance Manager | 216952380001 | ||||
LEE, Joanna Elise | Director | Portman House 2 Portman Street W1H 6DU London | England | British | Manager, Global Power Generation | 220424200001 | ||||
LINGARD, Stephen Gerald William | Director | Portman House 2 Portman Street W1H 6DU London | British | Finance Manager | 94559740001 | |||||
MCCALL, Jeffrey Craig | Director | 200-202 Aldersgate Street EC1A 4HD London 7th Floor England | England | Us Citizen | F&Ci Manager | 168738980002 | ||||
OGLESBY, Daniel Green | Director | 9a The Avenue DN41 7NA Healing South Humberside | Usa | General Manager | 99325050001 | |||||
POULTER, Carole Watts | Director | Pens Place Lower Pound Lane SL7 2AE Marlow Buckinghamshire | United States | Business Executive | 80591590001 | |||||
STALKER, Ross Graham | Director | Thornley Lodge 9 Smithfield DN36 5RU North Thoresby Lincolnshire | British | Finance Manager | 99326160002 | |||||
SVANBERG, Nils Ingve | Director | 34 Knights Park KT1 2QN Kingston Upon Thames Surrey | Norwegian | General Manager | 53797470002 | |||||
TETLOW, Jeffrey Howard | Director | 18 Sydenham Hill SE26 6SR London | England | British | Business Executive | 72116910002 | ||||
WALSH, John Ronald | Director | 14118 Langbourne Houston Texas 77077 Usa | Us Citizen | Company Director | 34053160003 | |||||
INSTANT COMPANIES LIMITED | Director designado corporativo | Mitchell Lane BS1 6BU Bristol 1 Avon | 900008290001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de PHILLIPS 66 EUROPEAN POWER LIMITED?
Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phillips 66 Limited | 31 jul 2018 | 200-202 Aldersgate Street EC1A 4HD London 7th Floor England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Phillips 66 Development Holdings Ltd. | 06 abr 2016 | Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847 KY1-1103 Grand Cayman Trident Trust Company (Cayman) Ltd. Cayman Islands | Sí | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
|
¿Tiene PHILLIPS 66 EUROPEAN POWER LIMITED alguna carga?
Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
---|---|---|---|---|
Share mortgage | Creado el 17 ene 2002 Entregado el 04 feb 2002 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from immingham chp LLP (the "borrower") to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción The shares and related rights, all rights and benefits under the loan agreement together with all moneys payable. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0