SERVISTA LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaSERVISTA LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 03719982
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de SERVISTA LIMITED?

    • (7487) /

    ¿Dónde se encuentra SERVISTA LIMITED?

    Dirección de la sede social
    C/O BAKER TILLY RESTRUCTURING AND RECOVERY LLP
    The Pinnacle 170 Midsummer Boulevard
    MK9 1BP Milton Keynes
    Bucks
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de SERVISTA LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    SERVISTA.COM LIMITED01 feb 200001 feb 2000
    EUTILITIES LIMITED23 jun 199923 jun 1999
    M&R 711 LIMITED25 feb 199925 feb 1999

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de SERVISTA LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta30 jun 2008

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para SERVISTA LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 29 ago 2017

    6 páginas4.68

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de acreedores

    21 páginas4.72

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de acreedores

    19 páginasLIQ14

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 04 ago 2017

    6 páginas4.68

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 04 feb 2017

    6 páginas4.68

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 04 ago 2016

    6 páginas4.68

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 04 feb 2016

    8 páginas4.68

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 04 ago 2015

    6 páginas4.68

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 04 feb 2015

    6 páginas4.68

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 04 ago 2014

    6 páginas4.68

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 04 feb 2014

    7 páginas4.68

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 04 ago 2013

    12 páginas4.68

    Declaración de recibos y pagos del liquidador

    6 páginas4.68

    Declaración de recibos y pagos del liquidador

    9 páginas4.68

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 04 feb 2013

    6 páginas4.68

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 04 ago 2012

    9 páginas4.68

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 04 feb 2012

    7 páginas4.68

    Aviso de cese de funciones como liquidador voluntario

    8 páginas4.40

    Presentación de insolvencia

    Insolvency:o/c appointuing bruce alexander mackay as liquidator
    7 páginasLIQ MISC

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    1 páginas600

    Resultado de la reunión de acreedores

    32 páginas2.23B

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 04 ago 2011

    6 páginas4.68

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 04 feb 2011

    11 páginas4.68

    Domicilio social registrado cambiado de * C/O Baker Tilly Restructuruing and 5Th Floor Exhange House 466 Midsummer Boulevard Milton Keynes Buckinghamshire MK9 2EA* el 21 abr 2010

    2 páginasAD01

    ¿Quiénes son los directivos de SERVISTA LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    PARMAR, Manoj Kumar
    6 Northdown Road
    SL9 0LQ Chalfont St Peter
    Buckinghamshire
    Secretario
    6 Northdown Road
    SL9 0LQ Chalfont St Peter
    Buckinghamshire
    BritishChief Financial Officer160115240001
    ANDRADI, Benedict Pius Marilaan
    16 Knole Way
    TN13 3RS Sevenoaks
    Kent
    Director
    16 Knole Way
    TN13 3RS Sevenoaks
    Kent
    EnglandBritishChief Executive Officer82360580001
    BERTRAND, Cyril
    12 Rue Tronchet
    Paris
    France 75008
    Director
    12 Rue Tronchet
    Paris
    France 75008
    FrenchFund Manager136535100001
    DU ROY DE BLICQUY, Corentin
    48 Broomhouse Road
    SW6 3QX London
    Director
    48 Broomhouse Road
    SW6 3QX London
    United KingdomBelgianSenior Associate116061580001
    FORD, Howard
    12 Tekels Avenue
    GU15 2LB Camberley
    Surrey
    Director
    12 Tekels Avenue
    GU15 2LB Camberley
    Surrey
    EnglandBritishSenior Vice President22120110001
    GURNANI, Chander Prakash
    Sector 17
    Noida
    A63
    201301
    India
    Director
    Sector 17
    Noida
    A63
    201301
    India
    IndianService133681900001
    MEARING-SMITH, Nicholas Paul
    9 Clonmore Street
    SW18 5EU London
    Director
    9 Clonmore Street
    SW18 5EU London
    EnglandBritishCompany Director103002190002
    PARMAR, Manoj Kumar
    6 Northdown Road
    SL9 0LQ Chalfont St Peter
    Buckinghamshire
    Director
    6 Northdown Road
    SL9 0LQ Chalfont St Peter
    Buckinghamshire
    EnglandBritishChief Financial Officer160115240001
    RABINI, Johannes
    Am Volkspark 47
    FOREIGN Berlin
    10715
    Germany
    Director
    Am Volkspark 47
    FOREIGN Berlin
    10715
    Germany
    GermanInvestment Director116353770001
    SOFINNOVA PARTNERS SA
    17 Rue De Surene
    FOREIGN Paris
    75008
    France
    Director corporativo
    17 Rue De Surene
    FOREIGN Paris
    75008
    France
    66287570001
    BATES, Alexander John
    47 Linhope Street
    NW1 6HL London
    Secretario
    47 Linhope Street
    NW1 6HL London
    BritishDirectors23351690002
    GORMAN, John Alfred
    9 Violet Hill
    NW8 9EB London
    Secretario
    9 Violet Hill
    NW8 9EB London
    AmericanCompany Director64683050002
    MOBED, Julie
    9 Brooklands Court
    Brooklands Avenue
    CB2 2BP Cambridge
    Secretario
    9 Brooklands Court
    Brooklands Avenue
    CB2 2BP Cambridge
    British69592510001
    NDUMU, Divine Tamajong, Dr
    215 Cleveland Way
    SG1 6BX Stevenage
    Hertfordshire
    Secretario
    215 Cleveland Way
    SG1 6BX Stevenage
    Hertfordshire
    BritishChief Technology Officer106435250001
    OVERTON, Martin John
    The New House
    London Road, Capel St. Mary
    IP9 2JR Ipswich
    Suffolk
    Secretario
    The New House
    London Road, Capel St. Mary
    IP9 2JR Ipswich
    Suffolk
    BritishManager92083320001
    SHEETS, Courtney Todd
    Flat 3
    42 Clifton Gardens
    W9 1AU London
    Secretario
    Flat 3
    42 Clifton Gardens
    W9 1AU London
    AmericanDirector64683110002
    SHEETS, Courtney Todd
    Flat 3
    42 Clifton Gardens
    W9 1AU London
    Secretario
    Flat 3
    42 Clifton Gardens
    W9 1AU London
    AmericanCompany Director64683110002
    BATES, Alexander John
    47 Linhope Street
    NW1 6HL London
    Director
    47 Linhope Street
    NW1 6HL London
    United KingdomBritishDirectors23351690002
    BENNELL, Peter Raymond
    The Old Vicarage
    Church Lane, Playford
    IP6 9DS Ipswich
    Suffolk
    Director
    The Old Vicarage
    Church Lane, Playford
    IP6 9DS Ipswich
    Suffolk
    BritishGeneral Manager68905300001
    BEST, David Graham
    Toftwood
    East Common
    AL5 1DD Harpenden
    Hertfordshire
    Director
    Toftwood
    East Common
    AL5 1DD Harpenden
    Hertfordshire
    United KingdomBritishChartered Accountant34249020002
    BOHANNON, Kyle
    131b Portland Road
    W11 4LW London
    Director
    131b Portland Road
    W11 4LW London
    AmericanPrivate Equity102644730001
    COX, David Michael
    Ardshiel
    6 Ladythorn Crescent
    SK7 2HA Bramhall
    Cheshire
    Director
    Ardshiel
    6 Ladythorn Crescent
    SK7 2HA Bramhall
    Cheshire
    UkBritishCompany Director33300110001
    GARY, Michael Shayne
    3748 Wickcliff Lane
    Memphis
    Tennessee
    38118
    America
    Director
    3748 Wickcliff Lane
    Memphis
    Tennessee
    38118
    America
    AmericanDirector65971100001
    GORMAN, John Alfred
    Servista 32-38 Saffron Hill
    EC1N 8FH London
    Director
    Servista 32-38 Saffron Hill
    EC1N 8FH London
    AmericanCompany Director64683050003
    KARLIN, Mikael
    Uberrheiner Strase 8
    Kirchheim
    D 85551
    Germany
    Director
    Uberrheiner Strase 8
    Kirchheim
    D 85551
    Germany
    SwedishManagement74482400001
    LAFFY, Laurent Pierre Marie Raoul Edmond
    92 Portland Road
    W11 4LN London
    Director
    92 Portland Road
    W11 4LN London
    FrenchVenture Capital61848730001
    LANGSDALE, Philip Richard
    25 Highbury Place
    N5 1QP London
    Director
    25 Highbury Place
    N5 1QP London
    United KingdomBritishDirector32832560002
    LINDOW, Stephan Peter
    Friedrichshaller Strasse 41
    FOREIGN Berlin
    Berlin 14199
    Germany
    Director
    Friedrichshaller Strasse 41
    FOREIGN Berlin
    Berlin 14199
    Germany
    GermanInvestment Director102164480001
    MARSHALL, Brian
    Owls Hall Chimney Street
    Hundon
    CO10 8DX Sudbury
    Suffolk
    Director designado
    Owls Hall Chimney Street
    Hundon
    CO10 8DX Sudbury
    Suffolk
    British900008320001
    NDUMU, Divine Tamajong, Dr
    215 Cleveland Way
    SG1 6BX Stevenage
    Hertfordshire
    Director
    215 Cleveland Way
    SG1 6BX Stevenage
    Hertfordshire
    United KingdomBritishChief Technology Officer106435250001
    OVERTON, Martin John
    The New House
    London Road, Capel St. Mary
    IP9 2JR Ipswich
    Suffolk
    Director
    The New House
    London Road, Capel St. Mary
    IP9 2JR Ipswich
    Suffolk
    BritishManager92083320001
    SCHRICKE, Herve
    27 Rue Du Faubourg
    Montmartre
    FOREIGN Paris
    9e (75)
    France
    Director
    27 Rue Du Faubourg
    Montmartre
    FOREIGN Paris
    9e (75)
    France
    FranceFrenchBusiness Man171898440001
    SHEETS, Courtney Todd
    20c Randolph Crescent
    W9 1DR London
    Director
    20c Randolph Crescent
    W9 1DR London
    BritishCompany Director64683110003
    VALKIN, Adam Alexander
    16 Bristol Mews
    W9 2JF London
    Director
    16 Bristol Mews
    W9 2JF London
    United KingdomSouth AfricanNon Executive Director94456980002
    WILLIAMS, Martyn Courtney Bailey
    9 Chadlington Road
    OX2 6SY Oxford
    Director
    9 Chadlington Road
    OX2 6SY Oxford
    EnglandBritishDirector37614850003

    ¿Tiene SERVISTA LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Mortgage debenture
    Creado el 07 ene 2008
    Entregado el 15 ene 2008
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Silicon Valley Bank
    Transacciones
    • 15 ene 2008Registro de un cargo (395)
    Rent deposit deed
    Creado el 15 dic 2006
    Entregado el 21 dic 2006
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    £83,100.00 due or to become due from the company to
    Breve descripción
    £83,100.00 together with any interest thereon for the time being standing to the credit of the account.
    Personas con derecho
    • The Mount Stuart Trust
    Transacciones
    • 21 dic 2006Registro de un cargo (395)
    Rent deposit deed
    Creado el 15 dic 2006
    Entregado el 21 dic 2006
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    £101,600.00 due or to become due from the company to
    Breve descripción
    £101,600.00 together with any interest thereon for the time being standing to the credit of the account.
    Personas con derecho
    • The Mount Stuart Trust
    Transacciones
    • 21 dic 2006Registro de un cargo (395)
    Mortgage debenture
    Creado el 01 jul 2006
    Entregado el 11 jul 2006
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Silicon Valley Bank (The Bank)
    Transacciones
    • 11 jul 2006Registro de un cargo (395)
    Rent deposit deed
    Creado el 23 jun 2006
    Entregado el 08 jul 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £249,690.00 due or to become due from the company to
    Breve descripción
    £249,690.00 together with any interest thereon for the time being standing to the credit of the account held by the landlord.
    Personas con derecho
    • The Mount Stuart Trust
    Transacciones
    • 08 jul 2006Registro de un cargo (395)
    • 21 abr 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Rent deposit deed
    Creado el 16 ene 2004
    Entregado el 22 ene 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    £249,690.00 paid and any interest standing to the credit of the account.
    Personas con derecho
    • Gradecourt Limited
    Transacciones
    • 22 ene 2004Registro de un cargo (395)
    • 19 may 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Rent deposit deed
    Creado el 21 may 2001
    Entregado el 30 may 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under a lease of even date
    Breve descripción
    The sum of £138,500.
    Personas con derecho
    • Gradecourt Limited
    Transacciones
    • 30 may 2001Registro de un cargo (395)
    • 19 may 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Deed of charge over credit balances
    Creado el 13 may 2000
    Entregado el 24 may 2000
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Barclays current account number 50895962. the charge creates a fixed charge over all the deposit(s) referred to in the schedule to the form 395 (including all or any part of the money payable pursuant to such deposit(s) and the debts represented thereby) together with all interest from time to time accruing thereon it also creates an assignment by the chargor for the purposes of and to give effect to the security over the right of the chargor to require repayment of such deposit(s) and interest thereon.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 24 may 2000Registro de un cargo (395)
    • 19 may 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Charge
    Creado el 05 may 2000
    Entregado el 20 may 2000
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All liabilities due or to become due from the company to the chargee as trustee for itself and the beneficiaries (as defined) (the "security trustee") or any of them under or in connection with any finance document (as defined) on any account whatsoever
    Breve descripción
    All existing and future cash at the bank and in the debts.
    Personas con derecho
    • Digital Ventures Ii Limited
    Transacciones
    • 20 may 2000Registro de un cargo (395)
    • 02 feb 2001Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Rent security deposit deed
    Creado el 29 mar 2000
    Entregado el 30 mar 2000
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £111,190 due or to become due from the company to the chargee
    Breve descripción
    The deposit of £111,190 and all losses. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Transworld Land Co. Limited
    Transacciones
    • 30 mar 2000Registro de un cargo (395)
    • 19 may 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    ¿Tiene SERVISTA LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    05 feb 2010Fin de la administración
    03 jul 2009Inicio de la administración
    En administración
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Graham Paul Bushby
    5th Floor Exchange House 446 Midsummer Boulevard
    MK9 2EA Central Milton Keynes
    Profesional
    5th Floor Exchange House 446 Midsummer Boulevard
    MK9 2EA Central Milton Keynes
    Simon Peter Bower
    Baker Tilly
    5th Floor, Exchange House
    MK9 2EA 446 Midsummer Boulevard
    Milton Keynes
    Profesional
    Baker Tilly
    5th Floor, Exchange House
    MK9 2EA 446 Midsummer Boulevard
    Milton Keynes
    2
    FechaTipo
    12 dic 2017Fecha prevista de disolución
    05 feb 2010Inicio de la liquidación
    Liquidación voluntaria de acreedores
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Graham Paul Bushby
    5th Floor Exchange House 446 Midsummer Boulevard
    MK9 2EA Central Milton Keynes
    Profesional
    5th Floor Exchange House 446 Midsummer Boulevard
    MK9 2EA Central Milton Keynes
    Simon Peter Bower
    Baker Tilly
    5th Floor, Exchange House
    MK9 2EA 446 Midsummer Boulevard
    Milton Keynes
    Profesional
    Baker Tilly
    5th Floor, Exchange House
    MK9 2EA 446 Midsummer Boulevard
    Milton Keynes
    Bruce Alexander Mackay
    25 Farringdon Street
    EC4A 4AB London
    Profesional
    25 Farringdon Street
    EC4A 4AB London

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0