EUROBET HOLDINGS LIMITED

EUROBET HOLDINGS LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaEUROBET HOLDINGS LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 03729913
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de EUROBET HOLDINGS LIMITED?

    • Actividades de oficinas centrales (70100) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra EUROBET HOLDINGS LIMITED?

    Dirección de la sede social
    New Castle House
    Castle Boulevard
    NG7 1FT Nottingham
    Nottinghamshire
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de EUROBET HOLDINGS LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    CORAL INTERNATIONAL LIMITED07 dic 199907 dic 1999
    DIRECTHALF LIMITED10 mar 199910 mar 1999

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de EUROBET HOLDINGS LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta26 sept 2015

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para EUROBET HOLDINGS LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Declaración de confirmación presentada el 03 may 2017 con actualizaciones

    5 páginasCS01

    Exercice comptable en cours prolongé du 30 sept 2016 au 31 mar 2017

    1 páginasAA01

    Cancelación total de la carga 12

    4 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 11

    4 páginasMR04

    Nombramiento de Harry Willits como director el 13 sept 2016

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Gala Coral Nominees Limited como director el 13 sept 2016

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Gala Coral Secretaries Limited como secretario el 13 sept 2016

    1 páginasTM02

    Cuentas completas preparadas hasta el 26 sept 2015

    16 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 03 may 2016 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital24 may 2016

    Estado de capital el 24 may 2016

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Cuentas completas preparadas hasta el 27 sept 2014

    15 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 03 may 2015 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital15 may 2015

    Estado de capital el 15 may 2015

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Cuentas completas preparadas hasta el 28 sept 2013

    14 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 03 may 2014 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital28 may 2014

    Estado de capital el 28 may 2014

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Declaración de los objetos de la sociedad

    2 páginasCC04

    Resoluciones

    Resolutions
    43 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    incorporation

    Resolución del Memorándum de Asociación

    RES01
    capital

    Resolución de asignación de valores

    RES10
    capital

    Resoluciones

    Re-transitional provisions & savings 20/08/2013
    RES13

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 29 sept 2012

    6 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 03 may 2013 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01

    Cambio de datos del director Paul Bowtell el 03 oct 2011

    2 páginasCH01

    Domicilio social registrado cambiado de * 71 Queensway London W2 4QH England* el 15 feb 2013

    1 páginasAD01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 24 sept 2011

    7 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 03 may 2012 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01

    Nombramiento de Paul Bowtell como director

    2 páginasAP01

    ¿Quiénes son los directivos de EUROBET HOLDINGS LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    BOWTELL, Paul
    Castle Boulevard
    NG7 1FT Nottingham
    New Castle House
    Nottinghamshire
    Director
    Castle Boulevard
    NG7 1FT Nottingham
    New Castle House
    Nottinghamshire
    United KingdomBritishExecutive164343080001
    WILLITS, Harry Andrew
    Castle Boulevard
    NG7 1FT Nottingham
    New Castle House
    Nottinghamshire
    Director
    Castle Boulevard
    NG7 1FT Nottingham
    New Castle House
    Nottinghamshire
    United KingdomBritishSolicitor175965490001
    MARISCOTTI, Michael Gordon
    Redcraft
    Spencers Green
    HP23 6LA Tring
    Hertfordshire
    Secretario
    Redcraft
    Spencers Green
    HP23 6LA Tring
    Hertfordshire
    BritishDirector17449850001
    ALNERY INCORPORATIONS NO.1 LIMITED
    9 Cheapside
    EC2V 6AD London
    Secretario corporativo
    9 Cheapside
    EC2V 6AD London
    64979410001
    GALA CORAL SECRETARIES LIMITED
    Queensway
    71 Queensway
    W2 4QH London
    71
    England
    Secretario corporativo
    Queensway
    71 Queensway
    W2 4QH London
    71
    England
    69240850005
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secretario designado corporativo
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    ASHDOWN, Vaughn Trevor
    Pine Hall
    Crouch Lane Borough Green
    TN15 8LU Sevenoaks
    Kent
    Director
    Pine Hall
    Crouch Lane Borough Green
    TN15 8LU Sevenoaks
    Kent
    BritishDirector16667900007
    BEAUMONT, Trevor Kenneth
    9 Pyne Gale
    Galleywood
    CM2 8QG Chelmsford
    Essex
    Director
    9 Pyne Gale
    Galleywood
    CM2 8QG Chelmsford
    Essex
    EnglandBritishDirector109954570001
    CRONK, John Julian Tristam
    Glebe House
    Vicarage Drive
    IG11 7NS Barking
    Essex
    Director
    Glebe House
    Vicarage Drive
    IG11 7NS Barking
    Essex
    BritishCompany Secretary6422100001
    ELIA, Rosario
    4 Silversmiths Way
    GU21 3HG Woking
    Surrey
    Director
    4 Silversmiths Way
    GU21 3HG Woking
    Surrey
    BritishIt Director72925020001
    GIOVANDO, Domenico
    St Normans Old Avenue
    KT14 6AD West Byfleet
    Surrey
    Director
    St Normans Old Avenue
    KT14 6AD West Byfleet
    Surrey
    EnglandItalianDirector48321030002
    GOULDEN, Neil Geoffrey
    Queensway
    W2 4QH London
    71
    England
    Director
    Queensway
    W2 4QH London
    71
    England
    EnglandBritishDirector151637880001
    HARRISON, Dominic Stephen
    Glebe House
    Vicarage Drive
    IG11 7NS Barking
    Essex
    Director
    Glebe House
    Vicarage Drive
    IG11 7NS Barking
    Essex
    United KingdomBritishChief Executive107909600001
    HUGHES, Gary William
    Queensway
    71 Queensway
    W2 4QH London
    71
    England
    Director
    Queensway
    71 Queensway
    W2 4QH London
    71
    England
    ScotlandBritishChief Financial Officer151269910001
    JONES, Stephen Alec
    10 Clematis Gardens
    IG8 0BU Woodford Green
    Essex
    Director
    10 Clematis Gardens
    IG8 0BU Woodford Green
    Essex
    BritishDirector11372830002
    KINDTS, Anniek Madeleine Denise Ghislaine
    Flat 2
    4 Melbury Road
    W14 8LP London
    Director
    Flat 2
    4 Melbury Road
    W14 8LP London
    BelgiumMarketing Director72925630001
    KNIGHT, Philip Gregory
    14 St Georges Road
    W4 1AY London
    Director
    14 St Georges Road
    W4 1AY London
    BritishFinance Director67079460002
    MARISCOTTI, Michael Gordon
    Arrewig Farm
    Arrewig Lane
    HP5 2UA Chartridge
    Buckinghamshire
    Director
    Arrewig Farm
    Arrewig Lane
    HP5 2UA Chartridge
    Buckinghamshire
    EnglandBritishDirector17449850002
    MARISCOTTI, Michael Gordon
    Redcraft
    Spencers Green
    HP23 6LA Tring
    Hertfordshire
    Director
    Redcraft
    Spencers Green
    HP23 6LA Tring
    Hertfordshire
    BritishDirector17449850001
    MURPHY, Neil Charles
    20 Burntash Cottages
    Marsh Steep
    GU32 2BB Petersfield
    Hampshire
    Director
    20 Burntash Cottages
    Marsh Steep
    GU32 2BB Petersfield
    Hampshire
    BritishDirector72925410001
    RICHARDSON, Lee Wayne
    32 The Birches
    Cove
    GU14 9RP Farnborough
    Hampshire
    Director
    32 The Birches
    Cove
    GU14 9RP Farnborough
    Hampshire
    EnglandBritishBusinessman116082950001
    ALNERY INCORPORATIONS NO 2 LIMITED
    9 Cheapside
    EC2V 6AB London
    Director corporativo
    9 Cheapside
    EC2V 6AB London
    66825630001
    ALNERY INCORPORATIONS NO.1 LIMITED
    9 Cheapside
    EC2V 6AD London
    Director corporativo
    9 Cheapside
    EC2V 6AD London
    64979410001
    GALA CORAL NOMINEES LIMITED
    Queensway
    71 Queensway
    W2 4QH London
    71
    England
    Director corporativo
    Queensway
    71 Queensway
    W2 4QH London
    71
    England
    76454320002
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Director designado corporativo
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de EUROBET HOLDINGS LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Castle Boulevard
    NG7 1FT Nottingham
    New Castle House
    England
    06 abr 2016
    Castle Boulevard
    NG7 1FT Nottingham
    New Castle House
    England
    No
    Forma jurídicaPrivate Limited By Share
    País de registroEngland
    Autoridad legalCompanies Act 2006
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro3927901
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.

    ¿Tiene EUROBET HOLDINGS LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Mortgage of shares
    Creado el 27 may 2011
    Entregado el 01 nov 2011
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company or any other obigor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    All the security created under the security document. All the liabilities all the shares and all related rights see image for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC (Acting as Security Agent)
    Transacciones
    • 01 nov 2011Registro de un cargo (MG01)
    • 20 dic 2016Satisfacción de una carga (MR04)
    Fixed and floating security document
    Creado el 27 may 2011
    Entregado el 10 jun 2011
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from a chargor or any obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC (Acting as Security Agent)
    Transacciones
    • 10 jun 2011Registro de un cargo (MG01)
    • 20 dic 2016Satisfacción de una carga (MR04)
    Fixed and floating security document
    Creado el 11 may 2006
    Entregado el 24 may 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Trustee for the Benefit of the Secured Parties
    Transacciones
    • 24 may 2006Registro de un cargo (395)
    • 08 jun 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Fixed and floating security document
    Creado el 23 dic 2005
    Entregado el 03 ene 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due by the company to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    F/H property being stadium and cromer road and spring garden car parks essex t/n EGL386379. F/h property being lessington avenue/ esher avenue car park essex t/n EGL293249. F/h property being employee house number 1 lessington avenue essex t/n EGL72046. For further details of property charged please refer to form 395. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Trustee for the Benefit of the Secured Parties
    Transacciones
    • 03 ene 2006Registro de un cargo (395)
    • 08 jun 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Share pledge
    Creado el 22 dic 2005
    Entregado el 09 ene 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    The pledged assets and all the right, title and interest in and to the pledged assets being 2 shares of £1 each of and in eurobet gibraltar and all rights attaching to the said shares and all dividends, interest or other income paid or payable. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Trustee for the Benefit of the Secured Parties
    Transacciones
    • 09 ene 2006Registro de un cargo (395)
    • 08 jun 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Share pledge
    Creado el 10 dic 2004
    Entregado el 22 dic 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    All right title and interest to and in the pledged assets. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (The Security Agent)
    Transacciones
    • 22 dic 2004Registro de un cargo (395)
    • 09 nov 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Security accession deed
    Creado el 10 dic 2004
    Entregado el 21 dic 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from any charging company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over all property and assets present and future including goodwill uncalled capital book debts buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Trustee for Itself and the Othersecured Parties (Security Agent)
    Transacciones
    • 21 dic 2004Registro de un cargo (395)
    • 09 nov 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Share pledge
    Creado el 11 feb 2004
    Entregado el 20 feb 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company or any other obligor to any finance party on any account whatsoever
    Breve descripción
    All right title and interest to and in the pledged assets. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (The Security Agent)
    Transacciones
    • 20 feb 2004Registro de un cargo (395)
    • 21 dic 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 11 feb 2004
    Entregado el 20 feb 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from any charging company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Trustee for Itself and the Othersecured Parties
    Transacciones
    • 20 feb 2004Registro de un cargo (395)
    • 21 dic 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Share pledge
    Creado el 08 oct 2002
    Entregado el 16 oct 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All money,obligations and liabilities due or to become due from the company (the "pledgor") to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    All pledgor's rights,title and interest in and to the pledged assets,as defined,and all other rights and interest in respect of all sums of money due. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 16 oct 2002Registro de un cargo (395)
    • 25 feb 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 06 sept 2002
    Entregado el 17 sept 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from any charging company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC (As Security Agent for Itself and the Other Secured Parties)(the Security Agent)
    Transacciones
    • 17 sept 2002Registro de un cargo (395)
    • 25 feb 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Deed of accession
    Creado el 16 may 2000
    Entregado el 01 jun 2000
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies and liabilities due or to become due from the company and each of the other obligors (as defined) to the chargee (the "security agent") or the other secured parties (as defined) under the senior finance documents (as defined) or any of them and under the debenture and on any account whatsoever
    Breve descripción
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 01 jun 2000Registro de un cargo (395)
    • 15 oct 2002Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0