HARMONY PUB COMPANY TRADING LIMITED

HARMONY PUB COMPANY TRADING LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración anual
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaHARMONY PUB COMPANY TRADING LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 03732095
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de HARMONY PUB COMPANY TRADING LIMITED?

    • Venta al por menor de bebidas en establecimientos especializados (47250) / Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas
    • Pubs y bares (56302) / Actividades de alojamiento y de servicios de comida
    • Alquiler y explotación de bienes inmobiliarios de entidades de vivienda (68201) / Actividades inmobiliarias

    ¿Dónde se encuentra HARMONY PUB COMPANY TRADING LIMITED?

    Dirección de la sede social
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de HARMONY PUB COMPANY TRADING LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    HERITAGE PUB COMPANY TRADING LIMITED15 abr 200315 abr 2003
    ATLASWAY 1 LTD12 mar 199912 mar 1999

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de HARMONY PUB COMPANY TRADING LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta01 jun 2013

    ¿Cuál es el estado de la última declaración anual para HARMONY PUB COMPANY TRADING LIMITED?

    Declaración anual
    Última declaración anual

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para HARMONY PUB COMPANY TRADING LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros

    9 páginas4.71

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 18 may 2015

    8 páginas4.68

    Cese del nombramiento de Glenn Pearson como director

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Andrew Clifford como director

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Kevin Georgel como director

    1 páginasTM01

    Domicilio social registrado cambiado de * 150 Aldersgate Street London EC1A 4EJ* el 05 jun 2014

    2 páginasAD01

    Declaración de solvencia

    3 páginas4.70

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    2 páginas600

    Resolución de insolvencia

    Resolution insolvency:business of liquidator
    1 páginasLIQ MISC RES

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo especial para la liquidación

    LRESSP

    Cancelación total de la carga 037320950009

    1 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 037320950010

    1 páginasMR04

    Déclaration annuelle établie au 12 mar 2014 avec liste complète des actionnaires

    7 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital12 mar 2014

    Estado de capital el 12 mar 2014

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Cese del nombramiento de Jonathan Paveley como director

    2 páginasTM01

    Cuentas completas preparadas hasta el 01 jun 2013

    13 páginasAA

    Memorándum y Estatutos

    10 páginasMEM/ARTS

    Resoluciones

    Resolutions
    3 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de autoridad para comprar un número de acciones

    RES09
    incorporation

    Resolución del Memorándum de Asociación

    RES01

    Registro de la carga 037320950010

    53 páginasMR01

    Registro de la carga 037320950009

    87 páginasMR01

    Déclaration annuelle établie au 12 mar 2013 avec liste complète des actionnaires

    8 páginasAR01

    Cuentas completas preparadas hasta el 26 may 2012

    14 páginasAA

    legacy

    6 páginasMG02

    legacy

    5 páginasMG02

    Cambio de datos del director Glenn Pearson el 28 sept 2012

    2 páginasCH01

    ¿Quiénes son los directivos de HARMONY PUB COMPANY TRADING LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    A G SECRETARIAL LIMITED
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    Secretario corporativo
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    90084920001
    GROSS, Milton
    86 Filey Avenue
    N16 6JJ London
    Secretario
    86 Filey Avenue
    N16 6JJ London
    Usa2986750004
    INGHAM, Michael Harry Peter
    3 Lauriston Road
    Wimbledon
    SW19 4TJ London
    Secretario
    3 Lauriston Road
    Wimbledon
    SW19 4TJ London
    British2739650001
    NIEDERMAN, Rivka
    Jessam Avenue
    E5 9DU London
    30
    Secretario
    Jessam Avenue
    E5 9DU London
    30
    British113503670001
    FORM 10 SECRETARIES FD LTD
    39a Leicester Road
    Salford
    M7 4AS Manchester
    Lancashire
    Secretario designado corporativo
    39a Leicester Road
    Salford
    M7 4AS Manchester
    Lancashire
    900014000001
    BROWN, Aaron Maxwell
    11 Carlyle Close
    N2 0QU London
    Director
    11 Carlyle Close
    N2 0QU London
    American98928830001
    CLIFFORD, Andrew Francis James
    Steam Mill Business Centre
    Steam Mill Street
    CH3 5AN Chester
    Suite H3
    United Kingdom
    Director
    Steam Mill Business Centre
    Steam Mill Street
    CH3 5AN Chester
    Suite H3
    United Kingdom
    EnglandBritish119327230001
    D'ARCY, Lynne
    5 Winwick Park Avenue
    WA2 8XB Warrington
    Cheshire
    Director
    5 Winwick Park Avenue
    WA2 8XB Warrington
    Cheshire
    United KingdomBritish106840540001
    FINNEY, Francis John
    Summers End
    8 Weaverlake
    DE13 8AD Yoxall
    Staffordshire
    Director
    Summers End
    8 Weaverlake
    DE13 8AD Yoxall
    Staffordshire
    EnglandBritish89286280002
    GEORGEL, Kevin Roger
    Steam Mill Street
    CH3 5AN Chester
    Suite H3 Steam Mill Business Centre
    Director
    Steam Mill Street
    CH3 5AN Chester
    Suite H3 Steam Mill Business Centre
    United KingdomBritish153480970001
    GROSS, Milton
    86 Filey Avenue
    N16 6JJ London
    Director
    86 Filey Avenue
    N16 6JJ London
    Usa2986750004
    HARRISON, David John
    Main Street
    Winster
    DE4 2DH Matlock
    The Archway
    Derbyshire
    Director
    Main Street
    Winster
    DE4 2DH Matlock
    The Archway
    Derbyshire
    United KingdomBritish62175190001
    LANDESBERG, Alan
    Allingham Court
    44 The Bishops Avenue Hampstead
    N2 OBA London
    Flat 3,
    Director
    Allingham Court
    44 The Bishops Avenue Hampstead
    N2 OBA London
    Flat 3,
    EnglandBritish142883260001
    LANDESBERG, Gary Mitchell
    122 Wigmore Street
    W1U 3RX London
    Director
    122 Wigmore Street
    W1U 3RX London
    United KingdomBritish54137480002
    O'NEILL, John
    Westbourne
    Gorse Bank Lane, Baslow
    DE45 1SG Bakewell
    Derbyshire
    Director
    Westbourne
    Gorse Bank Lane, Baslow
    DE45 1SG Bakewell
    Derbyshire
    British89254470001
    PAVELEY, Jonathan David, Dr
    Steam Mill Street
    CH3 5AN Chester
    Suite H3 Steam Mill Business Centre
    Director
    Steam Mill Street
    CH3 5AN Chester
    Suite H3 Steam Mill Business Centre
    United KingdomBritish100582600002
    PEARSON, Glenn
    Steam Mill Business Centre
    Steam Mill Street
    CH3 5AN Chester
    Suite H3
    United Kingdom
    Director
    Steam Mill Business Centre
    Steam Mill Street
    CH3 5AN Chester
    Suite H3
    United Kingdom
    United KingdomBritish123243570001
    PERCY, Andrew Graeme
    5 Carlton Avenue
    SK9 4EP Wilmslow
    Cheshire
    Director
    5 Carlton Avenue
    SK9 4EP Wilmslow
    Cheshire
    British53017070002
    ROSENBERG, David
    Green Verges
    Priory Drive
    HA7 3HL Stanmore
    Middlesex
    Director
    Green Verges
    Priory Drive
    HA7 3HL Stanmore
    Middlesex
    EnglandBritish2541410004
    ROSENBERG, Elliot Simon
    Brooklands 33 Linksway
    HA6 2XA Northwood
    Middlesex
    Director
    Brooklands 33 Linksway
    HA6 2XA Northwood
    Middlesex
    EnglandBritish2541420006
    SCHREIBER, David
    143 Upper Clapton Road
    E5 9DB London
    Director
    143 Upper Clapton Road
    E5 9DB London
    EnglandBritish75594970001
    SCHREIBER, Jacob
    10 Gilda Crescent
    N16 6JP London
    Director
    10 Gilda Crescent
    N16 6JP London
    United KingdomBritish67574090001
    SMALLEY, Timothy John
    Chivers Road
    CM15 0LG Stondon Massey
    Stondon Place
    Essex
    Director
    Chivers Road
    CM15 0LG Stondon Massey
    Stondon Place
    Essex
    United KingdomBritish102593650002
    WILSON, Hugh Wingate
    The Home Farm
    Fenton Road Stubton
    NG23 5DB Newark
    Nottinghamshire
    Director
    The Home Farm
    Fenton Road Stubton
    NG23 5DB Newark
    Nottinghamshire
    British89126810001
    FORM 10 DIRECTORS FD LTD
    39a Leicester Road
    Salford
    M7 4AS Manchester
    Lancashire
    Director designado corporativo
    39a Leicester Road
    Salford
    M7 4AS Manchester
    Lancashire
    900013990001

    ¿Tiene HARMONY PUB COMPANY TRADING LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    A registered charge
    Creado el 27 jun 2013
    Entregado el 12 jul 2013
    Satisfecho en su totalidad
    Breve descripción
    Notification of addition to or amendment of charge.
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Admiral Taverns Bidco Limited
    Transacciones
    • 12 jul 2013Registro de una carga (MR01)
    • 15 may 2014Satisfacción de una carga (MR04)
    A registered charge
    Creado el 27 jun 2013
    Entregado el 09 jul 2013
    Satisfecho en su totalidad
    Breve descripción
    Notification of addition to or amendment of charge.
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • U.S. Bank Trustees Limited (As Security Agent and Trustee for the Beneficiaries)
    Transacciones
    • 09 jul 2013Registro de una carga (MR01)
    • 16 may 2014Satisfacción de una carga (MR04)
    Debenture
    Creado el 17 nov 2009
    Entregado el 02 dic 2009
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the secured parties or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC in Its Capacity as Security Trustee
    Transacciones
    • 02 dic 2009Registro de un cargo (MG01)
    • 27 dic 2012Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Debenture
    Creado el 17 nov 2009
    Entregado el 02 dic 2009
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    By way of first legal mortgage the original property: and all estates or interests in f/h, l/h or commonhold property and which is owned by the chargor as at the date of the debenture, and in each case, all premises and fixtures on such property for the time being. By way of fixed charge all other estates or interests in f/h, l/h or commonhold property: the proceeds of sale of its secured property and all licences to enter on or use any secured property see image for full details.
    Personas con derecho
    • Admiral Taverns Bidco Limited
    Transacciones
    • 02 dic 2009Registro de un cargo (MG01)
    • 27 dic 2012Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Debenture
    Creado el 30 ene 2009
    Entregado el 07 feb 2009
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 07 feb 2009Registro de un cargo (395)
    • 02 dic 2009Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Debenture
    Creado el 24 jul 2007
    Entregado el 04 ago 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Irish Nationwide Building Society
    Transacciones
    • 04 ago 2007Registro de un cargo (395)
    • 02 dic 2009Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Debenture
    Creado el 24 jul 2007
    Entregado el 02 ago 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 02 ago 2007Registro de un cargo (395)
    • 02 dic 2009Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Debenture
    Creado el 08 ago 2005
    Entregado el 13 ago 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Irish Nationwide Building Society
    Transacciones
    • 13 ago 2005Registro de un cargo (395)
    • 05 sept 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Assignment of keyman
    Creado el 24 nov 2003
    Entregado el 25 nov 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    The policies, all sums assured by them and all bonuses and benefits which may arise under them and the company's whole right title and interest in the policy no's 0102078318, 0102078318 and 0102077781. see the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 25 nov 2003Registro de un cargo (395)
    • 29 jul 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 15 abr 2003
    Entregado el 19 abr 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 19 abr 2003Registro de un cargo (395)
    • 29 jul 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    ¿Tiene HARMONY PUB COMPANY TRADING LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    19 may 2014Inicio de la liquidación
    15 jun 2016Fecha de disolución
    Liquidación voluntaria de socios
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Colin Peter Dempster
    Ten George Street
    EH2 2DZ Edinburgh
    Profesional
    Ten George Street
    EH2 2DZ Edinburgh
    Derek Hyslop
    10 George Street
    EH2 2DZ Edinburgh
    Profesional
    10 George Street
    EH2 2DZ Edinburgh

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0