IMPEY SHOWERS LTD

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaIMPEY SHOWERS LTD
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 03742299
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de IMPEY SHOWERS LTD?

    • Fabricación de otros muebles n.c.p. (31090) / Industrias manufactureras

    ¿Dónde se encuentra IMPEY SHOWERS LTD?

    Dirección de la sede social
    Conquest Business Park
    Cad Rd
    TA19 9EA Ilton
    Somerset
    England
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de IMPEY SHOWERS LTD?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    IMPEY UK LTD16 feb 200416 feb 2004
    CREATIVE HEALTHCARE LTD.29 mar 199929 mar 1999

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de IMPEY SHOWERS LTD?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2018

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para IMPEY SHOWERS LTD?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    La acción de exclusión voluntaria ha sido suspendida

    1 páginasSOAS(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Cese del nombramiento de John Kenneth Blackburn como director el 01 dic 2020

    1 páginasTM01

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    1 páginasDS01

    Nombramiento de Mr Stephen Richard Huntly como director el 01 dic 2020

    2 páginasAP01

    Declaración de confirmación presentada el 29 mar 2020 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    Cese del nombramiento de Robert Alan Jarvis como director el 18 dic 2019

    1 páginasTM01

    legacy

    1 páginasSH20

    Estado de capital el 20 dic 2019

    • Capital: GBP 1
    3 páginasSH19

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06

    Domicilio social registrado cambiado de Building 3 Stanmore Industrial Estate Bridgnorth Shropshire WV15 5HP a Conquest Business Park Cad Rd Ilton Somerset TA19 9EA el 01 nov 2019

    1 páginasAD01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2018

    22 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 29 mar 2019 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cancelación total de la carga 037422990010

    1 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 9

    2 páginasMR04

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2017

    20 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 29 mar 2018 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2016

    20 páginasAA

    La dirección de inspección del registro se ha cambiado de Conquest House Conquest Business Park Cad Road Ilton, Ilminster Somerset TA19 9EA England a 4a Stanmore Industrial Estate Bridgnorth WV15 5HP

    1 páginasAD02

    Declaración de confirmación presentada el 29 mar 2017 con actualizaciones

    5 páginasCS01

    Nombramiento de Mr Mark Richard Dain como secretario el 31 ago 2016

    2 páginasAP03

    Cese del nombramiento de Renee Teresa Barrett como director el 31 ago 2016

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Renee Teresa Barrett como secretario el 31 ago 2016

    1 páginasTM02

    ¿Quiénes son los directivos de IMPEY SHOWERS LTD?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    DAIN, Mark Richard
    Cad Rd
    TA19 9EA Ilton
    Conquest Business Park
    Somerset
    England
    Secretario
    Cad Rd
    TA19 9EA Ilton
    Conquest Business Park
    Somerset
    England
    218748320001
    DAIN, Mark Richard
    Cad Rd
    TA19 9EA Ilton
    Conquest Business Park
    Somerset
    England
    Director
    Cad Rd
    TA19 9EA Ilton
    Conquest Business Park
    Somerset
    England
    EnglandEnglish117343980001
    HUNTLY, Stephen Richard
    Cad Rd
    TA19 9EA Ilton
    Conquest Business Park
    Somerset
    England
    Director
    Cad Rd
    TA19 9EA Ilton
    Conquest Business Park
    Somerset
    England
    EnglandBritish277651870001
    BARRETT, Renee Teresa
    Stanmore Industrial Estate
    WV15 5HP Bridgnorth
    Building 3
    Shropshire
    Secretario
    Stanmore Industrial Estate
    WV15 5HP Bridgnorth
    Building 3
    Shropshire
    161768270001
    GRAVE, Jacquelyn Eva
    Kentmere
    Snowden Cottage Lane
    TA20 1LN Chard
    Somerset
    Secretario
    Kentmere
    Snowden Cottage Lane
    TA20 1LN Chard
    Somerset
    British63240160002
    JONES, Gary
    Bassnage Road
    B63 4HG Halesowen
    70
    West Midlands
    Secretario
    Bassnage Road
    B63 4HG Halesowen
    70
    West Midlands
    British150912700001
    CHETTLEBURGH INTERNATIONAL LIMITED
    Temple House
    20 Holywell Row
    EC2A 4JB London
    Secretario designado corporativo
    Temple House
    20 Holywell Row
    EC2A 4JB London
    900000860001
    BALL, Howard Ashley
    23 Barrowfield Close
    Burton Bradstock
    DT6 4RH Bridport
    Dorset
    Director
    23 Barrowfield Close
    Burton Bradstock
    DT6 4RH Bridport
    Dorset
    United KingdomBritish107722530002
    BARRETT, Renee Teresa
    Stanmore Industrial Estate
    WV15 5HP Bridgnorth
    Building 3
    Shropshire
    Director
    Stanmore Industrial Estate
    WV15 5HP Bridgnorth
    Building 3
    Shropshire
    EnglandBritish80782310002
    BEGGS, Rebecca Jane
    18 The Beacon
    TA19 9AH Ilminster
    Beacon Orchard
    Somerset
    Director
    18 The Beacon
    TA19 9AH Ilminster
    Beacon Orchard
    Somerset
    United KingdomBritish79319110004
    BLACKBURN, John Kenneth
    Cad Rd
    TA19 9EA Ilton
    Conquest Business Park
    Somerset
    England
    Director
    Cad Rd
    TA19 9EA Ilton
    Conquest Business Park
    Somerset
    England
    EnglandBritish113390120001
    DIMELOE, Peter William
    Stanmore Industrial Estate
    WV15 5HP Bridgnorth
    Building 3
    Shropshire
    Director
    Stanmore Industrial Estate
    WV15 5HP Bridgnorth
    Building 3
    Shropshire
    United KingdomBritish36078950001
    GENT, Stephen Alan
    Stanmore Industrial Estate
    WV15 5HP Bridgnorth
    Building 3
    Shropshire
    Director
    Stanmore Industrial Estate
    WV15 5HP Bridgnorth
    Building 3
    Shropshire
    United KingdomBritish80476320002
    GRAVE, Benjamin John
    Windsor Crescent
    TA20 2HG Chard
    22
    Somerset
    Director
    Windsor Crescent
    TA20 2HG Chard
    22
    Somerset
    EnglandBritish105591080004
    GRAVE, Jacquelyn Eva
    Kentmere
    Snowden Cottage Lane
    TA20 1LN Chard
    Somerset
    Director
    Kentmere
    Snowden Cottage Lane
    TA20 1LN Chard
    Somerset
    United KingdomBritish63240160002
    GRAVE, Robert Charles
    Japonica Cottage
    342 High Street
    BA22 9PJ Hardington Mandeville
    Somerset
    Director
    Japonica Cottage
    342 High Street
    BA22 9PJ Hardington Mandeville
    Somerset
    United KingdomBritish69130170002
    GRAVE, Robert Bruce
    Kentmere
    Snowdon Cottage Lane
    TA20 1LN Chard
    Somerset
    Director
    Kentmere
    Snowdon Cottage Lane
    TA20 1LN Chard
    Somerset
    United KingdomBritish63240150005
    JARVIS, Robert Alan
    Cad Rd
    TA19 9EA Ilton
    Conquest Business Park
    Somerset
    England
    Director
    Cad Rd
    TA19 9EA Ilton
    Conquest Business Park
    Somerset
    England
    EnglandBritish131619900001
    MCCORMICK, Keith
    Stanmore Industrial Estate
    WV15 5HP Bridgnorth
    Building 3
    Shropshire
    Director
    Stanmore Industrial Estate
    WV15 5HP Bridgnorth
    Building 3
    Shropshire
    United KingdomBritish89897960001
    PILAAR, Niels Jan
    Stanmore Industrial Estate
    WV15 5HP Bridgnorth
    Building 3
    Shropshire
    Director
    Stanmore Industrial Estate
    WV15 5HP Bridgnorth
    Building 3
    Shropshire
    NetherlandsDutch150912500001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de IMPEY SHOWERS LTD?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Cram Uk Holding Ltd
    Stanmore Industrial Estate
    WV15 5HP Bridgnorth
    4a
    England
    06 abr 2016
    Stanmore Industrial Estate
    WV15 5HP Bridgnorth
    4a
    England
    No
    Forma jurídicaLimited Company
    País de registroEngland
    Autoridad legalCompanies Act
    Lugar de registroLondon
    Número de registro07214057
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.

    ¿Tiene IMPEY SHOWERS LTD alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    A registered charge
    Creado el 17 dic 2014
    Entregado el 02 ene 2015
    Satisfecho en su totalidad
    Breve descripción
    Nine trademarks being UK00002236308, UK00002272075, UK00002471001, UK00002472030, UK00002473084, UK00002520800, UK00002601191, UK00002628724, UK00002638446.
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Abn Amro Commercial Finance PLC
    Transacciones
    • 02 ene 2015Registro de una carga (MR01)
    • 04 ene 2019Satisfacción de una carga (MR04)
    Debenture
    Creado el 20 mar 2013
    Entregado el 05 abr 2013
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or any of the other borrowers to the banks (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    By way of fixed charge all the debts, any deposits, margins, commissions or other rights, all loan capital, indebtedness or liabilities, the contracts and by way of floating charge all the stock-in-trade see image for full details.
    Personas con derecho
    • Ing Bank N.V. and Abn Amro Bank N.V.
    Transacciones
    • 05 abr 2013Registro de un cargo (MG01)
    • 12 dic 2018Satisfacción de una carga (MR04)
    Charge of deposit
    Creado el 30 mar 2010
    Entregado el 09 abr 2010
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    The deposit initially of £62,000 credited to account designation number 23542551 with the bank and any addition to that deposit and any deposit or account from time to time of any other currency description or designation which derives in whole or in part from such deposit or account.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 09 abr 2010Registro de un cargo (MG01)
    • 12 oct 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Fixed and floating charge
    Creado el 05 dic 2006
    Entregado el 07 dic 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Rbs Invoice Finance Limited
    Transacciones
    • 07 dic 2006Registro de un cargo (395)
    • 15 sept 2011Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad gravada ha sido liberada (MG04)
    • 01 dic 2014Satisfacción de una carga (MR04)
    Legal charge
    Creado el 25 ago 2006
    Entregado el 09 sept 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Commercial unit conquest business park cad road ilton ilminster somerset. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 09 sept 2006Registro de un cargo (395)
    • 17 abr 2010Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Legal charge
    Creado el 25 ago 2006
    Entregado el 09 sept 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Development land at conquest business park cad road ilton ilminster somerset. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 09 sept 2006Registro de un cargo (395)
    • 17 abr 2010Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Legal charge
    Creado el 25 ago 2006
    Entregado el 09 sept 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Conquest house conquest business park cad road ilton ilminster somerset. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 09 sept 2006Registro de un cargo (395)
    • 17 abr 2010Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Debenture
    Creado el 23 jun 2006
    Entregado el 04 jul 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 04 jul 2006Registro de un cargo (395)
    • 14 abr 2010Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Legal charge
    Creado el 12 ago 2004
    Entregado el 20 ago 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Plot 4 spinnaker quay lawrence road plymouth city of plymouth t/no DN481911.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 20 ago 2004Registro de un cargo (395)
    • 09 abr 2010Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Legal charge
    Creado el 07 oct 2003
    Entregado el 27 oct 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    The construction equipment centre and plot 4 conquest business park ilton ilminster somerset t/no WS24171.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 27 oct 2003Registro de un cargo (395)
    • 21 dic 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0