MEANTIME BREWING COMPANY LIMITED

MEANTIME BREWING COMPANY LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaMEANTIME BREWING COMPANY LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 03748390
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de MEANTIME BREWING COMPANY LIMITED?

    • Fabricación de cerveza (11050) / Industrias manufactureras

    ¿Dónde se encuentra MEANTIME BREWING COMPANY LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Griffin Brewery
    Chiswick Lane South
    W4 2QB London
    England
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de MEANTIME BREWING COMPANY LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    SPEED 7605 LIMITED08 abr 199908 abr 1999

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de MEANTIME BREWING COMPANY LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2020

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para MEANTIME BREWING COMPANY LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Declaración de confirmación presentada el 17 ago 2023 con actualizaciones

    4 páginasCS01
    XCAOW3YO

    La acción de exclusión voluntaria ha sido suspendida

    1 páginasSOAS(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    2 páginasDS01
    XBYW6D6A

    Declaración de confirmación presentada el 17 ago 2022 con actualizaciones

    4 páginasCS01
    XBBKDVBV

    Cese del nombramiento de Yoshiaki Suzuki como director el 04 may 2022

    1 páginasTM01
    XB5LPG3N

    Cese del nombramiento de Paolo Lanzarotti como director el 04 may 2022

    1 páginasTM01
    XB5LPF7N

    Cese del nombramiento de Victoria Jane Segebarth como director el 04 may 2022

    1 páginasTM01
    XB5LPFV4

    Cancelación total de la carga 037483900009

    1 páginasMR04
    XB3O00R6

    Cancelación total de la carga 037483900011

    1 páginasMR04
    XB3O03EO

    Cancelación total de la carga 037483900014

    1 páginasMR04
    XB3O05GQ

    Cancelación total de la carga 037483900010

    1 páginasMR04
    XB3O02P4

    Cancelación total de la carga 037483900015

    1 páginasMR04
    XB3O05TS

    Cancelación total de la carga 037483900016

    1 páginasMR04
    XB3O07D4

    Cancelación total de la carga 037483900012

    1 páginasMR04
    XB3O04B4

    Cancelación total de la carga 037483900013

    1 páginasMR04
    XB3O050W

    Exercice comptable en cours prolongé du 31 dic 2021 au 30 jun 2022

    1 páginasAA01
    XB1W7T3U

    Cambio de datos del director Mr Yoshiaki Suzuki el 01 dic 2021

    2 páginasCH01
    XAY05X5E

    Cambio de datos del director Mr Yoshiaki Suzuki el 01 dic 2021

    2 páginasCH01
    XAY05WE2

    Modification des détails de Asahi Europe & International Ltd en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 01 ene 2022

    2 páginasPSC05
    XAXH88I2

    Notification de Asahi Europe & International Ltd en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 01 ene 2022

    1 páginasPSC02
    XAXH7X2G

    Cessation de Asahi International Ltd en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 01 ene 2022

    1 páginasPSC07
    XAXH7NU0

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2020

    34 páginasAA
    AAE4SI29

    Estado de capital el 24 sept 2021

    • Capital: GBP 278.47
    5 páginasSH19
    YADQM2WA

    ¿Quiénes son los directivos de MEANTIME BREWING COMPANY LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    BAILEY, Andrew
    Chiswick Lane South
    W4 2QB London
    Griffin Brewery
    England
    Director
    Chiswick Lane South
    W4 2QB London
    Griffin Brewery
    England
    Czech RepublicBritishCfo276078840001
    CLAY, Timothy James
    Chiswick Lane South
    W4 2QB London
    Griffin Brewery
    England
    Director
    Chiswick Lane South
    W4 2QB London
    Griffin Brewery
    England
    EnglandBritishDirector241594850001
    JAMES, Michael William
    Chiswick Lane South
    W4 2QB London
    Griffin Brewery
    England
    Director
    Chiswick Lane South
    W4 2QB London
    Griffin Brewery
    England
    United KingdomBritishFinance Director220997590001
    EMMS, Robert
    Forge End
    GU21 6DB Woking
    One Forge End
    England
    Secretario
    Forge End
    GU21 6DB Woking
    One Forge End
    England
    177428790001
    HAYDON, Peter Risdon
    16 Eversley Road
    SE7 7LD London
    Secretario
    16 Eversley Road
    SE7 7LD London
    British82721320001
    HOOK, Alastair Frederick
    St. Johns Park
    SE3 7TG London
    4e
    Secretario
    St. Johns Park
    SE3 7TG London
    4e
    BritishDirector87310630002
    HUSER, Lars Martin Daehlie
    8 Timbercroft Lane
    Plumstead
    SE18 2SB London
    Secretario
    8 Timbercroft Lane
    Plumstead
    SE18 2SB London
    NorwegianFinance Director79676470001
    PARKINSON, Thomas James
    Forge End
    GU21 6DB Woking
    One Forge End
    England
    Secretario
    Forge End
    GU21 6DB Woking
    One Forge End
    England
    245303760001
    PERKS, Edward
    Chiswick Lane South
    W4 2QB London
    Griffin Brewery
    England
    Secretario
    Chiswick Lane South
    W4 2QB London
    Griffin Brewery
    England
    272819250001
    SMITH, James
    Chiswick Lane South
    W4 2QB London
    Griffin Brewery
    England
    Secretario
    Chiswick Lane South
    W4 2QB London
    Griffin Brewery
    England
    255353170001
    WATERLOW SECRETARIES LIMITED
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    Secretario designado corporativo
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    900003950001
    CARSON, Anthony John
    Church Street West
    GU21 6HS Woking
    Sabmiller House
    Surrey
    England
    Director
    Church Street West
    GU21 6HS Woking
    Sabmiller House
    Surrey
    England
    United KingdomBritishMarketeer48536040014
    CLARK, Susan Michelle
    Church Street West
    GU21 6HS Woking
    Sabmiller House
    Surrey
    England
    Director
    Church Street West
    GU21 6HS Woking
    Sabmiller House
    Surrey
    England
    United KingdomBritishManaging Director, Europe198296200001
    CLIFF, David Peter
    Station Road
    Walmer
    CT14 7QS Deal
    24
    Kent
    Director
    Station Road
    Walmer
    CT14 7QS Deal
    24
    Kent
    EnglandBritishCommercial Director26545430001
    COLLETTS, Ian Michael
    Church Street West
    GU21 6HS Woking
    Sabmiller House
    Surrey
    England
    Director
    Church Street West
    GU21 6HS Woking
    Sabmiller House
    Surrey
    England
    United KingdomBritishAccountant64102680001
    COLLETTS, Ian Michael
    Palladium House
    1-4 Argyll Street
    W1F 7LD London
    Director
    Palladium House
    1-4 Argyll Street
    W1F 7LD London
    United KingdomBritishAccountant64102680001
    CRAWLEY, Stephen Thomas
    22 Eglinton Crescent
    EH12 5BY Edinburgh
    Midlothian
    Director
    22 Eglinton Crescent
    EH12 5BY Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritishMd96352380002
    CUMMINGS, Rohan August
    Chiswick Lane South
    W4 2QB London
    Griffin Brewery
    England
    Director
    Chiswick Lane South
    W4 2QB London
    Griffin Brewery
    England
    EnglandBritishChief Financial Officer217687810003
    FILMER, Christopher Marc
    Church Street West
    GU21 6HS Woking
    Sabmiller House
    Surrey
    England
    Director
    Church Street West
    GU21 6HS Woking
    Sabmiller House
    Surrey
    England
    SwitzerlandAmericanStrategy Director198311620001
    FROST, Peter Dale
    67 Bromley Common
    BR2 9LP Bromley
    Kent
    Director
    67 Bromley Common
    BR2 9LP Bromley
    Kent
    BritishProduction Director81864410002
    GOROSABEL, Hector
    Chiswick Lane South
    W4 2QB London
    Griffin Brewery
    England
    Director
    Chiswick Lane South
    W4 2QB London
    Griffin Brewery
    England
    SwitzerlandCanadianMd Western Europe134457860001
    HAIGH, Gary Kenneth
    Forge End
    GU21 6DB Woking
    One Forge End
    England
    Director
    Forge End
    GU21 6DB Woking
    One Forge End
    England
    EnglandBritishManaging Director252301360001
    HAYDON, Peter Risdon
    68a Elmwood Road
    SE24 9NR London
    Director
    68a Elmwood Road
    SE24 9NR London
    United KingdomBritishDirector82721320002
    HOOK, Alastair Frederick
    St. Johns Park
    SE3 7TG London
    4e
    Director
    St. Johns Park
    SE3 7TG London
    4e
    United KingdomBritishManaging Director87310630002
    HUSER, Lars Martin Daehlie
    8 Timbercroft Lane
    Plumstead
    SE18 2SB London
    Director
    8 Timbercroft Lane
    Plumstead
    SE18 2SB London
    EnglandNorwegianFinance Director79676470001
    JOSEPH, Benjamin
    216 Burrage Road
    SE18 7JU London
    Director
    216 Burrage Road
    SE18 7JU London
    EnglandBritishCo. Director32070700002
    LANZAROTTI, Paolo
    Chiswick Lane South
    W4 2QB London
    Griffin Brewery
    England
    Director
    Chiswick Lane South
    W4 2QB London
    Griffin Brewery
    England
    Czech RepublicBritishDirector268501880001
    MILLER, Nicholas Brian
    2 Blissett Street
    SE10 8UP London
    The Royal George
    England
    Director
    2 Blissett Street
    SE10 8UP London
    The Royal George
    England
    UkBritishCeo108653760003
    MORI, Satoshi
    1-Chome
    1308602 Sumida-Ku
    23-1 Azumabashi
    Tokyo
    Japan
    Director
    1-Chome
    1308602 Sumida-Ku
    23-1 Azumabashi
    Tokyo
    Japan
    JapanJapaneseChief Integration Officer245165980001
    NARITSUKA, Yusuke
    Chiswick Lane South
    W4 2QB London
    Griffin Brewery
    England
    Director
    Chiswick Lane South
    W4 2QB London
    Griffin Brewery
    England
    United KingdomJapaneseDirector242819020001
    PAYNE, Glenn Alan
    4 Twinflower
    MK7 7LH Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Director
    4 Twinflower
    MK7 7LH Milton Keynes
    Buckinghamshire
    BritishSales House113855800001
    SEGEBARTH, Victoria Jane
    Chiswick Lane South
    W4 2QB London
    Griffin Brewery
    England
    Director
    Chiswick Lane South
    W4 2QB London
    Griffin Brewery
    England
    United KingdomBritishManaging Director187135420001
    SMITH, James Anthony
    Chiswick Lane South
    W4 2QB London
    Griffin Brewery
    England
    Director
    Chiswick Lane South
    W4 2QB London
    Griffin Brewery
    England
    EnglandBritishFinance Director272817660001
    SUZUKI, Yoshiaki
    Chiswick Lane South
    W4 2QB London
    Griffin Brewery
    England
    Director
    Chiswick Lane South
    W4 2QB London
    Griffin Brewery
    England
    Czech RepublicJapaneseDirector276079030005
    WARD, Andrew James Alexander
    Holmesley Road
    SE23 1PJ London
    32
    Director
    Holmesley Road
    SE23 1PJ London
    32
    United KingdomBritishRetail91096690002

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de MEANTIME BREWING COMPANY LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Asahi Europe & International Ltd
    Chertsey Road
    GU21 5BJ Woking
    Asahi House
    England
    01 ene 2022
    Chertsey Road
    GU21 5BJ Woking
    Asahi House
    England
    No
    Forma jurídicaPrivate Limited Company
    Autoridad legalCompanies Act 2006
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.
    Chiswick Lane South
    W4 2QB London
    Griffin Brewery
    England
    11 oct 2016
    Chiswick Lane South
    W4 2QB London
    Griffin Brewery
    England
    Forma jurídicaPrivate Limited Company
    País de registroUnited Kingdom (England And Wales)
    Autoridad legalCompanies Act 2006
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro10332503
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.

    ¿Tiene MEANTIME BREWING COMPANY LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    A registered charge
    Creado el 18 dic 2014
    Entregado el 18 dic 2014
    Satisfecho en su totalidad
    Breve descripción
    A legal assignment of contract monies.
    Contiene una promesa negativa:
    Personas con derecho
    • Hsbc Bank PLC
    Transacciones
    • 18 dic 2014Registro de una carga (MR01)
    • 09 may 2022Satisfacción de una carga (MR04)
    A registered charge
    Creado el 10 sept 2014
    Entregado el 18 sept 2014
    Satisfecho en su totalidad
    Breve descripción
    Assignment.
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Hsbc Asset Finance (UK) LTD
    • Hsbc Equipment Finance (UK) LTD
    Transacciones
    • 18 sept 2014Registro de una carga (MR01)
    • 09 may 2022Satisfacción de una carga (MR04)
    A registered charge
    Creado el 04 abr 2014
    Entregado el 04 abr 2014
    Satisfecho en su totalidad
    Breve descripción
    Notification of addition to or amendment of charge.
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • Hsbc Invoice Finance (UK) LTD
    Transacciones
    • 04 abr 2014Registro de una carga (MR01)
    • 09 may 2022Satisfacción de una carga (MR04)
    A registered charge
    Creado el 03 abr 2014
    Entregado el 07 abr 2014
    Satisfecho en su totalidad
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Hsbc Invoice Finance (UK) LTD
    Transacciones
    • 07 abr 2014Registro de una carga (MR01)
    • 09 may 2022Satisfacción de una carga (MR04)
    A registered charge
    Creado el 24 mar 2014
    Entregado el 25 mar 2014
    Satisfecho en su totalidad
    Breve descripción
    Notification of addition to or amendment of charge.
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Hsbc Bank PLC
    Transacciones
    • 25 mar 2014Registro de una carga (MR01)
    • 09 may 2022Satisfacción de una carga (MR04)
    A registered charge
    Creado el 20 feb 2014
    Entregado el 21 feb 2014
    Satisfecho en su totalidad
    Breve descripción
    Chattels mortgage. Notification of addition to or amendment of charge.
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Hsbc Asset Finance (UK) LTD
    • Hsbc Equipment Finance (UK) LTD
    Transacciones
    • 21 feb 2014Registro de una carga (MR01)
    • 09 may 2022Satisfacción de una carga (MR04)
    A registered charge
    Creado el 03 feb 2014
    Entregado el 04 feb 2014
    Satisfecho en su totalidad
    Breve descripción
    Notification of addition to or amendment of charge.
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Hsbc Bank PLC
    Transacciones
    • 04 feb 2014Registro de una carga (MR01)
    • 09 may 2022Satisfacción de una carga (MR04)
    A registered charge
    Creado el 03 feb 2014
    Entregado el 04 feb 2014
    Satisfecho en su totalidad
    Breve descripción
    L/H units 1 and 4 and 5 lawrence trading estate, blackwall lane, london t/no TGL381816 and TGL329509. Notification of addition to or amendment of charge.
    Personas con derecho
    • Hsbc Bank PLC
    Transacciones
    • 04 feb 2014Registro de una carga (MR01)
    • 09 may 2022Satisfacción de una carga (MR04)
    Chattel mortgage
    Creado el 06 jun 2012
    Entregado el 09 jun 2012
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    24 various holvrieka tanks. 5057/A fv cap 200/235 hl. 5057/B fv cap 200/235. 5057/c fv cap 200/235. (for further details of chattels charged please refer to form MG01) see image for full details.
    Personas con derecho
    • Clydesdale Bank PLC
    Transacciones
    • 09 jun 2012Registro de un cargo (MG01)
    • 11 mar 2016Satisfacción de una carga (MR04)
    Legal mortgage
    Creado el 25 ago 2010
    Entregado el 08 sept 2010
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Units 4 & 5 lawrence trading estate, blackwall lane, london assigns the goodwill of all businesses, from time to time carried on at the property, with the benefit of all authorisations, permits, registration certificates or licences of any kind, also by way of fixed charge the equipment & goods (if any) & all other fixtures, fittings, plant & machinery & by way of floating charge on other moveable plant, machinery, furniture, equipment, goods & other effects which are from time to time on the property.
    Personas con derecho
    • Clydesdale Bank PLC
    Transacciones
    • 08 sept 2010Registro de un cargo (MG01)
    • 07 feb 2015Todo el bien o empresa ha sido liberado de la carga (MR05)
    • 11 mar 2016Satisfacción de una carga (MR04)
    Chattel mortgage
    Creado el 21 mar 2005
    Entregado el 24 mar 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Charged and assigns the plant machinery chattels or other equipment being velo 110 hl stainless steel cylindrical lined fermentation tanks plant no. FV9 serial no. 3678 (2003) plant no. FV8 serial no. 3679 (2003) porkka type F820 240V free standing 2.5M cold room serial no. 403721 lowara vertical centrifugal pump serial no. 02411 (25/09/2003) fitted hydrovar digital flow controller for further details of property charged please refer to form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Clydesdale Bank Asset Finance Limited
    Transacciones
    • 24 mar 2005Registro de un cargo (395)
    • 11 mar 2016Satisfacción de una carga (MR04)
    Debenture
    Creado el 03 mar 2005
    Entregado el 04 mar 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transacciones
    • 04 mar 2005Registro de un cargo (395)
    • 11 mar 2016Satisfacción de una carga (MR04)
    Debenture
    Creado el 15 jul 2004
    Entregado el 03 ago 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    All assets of the company by way of a first fixed and floating charge.
    Personas con derecho
    • Eurofactor (UK) Limited
    Transacciones
    • 03 ago 2004Registro de un cargo (395)
    • 01 ago 2013Satisfacción de una carga (MR04)
    Mortgage
    Creado el 31 dic 2002
    Entregado el 10 ene 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Breve descripción
    Kuenzal type mza 16AOAA 1.5KW wheat malt mill s/n 20003 (2000), dme stainless steel malt holding bin with discharge (auger) s/n B1367-3, dme 5000 litre type crn OHO38998 45SPI @ 292F stainless steel double skin water storage tank s/n B1317-5. For details of further goods charged please refer to form 395.. see the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Mercantile Business Finance Limited
    Transacciones
    • 10 ene 2003Registro de un cargo (395)
    • 04 oct 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Deed of rent deposit
    Creado el 10 mar 2000
    Entregado el 18 mar 2000
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £7,000 plus vat due or to become due from the company to the chargee
    Breve descripción
    The rent deposit in respect of units g & h 2 penhall road charlton london.
    Personas con derecho
    • Hospitality Holdings Limited
    Transacciones
    • 18 mar 2000Registro de un cargo (395)
    • 11 mar 2016Satisfacción de una carga (MR04)
    Debenture
    Creado el 09 ene 2000
    Entregado el 25 ene 2000
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 25 ene 2000Registro de un cargo (395)
    • 04 oct 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0