PANDA SECURITY UK LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | PANDA SECURITY UK LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 03760287 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | Sí |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de PANDA SECURITY UK LIMITED?
- Desarrollo de software para negocios y hogares (62012) / Información y comunicación
¿Dónde se encuentra PANDA SECURITY UK LIMITED?
| Dirección de la sede social | Begbies Traynor (Central) Llp Town Wall House Balkerne Hill CO3 3AD Colchester Essex |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de PANDA SECURITY UK LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| PANDA SOFTWARE (UK) LTD | 16 abr 2008 | 16 abr 2008 |
| PANDA SECURITY (UK) LTD | 30 nov 2007 | 30 nov 2007 |
| PANDA SOFTWARE (UK) LTD | 27 abr 1999 | 27 abr 1999 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de PANDA SECURITY UK LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2019 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para PANDA SECURITY UK LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaceta final disuelta tras la liquidación | 1 páginas | GAZ2 | ||||||||||
Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros | 14 páginas | LIQ13 | ||||||||||
Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 20 dic 2022 | 15 páginas | LIQ03 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de 500 Bourne Business Park 5 Dashwood Lang Road Weybridge KT15 2HJ England a Begbies Traynor (Central) Llp Town Wall House Balkerne Hill Colchester Essex CO3 3AD el 07 ene 2022 | 2 páginas | AD01 | ||||||||||
Nombramiento de un liquidador voluntario | 3 páginas | 600 | ||||||||||
Declaración de solvencia | 6 páginas | LIQ01 | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 56 páginas | PARENT_ACC | ||||||||||
legacy | 4 páginas | GUARANTEE2 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 27 abr 2021 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||||||||||
Notification d'une déclaration relative à une personne disposant d'un contrôle significatif | 2 páginas | PSC08 | ||||||||||
Cessation de Gala Capital Partners Equity Scr S. A. en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 26 abr 2021 | 1 páginas | PSC07 | ||||||||||
Cessation de Jose Sancho Garcia en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 23 ene 2018 | 1 páginas | PSC07 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Antony Richard Lee como director el 01 ago 2020 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Oscar Del Pozo Menor como director el 31 jul 2020 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Juan Santamaria Uriarte como director el 31 jul 2020 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Cy Stefan Hersch como director el 06 jul 2020 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Kathryn Elizabeth Coffey como director el 06 jul 2020 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 27 abr 2020 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas auditadas abreviadas presentadas hasta el 31 dic 2019 | 8 páginas | AA | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de 3000 Hillswood Drive Chertsey KT16 0RS England a 500 Bourne Business Park 5 Dashwood Lang Road Weybridge KT15 2HJ el 13 may 2019 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 27 abr 2019 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas auditadas abreviadas presentadas hasta el 31 dic 2018 | 7 páginas | AA | ||||||||||
Nombramiento de Mr Oscar Del Pozo Menor como director el 04 mar 2019 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Santiago Mayoralas Alises como director el 28 feb 2019 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de PANDA SECURITY UK LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COFFEY, Kathryn Elizabeth | Director | Town Wall House Balkerne Hill CO3 3AD Colchester Begbies Traynor (Central) Llp Essex | United States | American | 271650810001 | |||||
| HERSCH, Cy Stefan | Director | Town Wall House Balkerne Hill CO3 3AD Colchester Begbies Traynor (Central) Llp Essex | United States | American | 271679340001 | |||||
| BATES, Samantha | Secretario | 19 Milner Road KT1 2AU Kingston Upon Thames Surrey | British | 68740950001 | ||||||
| HOLMES, Peter James | Secretario | Meadow View 5a Mill Common PE29 3AU Huntingdon Cambs | British | 97375340001 | ||||||
| LEE, Antony Richard | Secretario | 12 St Elizabeth Drive KT18 7LA Epsom Surrey | British | 109740640001 | ||||||
| PORTEUS, Emmaly Jayne | Secretario | 19 Fairfield Road RH15 8QB Burgess Hill West Sussex | British | 122692590001 | ||||||
| CATER BARNARD PLC | Secretario corporativo | Dean House Sovereign Court Ermine Business Park PE29 6WA Huntingdon Cambridgeshire | 74425930001 | |||||||
| ENVESTA PLC | Secretario corporativo | 6 Lloyds Avenue EC2N 3AX London | 78013300001 | |||||||
| FORM 10 SECRETARIES FD LTD | Secretario designado corporativo | 39a Leicester Road Salford M7 4AS Manchester Lancashire | 900014000001 | |||||||
| SOFTWARE DIALOG PLC | Secretario corporativo | Unit 5 Signet Court Swann Road CB5 8LA Cambridge Cambridgeshire | 90782490001 | |||||||
| ANSON, Nicola | Director | 3 Swan Grove Exning CB8 7HX Newmarket Suffolk | England | British | 49308560001 | |||||
| BATES, Jeremy Nicholas | Director | 19 Milner Road KT1 2AU Kingston Upon Thames Surrey | United Kingdom | British | 51202980001 | |||||
| CHAPMAN, Lyndon Douglas | Director | 2 Greenmead Cottage Henfield Road BN6 9DB Albourne West Sussex | United Kingdom | British | 95006010001 | |||||
| CHAPMAN, Lyndon Douglas | Director | 2 Greenmead Cottage Henfield Road BN6 9DB Albourne West Sussex | United Kingdom | British | 95006010001 | |||||
| CROSBY, Julie | Director | 311 Newmarket Road CB5 8JE Cambridge | British | 97478920001 | ||||||
| DEL POZO MENOR, Oscar | Director | Santiago De Compostela 12 1st Floor 48003 Bilbao Panda Security S.L. Spain | Spain | Spanish | 256246680001 | |||||
| EDWARDS, Stephen | Director | 1 Cam Close PE27 3FG St. Ives Cambridgeshire | British | 74301870001 | ||||||
| GARCIA AGUSTIN, Juan Andres | Director | 28009 Madrid C/Lope De Rueda 45, Spain | Spain | Spanish | 139546790001 | |||||
| GARCIA CHECA, Jose Fernando | Director | Hillswood Drive KT16 0RS Chertsey 3000 England | Spain | Spanish | 205500940001 | |||||
| GIANNOTTA, Simon | Director | 28 Carter Close SL4 3QX Windsor Berkshire | United Kingdom | British | 103689920002 | |||||
| HALE, Ian Edward | Director | 15 Beaumont Vale CB9 8QG Haverhill Suffolk | British | 76302170002 | ||||||
| HALLWORTH, Simon Jeremy | Director | Clifford House 5 High Street BN6 9TT Hurstpierpoint West Sussex | England | British | 61732800002 | |||||
| HOLMES, Peter James | Director | Meadow View 5a Mill Common PE29 3AU Huntingdon Cambs | England | British | 97375340001 | |||||
| HOSKINS, Dominic | Director | 1 Oldwood Chase Southwood GU14 0QS Farnborough Hampshire | British | 124512680001 | ||||||
| LAUTIN, Petter | Director | Opladen Way RG12 0PH Bracknell Lavenir Berkshire | United Kingdom | Norwegian | 65681210007 | |||||
| LEE, Antony Richard | Director | Bourne Business Park 5 Dashwood Lang Road KT15 2HJ Weybridge 500 England | England | British | 109740640001 | |||||
| MANRIQUE DE LARA FERNANDEZ, Ignacio | Director | C/La Maso 99 28034 Madrid Madrid Spain | Spain | Spanish | 139651450001 | |||||
| MAYORALAS ALISES, Santiago | Director | Hillswood Drive KT16 0RS Chertsey 3000 England | Spain | Spanish | 220972690001 | |||||
| NAVARRETE IACOBI, Diego Ian | Director | Opladen Way RG12 0PH Bracknell Lavenir Berkshire | Spain | Spanish | 199342400001 | |||||
| PEREZ, Juan Santana | Director | 28760 Tres Cantos Madrid C/Ronda De Poniente 17 Spain | Spain | Spanish | 148636550001 | |||||
| PORTEUS, Emmaly Jayne | Director | 19 Fairfield Road RH15 8QB Burgess Hill West Sussex | British | 122692590001 | ||||||
| PRICE, Mark Thomas | Director | 95 Teversham Drift CB1 3LL Cambridge Cambridgeshire | British | 97479010001 | ||||||
| REAY, David Alan | Director | 41 Pepperslade Duxford CB2 4XT Cambridge Cambridgeshire | British | 98636900001 | ||||||
| ROBERTS, Anthony | Director | 94a London Road RH15 8NB Burgess Hill West Sussex | British | 124511550001 | ||||||
| SANTAMARIA URIARTE, Juan | Director | Bourne Business Park 5 Dashwood Lang Road KT15 2HJ Weybridge 500 England | Spain | Spanish | 243078490001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de PANDA SECURITY UK LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gala Capital Partners Equity Scr S. A. | 06 abr 2016 | Serrano Madrid 57 Spain | Sí | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Mr Jose Sancho Garcia | 06 abr 2016 | Santiago De Compostela 48003 Bilbao 12 Spain | Sí | ||||||||||
Nacionalidad: Spanish País de residencia: Spain | |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Cuáles son las últimas declaraciones sobre personas con control significativo para PANDA SECURITY UK LIMITED?
| Notificado el | Cesado el | Declaración |
|---|---|---|
| 26 abr 2021 | La empresa sabe o tiene motivos razonables para creer que no existe ninguna persona registrable o entidad jurídica relevante registrable en relación con la empresa. |
¿Tiene PANDA SECURITY UK LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| All assets debenture | Creado el 25 jun 2010 Entregado el 29 jun 2010 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 07 may 2010 Entregado el 20 may 2010 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 06 abr 2009 Entregado el 16 abr 2009 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 29 nov 2005 Entregado el 30 nov 2005 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Rent deposit deed | Creado el 15 jul 2005 Entregado el 26 jul 2005 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada £17,986.31 due or to become due from the company to | |
Breve descripción £17,986.31 and interest accruing in a deposit account. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 13 nov 2001 Entregado el 15 nov 2001 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Fixed and floating charge | Creado el 28 mar 2000 Entregado el 11 abr 2000 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee arising under a factoring agreement | |
Breve descripción (I) by way of fixed charge any present or future debt the ownership of which fail to vest absolutely and effectively in the security holder for any reason together with the related rights (the factored debts) and (ii) all amounts of indebtedness due to the company on any account whatsoever other than the factored debts (the other debts).by way of floating charge all the undertaking and all the property rights and assets. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
¿Tiene PANDA SECURITY UK LIMITED algún caso de insolvencia?
| Número de expediente | Fechas | Tipo | Profesionales | Otro | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidación voluntaria de socios |
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0