SELECT CARE SERVICES (BIRMINGHAM) LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | SELECT CARE SERVICES (BIRMINGHAM) LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 03762419 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de SELECT CARE SERVICES (BIRMINGHAM) LIMITED?
- Otras actividades de asistencia sanitaria (86900) / Actividades sanitarias y de asistencia social
¿Dónde se encuentra SELECT CARE SERVICES (BIRMINGHAM) LIMITED?
| Dirección de la sede social | Connaught House 850 The Crescent Colchester Business Park CO4 9QB Colchester Essex United Kingdom |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles son las últimas cuentas de SELECT CARE SERVICES (BIRMINGHAM) LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 30 sept 2011 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para SELECT CARE SERVICES (BIRMINGHAM) LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Angela Culhane como director el 25 jun 2012 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 30 sept 2011 | 17 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 17 abr 2012 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Nombramiento de Jonathan David Calow como secretario el 08 dic 2011 | 1 páginas | AP03 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Care Uk Services Ltd como secretario el 08 dic 2011 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 17 abr 2011 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de Connaught House the Crescent Colchester Business Park Colchester Essex CO4 9QB el 03 may 2011 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Paul Justin Humphreys el 01 abr 2011 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 30 sept 2010 | 17 páginas | AA | ||||||||||
Nombramiento de Paul John Watson como director | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Michael Robert Parish el 10 ago 2010 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
legacy | 3 páginas | MG02 | ||||||||||
legacy | 3 páginas | MG02 | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 12 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 28 páginas | MG01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 30 sept 2009 | 17 páginas | AA | ||||||||||
Nombramiento de Deborah Jane Marriott-Boam como director | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Geoffrey Benn como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 17 abr 2010 avec liste complète des actionnaires | 6 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cambio de datos del secretario Care Uk Services Ltd el 01 abr 2010 | 2 páginas | CH04 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Douglas Umbers como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Angela Hector Culhane como director | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de SELECT CARE SERVICES (BIRMINGHAM) LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CALOW, Jonathan David | Secretario | 850 The Crescent Colchester Business Park CO4 9QB Colchester Connaught House Essex United Kingdom | 165633600001 | |||||||||||
| HUMPHREYS, Paul Justin | Director | 850 The Crescent Colchester Business Park CO4 9QB Colchester Connaught House Essex United Kingdom | United Kingdom | British | 33223550003 | |||||||||
| MARRIOTT-BOAM, Deborah Jane | Director | 850 The Crescent Colchester Business Park CO4 9QB Colchester Connaught House Essex United Kingdom | United Kingdom | British | 151689670001 | |||||||||
| PARISH, Michael Robert | Director | 850 The Crescent Colchester Business Park CO4 9QB Colchester Connaught House Essex United Kingdom | England | British | 78828750003 | |||||||||
| WATSON, Paul John | Director | 850 The Crescent Colchester Business Park CO4 9QB Colchester Connaught House Essex United Kingdom | United Kingdom | British | 82460360003 | |||||||||
| BURKE, Michael Anthony | Secretario | 1446 Stratford Road B28 9ES Birmingham West Midlands | British | 101343700001 | ||||||||||
| GEORGE, Valerie Grace | Secretario | 1446 Stratford Road Hall Green B28 9ES Birmingham | British | 66299990002 | ||||||||||
| HUMPHREYS, Paul Justin | Secretario | Hall Barn Creeting Hall Farm Creeting Saint Peter IP6 8QZ Ipswich Suffolk | British | 33223550003 | ||||||||||
| CARE UK SERVICES LTD | Secretario corporativo | 850 The Crescent Colchester Business Park CO4 9QB Colchester Connaught House Essex United Kingdom |
| 125241530002 | ||||||||||
| JPCORS LIMITED | Secretario designado corporativo | Suite 17 City Business Centre Lower Road SE16 2XB London | 900001430001 | |||||||||||
| BENN, Geoffrey Richard | Director | 15 Mimosa Close CM1 6NW Chelmsford Essex | England | British | 73786580001 | |||||||||
| BOOKER, Roger Ian | Director | Fairview 17a Queens Road WA15 9HF Hale Cheshire | United Kingdom | British | 14044530003 | |||||||||
| BURKE, Michael Anthony | Director | 1446 Stratford Road B28 9ES Birmingham West Midlands | British | 101343700001 | ||||||||||
| BURKE, Michelle Deborah | Director | 1446 Stratford Road Hall Green B28 9ES Birmingham West Midlands | British | 66299740002 | ||||||||||
| CULHANE, Angela | Director | 850 The Crescent Colchester Business Park CO4 9QB Colchester Connaught House Essex United Kingdom | England | British | 68602910001 | |||||||||
| GEORGE, Valerie Grace | Director | 1446 Stratford Road Hall Green B28 9ES Birmingham | British | 66299990002 | ||||||||||
| HASTINGS, Roy | Director | Wallis Road RG21 3DN Basingstoke 20 Hampshire | United Kingdom | British | 130098430001 | |||||||||
| QUINN, David Laurence, Mr. | Director | 6 Whitecross Road HP17 8BA Haddenham Buckinghamshire | England | British | 123356660001 | |||||||||
| UMBERS, Douglas | Director | SO53 | United Kingdom | British | 90541690001 | |||||||||
| VOCKINS, Anthony Frederick | Director | 4 Main Street Croxton Kerrial NG32 1QF Grantham The Old Post Office Lincolnshire | England | British | 130512090002 | |||||||||
| JPCORD LIMITED | Director designado corporativo | Suite 17 City Business Centre Lower Road SE16 2XB London | 900001420001 |
¿Tiene SELECT CARE SERVICES (BIRMINGHAM) LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Creado el 21 jul 2010 Entregado el 26 jul 2010 | Pendiente | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción Fixed and floating charge over all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. See image for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 16 mar 2007 Entregado el 04 abr 2007 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 22 sept 2006 Entregado el 29 sept 2006 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to any beneficiary on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Legal charge | Creado el 24 oct 2003 Entregado el 12 nov 2003 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción The property known as maple leaf lodge redhill road forhill. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 12 jul 1999 Entregado el 13 jul 1999 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0