SELECT CARE SERVICES (BIRMINGHAM) LIMITED

SELECT CARE SERVICES (BIRMINGHAM) LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaSELECT CARE SERVICES (BIRMINGHAM) LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 03762419
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de SELECT CARE SERVICES (BIRMINGHAM) LIMITED?

    • Otras actividades de asistencia sanitaria (86900) / Actividades sanitarias y de asistencia social

    ¿Dónde se encuentra SELECT CARE SERVICES (BIRMINGHAM) LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Connaught House 850 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Essex
    United Kingdom
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de SELECT CARE SERVICES (BIRMINGHAM) LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta30 sept 2011

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para SELECT CARE SERVICES (BIRMINGHAM) LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Cese del nombramiento de Angela Culhane como director el 25 jun 2012

    1 páginasTM01

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 sept 2011

    17 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 17 abr 2012 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital19 abr 2012

    Estado de capital el 19 abr 2012

    • Capital: GBP 1,350
    SH01

    Nombramiento de Jonathan David Calow como secretario el 08 dic 2011

    1 páginasAP03

    Cese del nombramiento de Care Uk Services Ltd como secretario el 08 dic 2011

    1 páginasTM02

    Déclaration annuelle établie au 17 abr 2011 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01

    Domicilio social registrado cambiado de Connaught House the Crescent Colchester Business Park Colchester Essex CO4 9QB el 03 may 2011

    1 páginasAD01

    Cambio de datos del director Paul Justin Humphreys el 01 abr 2011

    2 páginasCH01

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 sept 2010

    17 páginasAA

    Nombramiento de Paul John Watson como director

    2 páginasAP01

    Cambio de datos del director Michael Robert Parish el 10 ago 2010

    2 páginasCH01

    legacy

    3 páginasMG02

    legacy

    3 páginasMG02

    Resoluciones

    Resolutions
    12 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    incorporation

    Resolución de modificación de los Artículos de Asociación

    RES01

    legacy

    28 páginasMG01

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 sept 2009

    17 páginasAA

    Nombramiento de Deborah Jane Marriott-Boam como director

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Geoffrey Benn como director

    1 páginasTM01

    Déclaration annuelle établie au 17 abr 2010 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01
    Anotaciones
    FechaAnotación
    31 oct 2025Other Any information marked (#) was made unavailable on 31/10/2025 under section 1088 of the Companies Act 2006.

    Cambio de datos del secretario Care Uk Services Ltd el 01 abr 2010

    2 páginasCH04

    Cese del nombramiento de Douglas Umbers como director

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Angela Hector Culhane como director

    2 páginasAP01

    ¿Quiénes son los directivos de SELECT CARE SERVICES (BIRMINGHAM) LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    CALOW, Jonathan David
    850 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Connaught House
    Essex
    United Kingdom
    Secretario
    850 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Connaught House
    Essex
    United Kingdom
    165633600001
    HUMPHREYS, Paul Justin
    850 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Connaught House
    Essex
    United Kingdom
    Director
    850 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Connaught House
    Essex
    United Kingdom
    United KingdomBritish33223550003
    MARRIOTT-BOAM, Deborah Jane
    850 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Connaught House
    Essex
    United Kingdom
    Director
    850 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Connaught House
    Essex
    United Kingdom
    United KingdomBritish151689670001
    PARISH, Michael Robert
    850 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Connaught House
    Essex
    United Kingdom
    Director
    850 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Connaught House
    Essex
    United Kingdom
    EnglandBritish78828750003
    WATSON, Paul John
    850 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Connaught House
    Essex
    United Kingdom
    Director
    850 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Connaught House
    Essex
    United Kingdom
    United KingdomBritish82460360003
    BURKE, Michael Anthony
    1446 Stratford Road
    B28 9ES Birmingham
    West Midlands
    Secretario
    1446 Stratford Road
    B28 9ES Birmingham
    West Midlands
    British101343700001
    GEORGE, Valerie Grace
    1446 Stratford Road
    Hall Green
    B28 9ES Birmingham
    Secretario
    1446 Stratford Road
    Hall Green
    B28 9ES Birmingham
    British66299990002
    HUMPHREYS, Paul Justin
    Hall Barn Creeting Hall Farm
    Creeting Saint Peter
    IP6 8QZ Ipswich
    Suffolk
    Secretario
    Hall Barn Creeting Hall Farm
    Creeting Saint Peter
    IP6 8QZ Ipswich
    Suffolk
    British33223550003
    CARE UK SERVICES LTD
    850 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Connaught House
    Essex
    United Kingdom
    Secretario corporativo
    850 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Connaught House
    Essex
    United Kingdom
    Tipo de identificaciónEEE
    Número de registro2482660
    125241530002
    JPCORS LIMITED
    Suite 17 City Business Centre
    Lower Road
    SE16 2XB London
    Secretario designado corporativo
    Suite 17 City Business Centre
    Lower Road
    SE16 2XB London
    900001430001
    BENN, Geoffrey Richard
    15 Mimosa Close
    CM1 6NW Chelmsford
    Essex
    Director
    15 Mimosa Close
    CM1 6NW Chelmsford
    Essex
    EnglandBritish73786580001
    BOOKER, Roger Ian
    Fairview
    17a Queens Road
    WA15 9HF Hale
    Cheshire
    Director
    Fairview
    17a Queens Road
    WA15 9HF Hale
    Cheshire
    United KingdomBritish14044530003
    BURKE, Michael Anthony
    1446 Stratford Road
    B28 9ES Birmingham
    West Midlands
    Director
    1446 Stratford Road
    B28 9ES Birmingham
    West Midlands
    British101343700001
    BURKE, Michelle Deborah
    1446 Stratford Road
    Hall Green
    B28 9ES Birmingham
    West Midlands
    Director
    1446 Stratford Road
    Hall Green
    B28 9ES Birmingham
    West Midlands
    British66299740002
    CULHANE, Angela
    850 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Connaught House
    Essex
    United Kingdom
    Director
    850 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Connaught House
    Essex
    United Kingdom
    EnglandBritish68602910001
    GEORGE, Valerie Grace
    1446 Stratford Road
    Hall Green
    B28 9ES Birmingham
    Director
    1446 Stratford Road
    Hall Green
    B28 9ES Birmingham
    British66299990002
    HASTINGS, Roy
    Wallis Road
    RG21 3DN Basingstoke
    20
    Hampshire
    Director
    Wallis Road
    RG21 3DN Basingstoke
    20
    Hampshire
    United KingdomBritish130098430001
    QUINN, David Laurence, Mr.
    6 Whitecross Road
    HP17 8BA Haddenham
    Buckinghamshire
    Director
    6 Whitecross Road
    HP17 8BA Haddenham
    Buckinghamshire
    EnglandBritish123356660001
    UMBERS, Douglas
    SO53
    Director
    SO53
    United KingdomBritish90541690001
    VOCKINS, Anthony Frederick
    4 Main Street
    Croxton Kerrial
    NG32 1QF Grantham
    The Old Post Office
    Lincolnshire
    Director
    4 Main Street
    Croxton Kerrial
    NG32 1QF Grantham
    The Old Post Office
    Lincolnshire
    EnglandBritish130512090002
    JPCORD LIMITED
    Suite 17 City Business Centre
    Lower Road
    SE16 2XB London
    Director designado corporativo
    Suite 17 City Business Centre
    Lower Road
    SE16 2XB London
    900001420001

    ¿Tiene SELECT CARE SERVICES (BIRMINGHAM) LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Debenture
    Creado el 21 jul 2010
    Entregado el 26 jul 2010
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. See image for full details.
    Personas con derecho
    • Ing Bank Nv, London Branch (As Security Agent)
    Transacciones
    • 26 jul 2010Registro de un cargo (MG01)
    Debenture
    Creado el 16 mar 2007
    Entregado el 04 abr 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 04 abr 2007Registro de un cargo (395)
    • 28 jul 2010Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Debenture
    Creado el 22 sept 2006
    Entregado el 29 sept 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to any beneficiary on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (The "Security Trustee")
    Transacciones
    • 29 sept 2006Registro de un cargo (395)
    • 28 jul 2010Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Legal charge
    Creado el 24 oct 2003
    Entregado el 12 nov 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    The property known as maple leaf lodge redhill road forhill. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 12 nov 2003Registro de un cargo (395)
    • 04 may 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 12 jul 1999
    Entregado el 13 jul 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 13 jul 1999Registro de un cargo (395)
    • 28 ene 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0