SABIC UK PETROCHEMICALS LIMITED

SABIC UK PETROCHEMICALS LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración de confirmación
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaSABIC UK PETROCHEMICALS LIMITED
    Estado de la empresaActiva
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 03767075
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenesNo
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de SABIC UK PETROCHEMICALS LIMITED?

    • fabricación de otros productos químicos básicos orgánicos (20140) / Industrias manufactureras

    ¿Dónde se encuentra SABIC UK PETROCHEMICALS LIMITED?

    Dirección de la sede social
    The Wilton Centre
    Wilton
    TS10 4RF Redcar
    Cleveland
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de SABIC UK PETROCHEMICALS LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    HUNTSMAN PETROCHEMICALS (UK) LIMITED28 nov 200028 nov 2000
    HUNTSMAN ICI PETROCHEMICALS (UK) LIMITED05 may 199905 may 1999

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de SABIC UK PETROCHEMICALS LIMITED?

    VencidoNo
    Próximas cuentas
    Próximo período contable finaliza el31 dic 2025
    Próximas cuentas vencen el30 sept 2026
    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2024

    ¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para SABIC UK PETROCHEMICALS LIMITED?

    Última declaración de confirmación cerrada hasta19 sept 2026
    Próxima declaración de confirmación vence03 oct 2026
    Última declaración de confirmación
    Próxima declaración de confirmación cerrada hasta19 sept 2025
    VencidoNo

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para SABIC UK PETROCHEMICALS LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2024

    52 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 19 sept 2025 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2023

    53 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 19 sept 2024 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cese del nombramiento de John Middleton como secretario el 29 feb 2024

    1 páginasTM02

    Cese del nombramiento de John Christopher Middleton como director el 29 feb 2024

    1 páginasTM01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2022

    52 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 20 sept 2023 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2021

    51 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 08 sept 2022 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cese del nombramiento de Daren Smith como director el 24 jun 2022

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Johannes Bernardus Maria Visser como director el 16 jun 2022

    2 páginasAP01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2020

    52 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 05 oct 2021 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Declaración de confirmación presentada el 08 sept 2020 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2019

    61 páginasAA

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2018

    53 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 03 jul 2019 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2017

    53 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 29 jun 2018 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cese del nombramiento de Jan Bruijnooge como director el 03 ene 2018

    1 páginasTM01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2016

    49 páginasAA

    Nombramiento de Daren Smith como director el 02 oct 2017

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Omar Saeed Badahdah como director el 02 oct 2017

    1 páginasTM01

    Declaración de confirmación presentada el 04 may 2017 con actualizaciones

    6 páginasCS01

    ¿Quiénes son los directivos de SABIC UK PETROCHEMICALS LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    GRANT, Ronald Napier
    Hemingford Gardens
    TS15 9ST Yarm
    24
    Cleveland
    United Kingdom
    Director
    Hemingford Gardens
    TS15 9ST Yarm
    24
    Cleveland
    United Kingdom
    EnglandBritish129418770001
    VISSER, Johannes Bernardus Maria
    The Wilton Centre
    Wilton
    TS10 4RF Redcar
    Cleveland
    Director
    The Wilton Centre
    Wilton
    TS10 4RF Redcar
    Cleveland
    EnglandDutch297039940001
    BUSBY, David John
    5 Nightingale Square
    SW12 8QJ London
    Secretario
    5 Nightingale Square
    SW12 8QJ London
    British11450940001
    CHEATLE, Penelope Anne
    19 Wellsmoor Gardens
    BR1 2HT Bickley
    Kent
    Secretario
    19 Wellsmoor Gardens
    BR1 2HT Bickley
    Kent
    British34645590005
    GRAHAM, Christopher
    Glenluce
    Birtley Chester Le Street
    DH3 2HY Durham
    66
    England
    United Kingdom
    Secretario
    Glenluce
    Birtley Chester Le Street
    DH3 2HY Durham
    66
    England
    United Kingdom
    British61088970002
    KAY, John Lawrence
    Wabun Garbutts Lane
    Hutton Rudby
    TS15 0DL Yarm
    Cleveland
    Secretario
    Wabun Garbutts Lane
    Hutton Rudby
    TS15 0DL Yarm
    Cleveland
    British20420080001
    MAUGHAN, Michael Andrew James
    55 Percy Park
    NE30 4JX North Shields
    Tyne & Wear
    Secretario
    55 Percy Park
    NE30 4JX North Shields
    Tyne & Wear
    British73866690001
    MIDDLETON, John
    Herefordshire Drive
    Belmont
    DH1 2DQ Durham
    20
    England
    England
    Secretario
    Herefordshire Drive
    Belmont
    DH1 2DQ Durham
    20
    England
    England
    156907290001
    BADAHDAH, Omar Saeed
    The Wilton Centre
    Wilton
    TS10 4RF Redcar
    Cleveland
    Director
    The Wilton Centre
    Wilton
    TS10 4RF Redcar
    Cleveland
    NetherlandsSaudi Arabian219907810001
    BAZID, Abdullah Saeed Mohammed
    Moorselboslaan 23
    Tervuren
    3080
    Belgium
    Director
    Moorselboslaan 23
    Tervuren
    3080
    Belgium
    Saudi116062180001
    BOOTH, Paul
    27 Clockwood Gardens
    TS13 9RW Yarm
    Cedar House
    Director
    27 Clockwood Gardens
    TS13 9RW Yarm
    Cedar House
    United KingdomBritish135500080001
    BRUIJNOOGE, Jan
    The Wilton Centre
    Wilton
    TS10 4RF Redcar
    Cleveland
    Director
    The Wilton Centre
    Wilton
    TS10 4RF Redcar
    Cleveland
    EnglandDutch219908490001
    CHEATLE, Penelope Anne
    19 Wellsmoor Gardens
    BR1 2HT Bickley
    Kent
    Director
    19 Wellsmoor Gardens
    BR1 2HT Bickley
    Kent
    British34645590005
    CORNES, Peter Leslie, Dr
    White Cottage
    Pinchinthorpe
    TS14 8HE Guisborough
    Cleveland
    Director
    White Cottage
    Pinchinthorpe
    TS14 8HE Guisborough
    Cleveland
    United KingdomBritish74991140001
    DEN HOLDER, Johan
    The Wilton Centre
    Wilton
    TS10 4RF Redcar
    Cleveland
    Director
    The Wilton Centre
    Wilton
    TS10 4RF Redcar
    Cleveland
    EnglandDutch185220880001
    DUCKER, Michael Edward
    Knayton
    Y07 4AZ Thirsk
    Maynooth Grange
    North Yorkshire
    England
    Director
    Knayton
    Y07 4AZ Thirsk
    Maynooth Grange
    North Yorkshire
    England
    EnglandBritish119078530001
    EMERSON, Duncan
    6 Mile Planting
    DL10 5DB Richmond
    North Yorkshire
    Director
    6 Mile Planting
    DL10 5DB Richmond
    North Yorkshire
    British65305300002
    ESPLIN, Kimo
    2305 Lorita Way
    UTAH Sandy
    Ut 84093
    Usa
    Director
    2305 Lorita Way
    UTAH Sandy
    Ut 84093
    Usa
    UsaAmerican65184810002
    GILLETT, Philip John
    Cedar House
    Rockfield Road
    RH8 0EJ Oxted
    Surrey
    Director
    Cedar House
    Rockfield Road
    RH8 0EJ Oxted
    Surrey
    United KingdomBritish6838010001
    GRAHAM, Christopher
    Glenluce, Birtley
    Chester Le Street
    DH3 2HY Durham
    66
    England
    England
    Director
    Glenluce, Birtley
    Chester Le Street
    DH3 2HY Durham
    66
    England
    England
    EnglandBritish61088970002
    HEALY, Russell
    167 West 1475 North
    Centerville
    Utah
    84014
    Usa
    Director
    167 West 1475 North
    Centerville
    Utah
    84014
    Usa
    UsaAmerican65184510001
    HUNTSMAN, Peter Riley
    51 Silver Iris
    The Woodlands
    Texas 77382
    U S A
    Director
    51 Silver Iris
    The Woodlands
    Texas 77382
    U S A
    United StatesAmerican65184190009
    KAY, John Lawrence
    Wabun Garbutts Lane
    Hutton Rudby
    TS15 0DL Yarm
    Cleveland
    Director
    Wabun Garbutts Lane
    Hutton Rudby
    TS15 0DL Yarm
    Cleveland
    EnglandBritish20420080001
    KEENAN, Thomas James
    10 Worsall Road
    TS15 9DF Yarm
    Director
    10 Worsall Road
    TS15 9DF Yarm
    American101126350001
    LITJENS, Matheus Wilhelmus Garardus
    Strabachof 3
    Voerendaal
    6367de
    The Netherlands
    Director
    Strabachof 3
    Voerendaal
    6367de
    The Netherlands
    Dutch116062110001
    MAUGHAN, Michael Andrew James
    55 Percy Park
    NE30 4JX North Shields
    Tyne & Wear
    Director
    55 Percy Park
    NE30 4JX North Shields
    Tyne & Wear
    EnglandBritish73866690001
    MEESSEN, Hubertus Henricus Josephus
    6132 Ah Sittard
    Charles Beltjenslaan 22
    The Netherlands
    Director
    6132 Ah Sittard
    Charles Beltjenslaan 22
    The Netherlands
    The NetherlandsDutch148356740001
    MIDDLETON, John Christopher
    Herefordshire Drive
    Belmont
    DH1 2DQ Durham
    20
    England
    England
    Director
    Herefordshire Drive
    Belmont
    DH1 2DQ Durham
    20
    England
    England
    EnglandBritish156925020001
    MUELLER, Michael Alfred, Dr
    The Wilton Centre
    Wilton
    TS10 4RF Redcar
    Cleveland
    Director
    The Wilton Centre
    Wilton
    TS10 4RF Redcar
    Cleveland
    GermanyGerman148333240001
    NINOW, Kevin John
    2 Peony Springs Court
    The Woodlands
    Tx 77382
    Usa
    Director
    2 Peony Springs Court
    The Woodlands
    Tx 77382
    Usa
    American66483000006
    O'NEILL, John Ellison
    23 Lenamore Avenue
    BT37 0PF Jordanstown
    Director
    23 Lenamore Avenue
    BT37 0PF Jordanstown
    British123812690001
    O'NEILL, John Ellison
    70a The High Street
    Swainby
    DL6 3DG Northallerton
    North Yorkshire
    Director
    70a The High Street
    Swainby
    DL6 3DG Northallerton
    North Yorkshire
    British100992120001
    OHALI, Mosaed Sulaiman A Al
    Heugemerweg 42d
    6221 Gj Maastricht
    The Netherlands
    Director
    Heugemerweg 42d
    6221 Gj Maastricht
    The Netherlands
    Saudi127890240001
    SHOVLIN, Thomas Anthony
    23 Forest Lane
    Kirklevington
    TS15 9LX Yarm
    Cleveland
    Director
    23 Forest Lane
    Kirklevington
    TS15 9LX Yarm
    Cleveland
    British56330750001
    SLABBERS, Jacobus Henricus Johanna Maria
    Bronnenberg 8
    Herkenbosch
    6075 Cw
    The Netherlands
    Director
    Bronnenberg 8
    Herkenbosch
    6075 Cw
    The Netherlands
    Dutch118085780001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de SABIC UK PETROCHEMICALS LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Wilton
    TS10 4RF Redcar
    Wilton Centre
    Cleveland
    England
    06 abr 2016
    Wilton
    TS10 4RF Redcar
    Wilton Centre
    Cleveland
    England
    No
    Forma jurídicaPrivate Company Limited By Shares
    País de registroUnited Kingdom
    Autoridad legalCompanies Act 1985
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro06009440
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0