STREAMFOODS LTD

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaSTREAMFOODS LTD
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 03771000
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de STREAMFOODS LTD?

    • Fabricación de otros productos alimenticios, n.c.o.p. (10890) / Industrias manufactureras

    ¿Dónde se encuentra STREAMFOODS LTD?

    Dirección de la sede social
    40 Bradfield Road
    Finedon Road Industrial Estate
    NN8 4HB Wellingborough
    Northamptonshire
    England
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de STREAMFOODS LTD?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2021

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para STREAMFOODS LTD?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    La acción de exclusión voluntaria ha sido suspendida

    1 páginasSOAS(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    1 páginasDS01

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación obligatoria

    1 páginasGAZ1

    Nombramiento de Mr Deon Joubert como secretario el 03 feb 2023

    2 páginasAP03

    Nombramiento de Mr Deon Joubert como director el 03 feb 2023

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Steven Daniel Goodes como director el 03 feb 2023

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Felix Lombard como director el 03 feb 2023

    1 páginasTM01

    Cancelación total de la carga 037710000013

    1 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 5

    1 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 6

    1 páginasMR04

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2021

    11 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 14 may 2022 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2020

    22 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 14 may 2021 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    Estado de capital el 21 abr 2021

    • Capital: GBP 1
    5 páginasSH19

    legacy

    1 páginasSH20

    legacy

    2 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06
    capital

    Resoluciones

    Reduce share prem a/c 24/12/2020
    RES13

    Exercice comptable en cours prolongé du 30 sept 2020 au 31 dic 2020

    1 páginasAA01

    Declaración de confirmación presentada el 14 may 2020 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cese del nombramiento de Thushen Agambaram Govender como director el 30 abr 2020

    1 páginasTM01

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 sept 2019

    35 páginasAA

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 sept 2018

    34 páginasAA

    ¿Quiénes son los directivos de STREAMFOODS LTD?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    GOODES, Steven Daniel
    Bradfield Road
    Finedon Road Industrial Estate
    NN8 4HB Wellingborough
    40
    Northamptonshire
    England
    Secretario
    Bradfield Road
    Finedon Road Industrial Estate
    NN8 4HB Wellingborough
    40
    Northamptonshire
    England
    236744200001
    JOUBERT, Deon
    Sanitarium Drive
    Berkeley Vale
    1
    New South Wales 2261
    Australia
    Secretario
    Sanitarium Drive
    Berkeley Vale
    1
    New South Wales 2261
    Australia
    305129160001
    JOUBERT, Deon
    Sanitarium Drive
    Berkeley Vale
    1
    New South Wales 2261
    Australia
    Director
    Sanitarium Drive
    Berkeley Vale
    1
    New South Wales 2261
    Australia
    AustraliaAustralian305129060001
    THORN, Jonathon Wilhelm
    Bradfield Road
    Finedon Road Industrial Estate
    NN8 4HB Wellingborough
    40
    Northamptonshire
    England
    Director
    Bradfield Road
    Finedon Road Industrial Estate
    NN8 4HB Wellingborough
    40
    Northamptonshire
    England
    EnglandBritish211294420001
    CRAIG, Andrea Harvey, Ms.
    Noak 4 Brow Of The Hill
    Leziate
    PE32 1EN Kings Lynn
    Norfolk
    Secretario
    Noak 4 Brow Of The Hill
    Leziate
    PE32 1EN Kings Lynn
    Norfolk
    British59469810001
    DING, Alison
    Westfield Rise Wormegay Road
    Blackborough End
    PE32 1SG Kings Lynn
    Norfolk
    Secretario
    Westfield Rise Wormegay Road
    Blackborough End
    PE32 1SG Kings Lynn
    Norfolk
    British58359950001
    HATHER, Jon
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 201
    United Kingdom
    Secretario
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 201
    United Kingdom
    British68848420004
    LANE, Mark John
    Bradfield Road
    Finedon Road Industrial Estate
    NN8 4HB Wellingborough
    40
    Northamptonshire
    England
    Secretario
    Bradfield Road
    Finedon Road Industrial Estate
    NN8 4HB Wellingborough
    40
    Northamptonshire
    England
    British151305720001
    THORN, Jonathon Wilhelm
    Bradfield Road
    Finedon Road Industrial Estate
    NN8 4HB Wellingborough
    40
    Northamptonshire
    England
    Secretario
    Bradfield Road
    Finedon Road Industrial Estate
    NN8 4HB Wellingborough
    40
    Northamptonshire
    England
    211303240001
    RM REGISTRARS LIMITED
    Second Floor
    80 Great Eastern Street
    EC2A 3RX London
    Secretario designado corporativo
    Second Floor
    80 Great Eastern Street
    EC2A 3RX London
    900000760001
    CHARLES, Gavin
    Westfield
    Gipsy Lane
    RG40 2HP Wokingham
    Berkshire
    Director
    Westfield
    Gipsy Lane
    RG40 2HP Wokingham
    Berkshire
    EnglandBritish120029860002
    DING, Ian Charles
    West Field Rise Wormegay Road
    Blackborough End
    PE32 1SG Kings Lynn
    Norfolk
    Director
    West Field Rise Wormegay Road
    Blackborough End
    PE32 1SG Kings Lynn
    Norfolk
    EnglandBritish58359910001
    GLEN, Frederick Nairn
    The Well House
    RG7 2DJ Stratfield Saye
    Berkshire
    Director
    The Well House
    RG7 2DJ Stratfield Saye
    Berkshire
    United KingdomBritish72400610001
    GOODES, Steven Daniel
    Bradfield Road
    Finedon Road Industrial Estate
    NN8 4HB Wellingborough
    40
    Northamptonshire
    England
    Director
    Bradfield Road
    Finedon Road Industrial Estate
    NN8 4HB Wellingborough
    40
    Northamptonshire
    England
    EnglandBritish236743890001
    GOODING, Belinda
    16 Boxgrove Avenue
    GU1 1XG Guildford
    Surrey
    Director
    16 Boxgrove Avenue
    GU1 1XG Guildford
    Surrey
    United KingdomBritish109456400002
    GORDON, Alan George
    26 Wiverton Road
    SE26 5HY London
    Director
    26 Wiverton Road
    SE26 5HY London
    British42882550001
    GOVENDER, Thushen Agambaram
    Building 1, Sliver Stream Business Park
    10 Muswell Road
    Bryanston
    Ground Floor
    South Africa
    Director
    Building 1, Sliver Stream Business Park
    10 Muswell Road
    Bryanston
    Ground Floor
    South Africa
    South AfricaSouth African186889770001
    GUEST, Christopher Robert
    The Manor House
    Thorpe By Water
    LE15 9JQ Uppingham
    Leicestershire
    Director
    The Manor House
    Thorpe By Water
    LE15 9JQ Uppingham
    Leicestershire
    British31438630001
    HILES, John Matthews
    Bradfield Road
    Finedon Road Industrial Estate
    NN8 4HB Wellingborough
    40
    Northamptonshire
    England
    Director
    Bradfield Road
    Finedon Road Industrial Estate
    NN8 4HB Wellingborough
    40
    Northamptonshire
    England
    EnglandBritish173954820001
    LANE, Mark John
    Bradfield Road
    Finedon Road Industrial Estate
    NN8 4HB Wellingborough
    40
    Northamptonshire
    England
    Director
    Bradfield Road
    Finedon Road Industrial Estate
    NN8 4HB Wellingborough
    40
    Northamptonshire
    England
    EnglandBritish132183700002
    LOMBARD, Felix
    Glacier Place
    1 Sportica Cresent
    Tygervalley 7530
    Pioneer Foods
    South Africa
    Director
    Glacier Place
    1 Sportica Cresent
    Tygervalley 7530
    Pioneer Foods
    South Africa
    South AfricaSouth African238998300001
    MAGEE, Gerard Vincent
    Bradfield Road
    Finedon Road Industrial Estate
    NN8 4HB Wellingborough
    40
    Northamptonshire
    England
    Director
    Bradfield Road
    Finedon Road Industrial Estate
    NN8 4HB Wellingborough
    40
    Northamptonshire
    England
    IrelandIrish151272980001
    MCGILL, John
    Tiefields
    New Drove
    PE14 4UA Northbrink
    Cambs
    Director
    Tiefields
    New Drove
    PE14 4UA Northbrink
    Cambs
    British72400780001
    MYBURGH, Corni
    Bradfield Road
    Finedon Road Industrial Estate
    NN8 4HB Wellingborough
    40
    Northamptonshire
    England
    Director
    Bradfield Road
    Finedon Road Industrial Estate
    NN8 4HB Wellingborough
    40
    Northamptonshire
    England
    South AfricaSouth African236784340001
    NEWBERRY, Paul David
    White Lodge
    Maywood Drive, Portsmouth Road
    GU15 1LH Camberley
    Surrey
    Director
    White Lodge
    Maywood Drive, Portsmouth Road
    GU15 1LH Camberley
    Surrey
    EnglandBritish69243720001
    O'CONNOR, Philip Stephen
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 201
    United Kingdom
    Director
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 201
    United Kingdom
    EnglandIrish107745290001
    TOOMEY, John Francis
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 201
    United Kingdom
    Director
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 201
    United Kingdom
    EnglandIrish164624980001
    RM NOMINEES LIMITED
    Second Floor
    80 Great Eastern Street
    EC2A 3RX London
    Director designado corporativo
    Second Floor
    80 Great Eastern Street
    EC2A 3RX London
    900009140001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de STREAMFOODS LTD?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Bradfield Road
    Finedon Road Industrial Estate
    NN8 4HB Wellingborough
    40
    England
    29 jul 2016
    Bradfield Road
    Finedon Road Industrial Estate
    NN8 4HB Wellingborough
    40
    England
    No
    Forma jurídicaPrivate Limited Company
    País de registroEngland
    Autoridad legalCompanies Act 2006
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro04080435
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.

    ¿Tiene STREAMFOODS LTD alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    A registered charge
    Creado el 12 ago 2016
    Entregado el 18 ago 2016
    Satisfecho en su totalidad
    Breve descripción
    1) registered trademark: aneeq, registration number 2543822, filing date 31/03/2010, classes 29 and 30. 2) registered trademark: aroi, registration number 2543826, filing date 31/03/2010, classes 29 and 30. any additional intellectual property - see deed for further details.
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Rbs Invoice Finance Limited
    Transacciones
    • 18 ago 2016Registro de una carga (MR01)
    • 25 ene 2023Satisfacción de una carga (MR04)
    A supplemental deed
    Creado el 13 ene 2010
    Entregado el 14 ene 2010
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the obligors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor & Company of the Bank of Ireland
    Transacciones
    • 14 ene 2010Registro de un cargo (MG01)
    • 20 oct 2014Satisfacción de una carga (MR04)
    Composite debenture
    Creado el 24 dic 2009
    Entregado el 08 ene 2010
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All obligations and liabilities due or to become due from the obligors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed charge over any right title or interest in any land and all shareas related rights and all distribution rights thereon; all investments and related rights all book debts benefits and security thereon; all non trading debts and all benefits rights and security thereunder; fixed charge over all amounts standing to the credit of each account and any other amount; all property rights all fees royalties and other rights thereon; the goodwill and uncalled capital and benefit of all authorisations held in relation to any security interest; all insurances and floating charge over all undertaking and assets see image for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor & Company of the Bank of Ireland
    Transacciones
    • 08 ene 2010Registro de un cargo (MG01)
    • 20 oct 2014Satisfacción de una carga (MR04)
    Security accession deed
    Creado el 14 ene 2009
    Entregado el 27 ene 2009
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the obligors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Units a,b and c broadend industrial estate (also known as unit 5) t/no NK328879; fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, fixed plant & machinery. See image for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland (As Agent and Trustee for Itself and the Finance Parties)
    Transacciones
    • 27 ene 2009Registro de un cargo (395)
    • 20 oct 2014Satisfacción de una carga (MR04)
    Supplemental deed
    Creado el 14 mar 2008
    Entregado el 31 mar 2008
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the obligors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland (As Trustee for the Finance Parties) (the Security Trustee)
    Transacciones
    • 31 mar 2008Registro de un cargo (395)
    • 20 oct 2014Satisfacción de una carga (MR04)
    Security accession deed to a debenture dated 7 september 2006 and
    Creado el 28 feb 2007
    Entregado el 08 mar 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the obligors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland (As Trustee for the Finance Parties) (Securitytrustee)
    Transacciones
    • 08 mar 2007Registro de un cargo (395)
    • 20 oct 2014Satisfacción de una carga (MR04)
    Debenture
    Creado el 20 dic 2005
    Entregado el 29 dic 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 29 dic 2005Registro de un cargo (395)
    • 20 abr 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Rent deposit deed
    Creado el 23 sept 2005
    Entregado el 29 sept 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £9,693.75 due or to become due from the company to
    Breve descripción
    All of its right and entitlement to the funds held in the deposit account. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Beverley Patricia Emden
    Transacciones
    • 29 sept 2005Registro de un cargo (395)
    • 25 ene 2023Satisfacción de una carga (MR04)
    Rent deposit deed
    Creado el 14 jun 2005
    Entregado el 27 jun 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £8,812.50 due or to become due from the company to
    Breve descripción
    By way of first fixed legal charge all its right and entitlement to the deposit account from time to time and all interest cerdited to the deposit account.
    Personas con derecho
    • Beverley Patricia Emden
    Transacciones
    • 27 jun 2005Registro de un cargo (395)
    • 25 ene 2023Satisfacción de una carga (MR04)
    Legal charge
    Creado el 20 abr 2005
    Entregado el 05 may 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Breve descripción
    The property k/a units a b & c broadend road industrial estate walsoken wisbech cambs. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 05 may 2005Registro de un cargo (395)
    • 20 abr 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Chattel mortgage
    Creado el 27 ago 2004
    Entregado el 03 sept 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    All the plant, machinery, chattels or other equipment being, make line 3 fruit paste bar, model extruding machine, make cartoner, serial no 03-193's, make checkweighter, serial no B2319. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 03 sept 2004Registro de un cargo (395)
    • 30 oct 2015Satisfacción de una carga (MR04)
    Debenture
    Creado el 13 dic 2000
    Entregado el 15 dic 2000
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 15 dic 2000Registro de un cargo (395)
    • 20 abr 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 04 oct 2000
    Entregado el 11 oct 2000
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 11 oct 2000Registro de un cargo (395)
    • 12 mar 2002Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0