ALLIED DOMECQ LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | ALLIED DOMECQ LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Activa |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 03771147 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de ALLIED DOMECQ LIMITED?
- Actividades de oficinas centrales (70100) / Actividades profesionales, científicas y técnicas
¿Dónde se encuentra ALLIED DOMECQ LIMITED?
| Dirección de la sede social | 20 Montford Place Kennington SE11 5DE London England |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de ALLIED DOMECQ LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| ALLIED DOMECQ PLC | 02 ago 1999 | 02 ago 1999 |
| NEW ALLIED DOMECQ PLC | 28 may 1999 | 28 may 1999 |
| ALLIED DOMECQ 1999 PLC | 11 may 1999 | 11 may 1999 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de ALLIED DOMECQ LIMITED?
| Vencido | No |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 30 jun 2026 |
| Próximas cuentas vencen el | 31 mar 2027 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 30 jun 2025 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para ALLIED DOMECQ LIMITED?
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 11 may 2026 |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación vence | 25 may 2026 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 11 may 2025 |
| Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para ALLIED DOMECQ LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Cuentas completas preparadas hasta el 30 jun 2025 | 25 páginas | AA | ||
Nombramiento de Benjamin Jean Albert Granger como director el 26 ene 2026 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Edward Fells como director el 28 nov 2025 | 1 páginas | TM01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 11 may 2025 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 30 jun 2024 | 25 páginas | AA | ||
Cambio de datos del director Catherine Louise Thompson el 30 sept 2024 | 2 páginas | CH01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 11 may 2024 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 30 jun 2023 | 26 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 11 may 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 30 jun 2022 | 24 páginas | AA | ||
Cambio de datos del director Edward Fells el 19 oct 2022 | 2 páginas | CH01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 11 may 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cese del nombramiento de Stuart Macnab como director el 31 mar 2022 | 1 páginas | TM01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 30 jun 2021 | 25 páginas | AA | ||
Cambio de datos del director Catherine Louise Thompson el 01 sept 2021 | 2 páginas | CH01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 11 may 2021 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 30 jun 2020 | 22 páginas | AA | ||
Cambio de datos del director Edward Fells el 07 dic 2020 | 2 páginas | CH01 | ||
Nombramiento de Edward Fells como director el 01 oct 2020 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Vincent Turpin como director el 30 sept 2020 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de Amanda Hamilton-Stanley como director el 01 sept 2020 | 1 páginas | TM01 | ||
Domicilio social registrado cambiado de Chivas House 72 Chancellors Road London W6 9RS a 20 Montford Place Kennington London SE11 5DE el 01 jul 2020 | 1 páginas | AD01 | ||
Modification des détails de Goal Acquisitions (Holdings) Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 01 jul 2020 | 3 páginas | PSC05 | ||
Cambio de datos del director Catherine Louise Thompson el 10 ene 2020 | 2 páginas | CH01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 11 may 2020 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
¿Quiénes son los directivos de ALLIED DOMECQ LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMILEY, Alexander Hugh | Secretario | Montford Place Kennington SE11 5DE London 20 England | 258907960001 | |||||||
| GRANGER, Benjamin Jean Albert | Director | Montford Place Kennington SE11 5DE London 20 England | United Kingdom | French | 345185160001 | |||||
| MCKECHNIE, Stuart Andrew Ferrie | Director | Montford Place Kennington SE11 5DE London 20 England | Scotland | British | 264144930001 | |||||
| THOMPSON, Catherine Louise | Director | Montford Place Kennington SE11 5DE London 20 England | France | Australian | 258897310003 | |||||
| BROWN, Charles Bennett | Secretario | The Old Library High Street BS40 5QA Wrington Bristol Avon | British | 107840600001 | ||||||
| BURNS, Clive | Secretario | The Cottage Lamer Hill Gate Lower Gustard Wood AL4 8RX Wheathampstead Hertfordshire | British | 71073800001 | ||||||
| EGAN, Jane | Secretario | 11 Mccrorie Place PA10 2BF Kilbarchan Renfrewshire | British | 112277750001 | ||||||
| FITZSIMONS, Ian Terence | Secretario | 5 Rue Gounod, 75017 Paris | British | 116030190001 | ||||||
| KELLEY, Russell Phelps | Secretario | 206 Sussex Mansions 71-77 Old Brompton Road SW7 3JZ London | United States | 68327770001 | ||||||
| MACNAB, Stuart | Secretario | 6 Station Rise PA12 4NA Lochwinnoch Renfrewshire | British | 77024740001 | ||||||
| MAPPLEBECK, Ailsa Mary Robertson | Secretario | Chivas House 72 Chancellors Road W6 9RS London | 184016050001 | |||||||
| MITCHELL, David Smith | Secretario | 16 Walpole Gardens TW2 5SJ Twickenham Middlesex | British | 1970560001 | ||||||
| QUARANTO, Leonard Anthony | Secretario | Glebe House Naunton GL54 3AT Cheltenham | American | 77989690001 | ||||||
| HACKWOOD SECRETARIES LIMITED | Secretario designado corporativo | One Silk Street EC2Y 8HQ London | 900004790001 | |||||||
| ADAMS, Paul Nicholas | Director | Bowood Lodge Sebastopol Lane Sandhills GU8 5UG Godalming Surrey | British | 17187300004 | ||||||
| ANGELICI, Bruno Francois Jules | Director | 56 Wynnstay Gardens Allen Street W8 6UU London | French | 92693540001 | ||||||
| BABEAU, Emmanuel Andre Marie | Director | 7 Rue Paul Chatrousse, 92200 Neuilly Sur Seine France | French | 107414890001 | ||||||
| BOWMAN, Philip | Director | The Secretariat Department Allied Domecq Plc The Pavilions BS13 8AR Bridgwater Road Bedminster Down Bristol | Australian | 62693560005 | ||||||
| BRYDON, Donald Hood | Director | 7 Newgate Street EC1A 7NX London | United Kingdom | British | 46914650006 | |||||
| BUCKLAND, Ross, Sir | Director | 100 Gloucester Street The Rocks Sydney Nsw 2000 Australia | Australian | 11908840006 | ||||||
| BURNS, Clive | Director | The Cottage Lamer Hill Gate Lower Gustard Wood AL4 8RX Wheathampstead Hertfordshire | British | 71073800001 | ||||||
| BURROWS, Richard | Director | Dunseverick, Coast Road IRISH Portmarnock County Dublin Ireland | Irish | 77905730001 | ||||||
| FELLS, Edward | Director | Montford Place Kennington SE11 5DE London 20 England | United Kingdom | British | 274854930003 | |||||
| FETTER, Herve Denis Michel | Director | Chivas House 72 Chancellors Road W6 9RS London | England | French | 133848930001 | |||||
| FITZSIMONS, Ian Terence | Director | Chivas House 72 Chancellors Road W6 9RS London | United Kingdom | British | 116030190003 | |||||
| FLAISSIER, Yves Virgile Michel | Director | 11 Chemin Du Parc De Charonne 75020 FOREIGN Paris | French | 107756520001 | ||||||
| HAMILTON-STANLEY, Amanda | Director | Montford Place Kennington SE11 5DE London 20 England | England | British | 128721240001 | |||||
| HETHERINGTON, Graham Charles | Director | Heights West Harting GU31 5PA Petersfield Hampshire | British | 49219850003 | ||||||
| HOGG, Christopher Anthony, Sir | Director | Flat 3 51 South Street W1K 2XL London | United Kingdom | British | 9006020004 | |||||
| JACOBS, Peter Alan | Director | Garden Flat 29 Daleham Gardens NW3 5BY London | England | British | 124007460001 | |||||
| JETHA, Aziz | Director | 10 Grove Road HA5 5HW Pinner Middlesex | United Kingdom | British | 1186770001 | |||||
| MACNAB, Stuart | Director | Montford Place Kennington SE11 5DE London 20 England | United Kingdom | British | 77024740001 | |||||
| MALPAS, Alfred David | Director | Holborn Farm House Therfield SG8 9HR Royston Herts | United Kingdom | British | 35649260001 | |||||
| MARTIN, Todd David | Director | 3616 Maplewood Avenue 75205 Dallas Texas Usa | American | 57979880001 | ||||||
| MCCARTHY, George Fredrick, Chairman | Director | 29 Pheasant Lane Greenwich Fairfield 06830 Usa | American | 103871250001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de ALLIED DOMECQ LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goal Acquisitions (Holdings) Limited | 06 abr 2016 | Montford Place Kennington SE11 5DE London 20 England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0