PENNANT SOFTWARE SERVICES LIMITED

PENNANT SOFTWARE SERVICES LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaPENNANT SOFTWARE SERVICES LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 03772667
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de PENNANT SOFTWARE SERVICES LIMITED?

    • Desarrollo de software para negocios y hogares (62012) / Información y comunicación

    ¿Dónde se encuentra PENNANT SOFTWARE SERVICES LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Pennant Court
    Staverton Technology Park
    GL51 6TL Cheltenham
    Gloucestershire
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de PENNANT SOFTWARE SERVICES LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    PENNANT INFORMATION SERVICES LIMITED21 ene 200021 ene 2000
    SOLVERA INFORMATION SERVICES (DOCUMENTATION) LIMITED28 jul 199928 jul 1999
    PRECIS (1761) LIMITED18 may 199918 may 1999

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de PENNANT SOFTWARE SERVICES LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2017

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para PENNANT SOFTWARE SERVICES LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Cese del nombramiento de Gary Robert Barnes como director el 21 nov 2019

    1 páginasTM01

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Declaración de confirmación presentada el 18 may 2019 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cese del nombramiento de Christopher Charles Powell como director el 03 may 2019

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Timothy Julian Rice como director el 24 sept 2018

    1 páginasTM01

    Declaración de confirmación presentada el 18 may 2018 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Nombramiento de Mr Gary Robert Barnes como director el 01 abr 2018

    2 páginasAP01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2017

    26 páginasAA

    Nombramiento de Mr David Joseph Clements como director el 12 oct 2017

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr David Joseph Clements como secretario el 15 jun 2017

    2 páginasAP03

    Cese del nombramiento de Philip Henry Walker como secretario el 15 jun 2017

    1 páginasTM02

    Nombramiento de Mr Timothy Julian Rice como director el 05 jun 2017

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr Simon Alick Moore como director el 05 jun 2017

    2 páginasAP01

    Declaración de confirmación presentada el 18 may 2017 con actualizaciones

    5 páginasCS01

    Cese del nombramiento de Christopher Snook como director el 29 mar 2017

    1 páginasTM01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2016

    25 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 18 may 2016 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital18 may 2016

    Estado de capital el 18 may 2016

    • Capital: GBP 1,000,000
    SH01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2015

    25 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 18 may 2015 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital18 may 2015

    Estado de capital el 18 may 2015

    • Capital: GBP 1,000,000
    SH01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2014

    27 páginasAA

    Nombramiento de Mr Philip Henry Walker como secretario el 03 nov 2014

    2 páginasAP03

    Nombramiento de Mr Philip Henry Walker como director el 03 nov 2014

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de John Mark Waller como director el 03 nov 2014

    1 páginasTM01

    ¿Quiénes son los directivos de PENNANT SOFTWARE SERVICES LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    CLEMENTS, David Joseph
    Pennant Court
    Staverton Technology Park
    GL51 6TL Cheltenham
    Gloucestershire
    Secretario
    Pennant Court
    Staverton Technology Park
    GL51 6TL Cheltenham
    Gloucestershire
    233687120001
    CLEMENTS, David Joseph
    Pennant Court
    Staverton Technology Park
    GL51 6TL Cheltenham
    Gloucestershire
    Director
    Pennant Court
    Staverton Technology Park
    GL51 6TL Cheltenham
    Gloucestershire
    EnglandBritish200768970001
    MOORE, Simon Alick
    Pennant Court
    Staverton Technology Park
    GL51 6TL Cheltenham
    Gloucestershire
    Director
    Pennant Court
    Staverton Technology Park
    GL51 6TL Cheltenham
    Gloucestershire
    EnglandBritish169812620001
    WALKER, Philip Henry
    Pennant Court
    Staverton Technology Park
    GL51 6TL Cheltenham
    Gloucestershire
    Director
    Pennant Court
    Staverton Technology Park
    GL51 6TL Cheltenham
    Gloucestershire
    EnglandBritish192548770001
    WALKER, Philip Henry
    Pennant Court
    Staverton Technology Park
    GL51 6TL Cheltenham
    Gloucestershire
    Secretario
    Pennant Court
    Staverton Technology Park
    GL51 6TL Cheltenham
    Gloucestershire
    192552730001
    WALLER, John Mark
    Pennant Court
    Staverton Technology Park
    GL51 6TL Cheltenham
    Gloucestershire
    Secretario
    Pennant Court
    Staverton Technology Park
    GL51 6TL Cheltenham
    Gloucestershire
    British8778550002
    WEST, James Crawshaw
    103 Lower Road
    SL9 8JZ Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Secretario
    103 Lower Road
    SL9 8JZ Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    British29331030001
    OFFICE ORGANIZATION & SERVICES LIMITED
    Level 1 Exchange House
    Primrose Street
    EC2A 2HS London
    Secretario corporativo
    Level 1 Exchange House
    Primrose Street
    EC2A 2HS London
    2519400001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secretario designado corporativo
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    BARNES, Gary Robert
    Pennant Court
    Staverton Technology Park
    GL51 6TL Cheltenham
    Gloucestershire
    Director
    Pennant Court
    Staverton Technology Park
    GL51 6TL Cheltenham
    Gloucestershire
    EnglandBritish244815210001
    BARNETT, Calvin Stuart
    3 The Firs
    Stockbridge Road
    SO20 5BD Winchester
    Hampshire
    Director
    3 The Firs
    Stockbridge Road
    SO20 5BD Winchester
    Hampshire
    EnglandBritish65673400001
    DENHOLM, Ian Thomas
    4 Sunset Road
    Totton
    SO40 3JU Southampton
    Hampshire
    Director
    4 Sunset Road
    Totton
    SO40 3JU Southampton
    Hampshire
    British68340880002
    DENHOLM, Ian Thomas
    The Old School Hemp Lane
    Wigginton
    HP23 6HF Tring
    Hertfordshire
    Director
    The Old School Hemp Lane
    Wigginton
    HP23 6HF Tring
    Hertfordshire
    British68340880001
    JEROME, David Leslie
    34 Collington Crescent
    PO6 4BH Portsmouth
    Hampshire
    Director
    34 Collington Crescent
    PO6 4BH Portsmouth
    Hampshire
    British61080770001
    JEROME, David Leslie
    34 Collington Crescent
    PO6 4BH Portsmouth
    Hampshire
    Director
    34 Collington Crescent
    PO6 4BH Portsmouth
    Hampshire
    British61080770001
    PENFOLD, Diane June
    43 Eagle Court
    Hermon Hill
    E11 1PD London
    Director
    43 Eagle Court
    Hermon Hill
    E11 1PD London
    United KingdomBritish59962430002
    POWELL, Christopher Charles
    Pennant Court
    Staverton Technology Park
    GL51 6TL Cheltenham
    Gloucestershire
    Director
    Pennant Court
    Staverton Technology Park
    GL51 6TL Cheltenham
    Gloucestershire
    EnglandBritish264658290001
    RICE, Timothy Julian
    Pennant Court
    Staverton Technology Park
    GL51 6TL Cheltenham
    Gloucestershire
    Director
    Pennant Court
    Staverton Technology Park
    GL51 6TL Cheltenham
    Gloucestershire
    EnglandBritish219666070001
    SNOOK, Christopher
    Avalon 14 Whiteway View
    Stratton
    GL7 2HY Cirencester
    Gloucestershire
    Director
    Avalon 14 Whiteway View
    Stratton
    GL7 2HY Cirencester
    Gloucestershire
    EnglandBritish81547090001
    THOMPSON, Joseph John James
    Underhill House
    Gretton
    GL54 5DA Cheltenham
    Gloucestershire
    Director
    Underhill House
    Gretton
    GL54 5DA Cheltenham
    Gloucestershire
    British43146240001
    WALLER, John Mark
    Farriers House Naseby Road
    Thornby
    NN6 8SW Northampton
    Northamptonshire
    Director
    Farriers House Naseby Road
    Thornby
    NN6 8SW Northampton
    Northamptonshire
    EnglandBritish8778550002
    WILSON, Clare Alice
    75 Ifield Road
    SW10 9AU London
    Director
    75 Ifield Road
    SW10 9AU London
    British47611200001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de PENNANT SOFTWARE SERVICES LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Herrick Close
    Staverton Technology Park, Staverton
    GL51 6TL Cheltenham
    Pennant Court
    England
    06 abr 2016
    Herrick Close
    Staverton Technology Park, Staverton
    GL51 6TL Cheltenham
    Pennant Court
    England
    No
    Forma jurídicaPlc
    País de registroUk
    Autoridad legalCompanies Act
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro03187528
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.

    ¿Tiene PENNANT SOFTWARE SERVICES LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Charge of intellectual property
    Creado el 26 mar 2003
    Entregado el 04 abr 2003
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    All rights,title and interest in and to the intellectual property rights excluding third party rights and all materials; the right to commence proceedings and/or receive and recover damages and all plant,machinery and equipment thereon; all book and other debts from time to time due to the company; first floating charge over the remaining undertaking,assets and business and all other rights,assets and property; see form 395 for details. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 04 abr 2003Registro de un cargo (395)
    Legal charge
    Creado el 13 feb 2002
    Entregado el 19 feb 2002
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/H properties 2-10 cawte road 210-214 shirley road 1, 3, 5, 7 and 9 paynes road and land adjoining t/nos: HP154515 HP586655 HP518278 HP111751 HP428299 HP397993 HP238161 HP320808.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 19 feb 2002Registro de un cargo (395)
    Debenture
    Creado el 21 dic 1999
    Entregado el 23 dic 1999
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 23 dic 1999Registro de un cargo (395)
    Debenture
    Creado el 10 ago 1999
    Entregado el 14 ago 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Gmac Commercial Credit Limited
    Transacciones
    • 14 ago 1999Registro de un cargo (395)
    • 13 ene 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 06 ago 1999
    Entregado el 23 ago 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to clause 3 of the hive down agreement dated 6 august 1999
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Solvera Information Services Limited
    Transacciones
    • 23 ago 1999Registro de un cargo (395)
    • 13 ene 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 06 ago 1999
    Entregado el 14 ago 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Solvera PLC(In Administration)
    Transacciones
    • 14 ago 1999Registro de un cargo (395)
    • 13 ene 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0