PENNANT SOFTWARE SERVICES LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | PENNANT SOFTWARE SERVICES LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 03772667 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de PENNANT SOFTWARE SERVICES LIMITED?
- Desarrollo de software para negocios y hogares (62012) / Información y comunicación
¿Dónde se encuentra PENNANT SOFTWARE SERVICES LIMITED?
| Dirección de la sede social | Pennant Court Staverton Technology Park GL51 6TL Cheltenham Gloucestershire |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de PENNANT SOFTWARE SERVICES LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| PENNANT INFORMATION SERVICES LIMITED | 21 ene 2000 | 21 ene 2000 |
| SOLVERA INFORMATION SERVICES (DOCUMENTATION) LIMITED | 28 jul 1999 | 28 jul 1999 |
| PRECIS (1761) LIMITED | 18 may 1999 | 18 may 1999 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de PENNANT SOFTWARE SERVICES LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2017 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para PENNANT SOFTWARE SERVICES LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Cese del nombramiento de Gary Robert Barnes como director el 21 nov 2019 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 18 may 2019 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Christopher Charles Powell como director el 03 may 2019 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Timothy Julian Rice como director el 24 sept 2018 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 18 may 2018 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Gary Robert Barnes como director el 01 abr 2018 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2017 | 26 páginas | AA | ||||||||||
Nombramiento de Mr David Joseph Clements como director el 12 oct 2017 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr David Joseph Clements como secretario el 15 jun 2017 | 2 páginas | AP03 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Philip Henry Walker como secretario el 15 jun 2017 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Timothy Julian Rice como director el 05 jun 2017 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Simon Alick Moore como director el 05 jun 2017 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 18 may 2017 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Christopher Snook como director el 29 mar 2017 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2016 | 25 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 18 may 2016 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2015 | 25 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 18 may 2015 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2014 | 27 páginas | AA | ||||||||||
Nombramiento de Mr Philip Henry Walker como secretario el 03 nov 2014 | 2 páginas | AP03 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Philip Henry Walker como director el 03 nov 2014 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de John Mark Waller como director el 03 nov 2014 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de PENNANT SOFTWARE SERVICES LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLEMENTS, David Joseph | Secretario | Pennant Court Staverton Technology Park GL51 6TL Cheltenham Gloucestershire | 233687120001 | |||||||
| CLEMENTS, David Joseph | Director | Pennant Court Staverton Technology Park GL51 6TL Cheltenham Gloucestershire | England | British | 200768970001 | |||||
| MOORE, Simon Alick | Director | Pennant Court Staverton Technology Park GL51 6TL Cheltenham Gloucestershire | England | British | 169812620001 | |||||
| WALKER, Philip Henry | Director | Pennant Court Staverton Technology Park GL51 6TL Cheltenham Gloucestershire | England | British | 192548770001 | |||||
| WALKER, Philip Henry | Secretario | Pennant Court Staverton Technology Park GL51 6TL Cheltenham Gloucestershire | 192552730001 | |||||||
| WALLER, John Mark | Secretario | Pennant Court Staverton Technology Park GL51 6TL Cheltenham Gloucestershire | British | 8778550002 | ||||||
| WEST, James Crawshaw | Secretario | 103 Lower Road SL9 8JZ Gerrards Cross Buckinghamshire | British | 29331030001 | ||||||
| OFFICE ORGANIZATION & SERVICES LIMITED | Secretario corporativo | Level 1 Exchange House Primrose Street EC2A 2HS London | 2519400001 | |||||||
| SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Secretario designado corporativo | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||
| BARNES, Gary Robert | Director | Pennant Court Staverton Technology Park GL51 6TL Cheltenham Gloucestershire | England | British | 244815210001 | |||||
| BARNETT, Calvin Stuart | Director | 3 The Firs Stockbridge Road SO20 5BD Winchester Hampshire | England | British | 65673400001 | |||||
| DENHOLM, Ian Thomas | Director | 4 Sunset Road Totton SO40 3JU Southampton Hampshire | British | 68340880002 | ||||||
| DENHOLM, Ian Thomas | Director | The Old School Hemp Lane Wigginton HP23 6HF Tring Hertfordshire | British | 68340880001 | ||||||
| JEROME, David Leslie | Director | 34 Collington Crescent PO6 4BH Portsmouth Hampshire | British | 61080770001 | ||||||
| JEROME, David Leslie | Director | 34 Collington Crescent PO6 4BH Portsmouth Hampshire | British | 61080770001 | ||||||
| PENFOLD, Diane June | Director | 43 Eagle Court Hermon Hill E11 1PD London | United Kingdom | British | 59962430002 | |||||
| POWELL, Christopher Charles | Director | Pennant Court Staverton Technology Park GL51 6TL Cheltenham Gloucestershire | England | British | 264658290001 | |||||
| RICE, Timothy Julian | Director | Pennant Court Staverton Technology Park GL51 6TL Cheltenham Gloucestershire | England | British | 219666070001 | |||||
| SNOOK, Christopher | Director | Avalon 14 Whiteway View Stratton GL7 2HY Cirencester Gloucestershire | England | British | 81547090001 | |||||
| THOMPSON, Joseph John James | Director | Underhill House Gretton GL54 5DA Cheltenham Gloucestershire | British | 43146240001 | ||||||
| WALLER, John Mark | Director | Farriers House Naseby Road Thornby NN6 8SW Northampton Northamptonshire | England | British | 8778550002 | |||||
| WILSON, Clare Alice | Director | 75 Ifield Road SW10 9AU London | British | 47611200001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de PENNANT SOFTWARE SERVICES LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pennant International Group Plc | 06 abr 2016 | Herrick Close Staverton Technology Park, Staverton GL51 6TL Cheltenham Pennant Court England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Tiene PENNANT SOFTWARE SERVICES LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Charge of intellectual property | Creado el 26 mar 2003 Entregado el 04 abr 2003 | Pendiente | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción All rights,title and interest in and to the intellectual property rights excluding third party rights and all materials; the right to commence proceedings and/or receive and recover damages and all plant,machinery and equipment thereon; all book and other debts from time to time due to the company; first floating charge over the remaining undertaking,assets and business and all other rights,assets and property; see form 395 for details. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Legal charge | Creado el 13 feb 2002 Entregado el 19 feb 2002 | Pendiente | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción F/H properties 2-10 cawte road 210-214 shirley road 1, 3, 5, 7 and 9 paynes road and land adjoining t/nos: HP154515 HP586655 HP518278 HP111751 HP428299 HP397993 HP238161 HP320808. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 21 dic 1999 Entregado el 23 dic 1999 | Pendiente | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 10 ago 1999 Entregado el 14 ago 1999 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 06 ago 1999 Entregado el 23 ago 1999 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to clause 3 of the hive down agreement dated 6 august 1999 | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 06 ago 1999 Entregado el 14 ago 1999 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0