MEDISCOPE LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaMEDISCOPE LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 03782486
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de MEDISCOPE LIMITED?

    • Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales

    ¿Dónde se encuentra MEDISCOPE LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Ashfield House
    Resolution Road
    LE65 1HW Ashby De La Zouch
    Leicestershire
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de MEDISCOPE LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta30 sept 2017

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para MEDISCOPE LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Nombramiento de Ms Grainne Mcaleese como director el 01 oct 2018

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Ms Louise Tallon como director el 01 oct 2018

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Alan Ralph como director el 01 oct 2018

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Sean Gerard Coyle como director el 26 sept 2018

    1 páginasTM01

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 sept 2017

    13 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 16 may 2018 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Declaración de confirmación presentada el 17 may 2018 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 sept 2016

    12 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 26 may 2017 con actualizaciones

    6 páginasCS01

    Nombramiento de Mr Damien Moynagh como secretario el 03 may 2017

    2 páginasAP03

    Cese del nombramiento de Tara Grimley como secretario el 03 may 2017

    1 páginasTM02

    Renuncia del auditor

    2 páginasAUD

    Déclaration annuelle établie au 26 may 2016 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital30 may 2016

    Estado de capital el 30 may 2016

    • Capital: GBP 25
    SH01

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 sept 2015

    11 páginasAA

    Nombramiento de Mr Sean Coyle como director el 16 mar 2016

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de León Atkins como director el 31 dic 2015

    1 páginasTM01

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 sept 2014

    11 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 26 may 2015 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital27 may 2015

    Estado de capital el 27 may 2015

    • Capital: GBP 25
    SH01

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 sept 2013

    11 páginasAA

    Nombramiento de Ms Tara Grimley como secretario

    2 páginasAP03

    Cese del nombramiento de Michael Gannon como secretario

    1 páginasTM02

    Déclaration annuelle établie au 26 may 2014 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital03 jun 2014

    Estado de capital el 03 jun 2014

    • Capital: GBP 25
    SH01

    ¿Quiénes son los directivos de MEDISCOPE LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    MOYNAGH, Damien
    Ashfield House
    Resolution Road
    LE65 1HW Ashby De La Zouch
    Leicestershire
    Secretario
    Ashfield House
    Resolution Road
    LE65 1HW Ashby De La Zouch
    Leicestershire
    231202630001
    MCALEESE, Grainne
    Riverwalk
    Citywest Business Campus
    Dublin 24
    20
    Dublin
    Ireland
    Director
    Riverwalk
    Citywest Business Campus
    Dublin 24
    20
    Dublin
    Ireland
    IrelandIrishDirector251380610001
    TALLON, Louise
    Riverwalk
    Citywest Business Campus
    Dublin 24
    20
    Dublin
    Ireland
    Director
    Riverwalk
    Citywest Business Campus
    Dublin 24
    20
    Dublin
    Ireland
    IrelandIrishDirector251371350001
    DAVIS, Keith Michael
    Sycamores
    Westfield Road, Osbaston
    NP25 3HX Monmouth
    Gwent
    Secretario
    Sycamores
    Westfield Road, Osbaston
    NP25 3HX Monmouth
    Gwent
    BritishManager64530890003
    GANNON, Michael
    Stillorgan Park
    Blackrock
    Co. Dublin
    7
    Ireland
    Secretario
    Stillorgan Park
    Blackrock
    Co. Dublin
    7
    Ireland
    177388950001
    GEOGHEGAN, Karen
    8 Woodstown Parade
    16 Knocklyon
    Dublin
    Ireland
    Secretario
    8 Woodstown Parade
    16 Knocklyon
    Dublin
    Ireland
    IrishAccountant126163560001
    GRIMLEY, Tara
    Linseys Hill
    BT61 9HD Armagh
    34
    Northern Ireland
    Secretario
    Linseys Hill
    BT61 9HD Armagh
    34
    Northern Ireland
    188249810001
    HEELEY, Claire
    72 Drumnigh Wood
    IRISH Portmarnock
    Ireland
    Secretario
    72 Drumnigh Wood
    IRISH Portmarnock
    Ireland
    BritishCompany Secretary113828890001
    HALLMARK SECRETARIES LIMITED
    120 East Road
    N1 6AA London
    Secretario designado corporativo
    120 East Road
    N1 6AA London
    900004100001
    ATKINS, León
    Magna Drive, Magna Business Park
    Citywest Road
    Dublin 24
    United Drug House
    Ireland
    Director
    Magna Drive, Magna Business Park
    Citywest Road
    Dublin 24
    United Drug House
    Ireland
    IrelandBritishSolicitor179022560001
    BREHONY, Luke
    85 The Rise
    GL14 3AW Mount Merrion
    County Dublin
    Ireland
    Director
    85 The Rise
    GL14 3AW Mount Merrion
    County Dublin
    Ireland
    IrishManaging Director113472930001
    COYLE, Sean Gerard
    Ashfield House
    Resolution Road
    LE65 1HW Ashby De La Zouch
    Leicestershire
    Director
    Ashfield House
    Resolution Road
    LE65 1HW Ashby De La Zouch
    Leicestershire
    IrelandIrishAccountant253248680001
    DAVIS, Andrew James
    13a Pelham Crescent
    The Park
    NG7 1AR Nottingham
    Nottinghamshire
    Director
    13a Pelham Crescent
    The Park
    NG7 1AR Nottingham
    Nottinghamshire
    United KingdomBritishManaging Director72447960002
    DAVIS, Keith Michael
    Sycamores
    Westfield Road, Osbaston
    NP25 3HX Monmouth
    Gwent
    Director
    Sycamores
    Westfield Road, Osbaston
    NP25 3HX Monmouth
    Gwent
    WalesBritishManager64530890003
    DAVIS, Olwen Elizabeth
    Sycamores
    Westfield Road
    NP25 3HX Monmouth
    Gwent
    Director
    Sycamores
    Westfield Road
    NP25 3HX Monmouth
    Gwent
    WalesBritishTeacher126866330001
    MCGRANE, Barry
    Clonskeagh
    Dublin
    44 Whitethorn Road
    Dublin 6
    Ireland
    Director
    Clonskeagh
    Dublin
    44 Whitethorn Road
    Dublin 6
    Ireland
    IrelandIrishFinance Director144463870001
    PUTTOCK, Luke Benjamin
    116 Ruspidge Road
    GL14 2HL Cinderford
    Gloucestershire
    Director
    116 Ruspidge Road
    GL14 2HL Cinderford
    Gloucestershire
    BritishManager76202830002
    PUTTOCK, Matt
    95 Ruspidge Road
    GL14 3AW Cinderford
    Gloucestershire
    Director
    95 Ruspidge Road
    GL14 3AW Cinderford
    Gloucestershire
    BritishCompany Director71611050001
    PUTTOCK, Matt
    95 Ruspidge Road
    GL14 3AW Cinderford
    Gloucestershire
    Director
    95 Ruspidge Road
    GL14 3AW Cinderford
    Gloucestershire
    BritishDirector71611050001
    PUTTOCK, Raymond
    Flossie Cottage
    Viney Hill
    GL15 4LY Lydney
    Gloucestershire
    Director
    Flossie Cottage
    Viney Hill
    GL15 4LY Lydney
    Gloucestershire
    United KingdomBritishCompany Director66073760001
    PUTTOCK, Raymond
    Flossie Cottage
    Viney Hill
    GL15 4LY Lydney
    Gloucestershire
    Director
    Flossie Cottage
    Viney Hill
    GL15 4LY Lydney
    Gloucestershire
    United KingdomBritishDirector66073760001
    RALPH, Alan
    2 Killarney Glen
    Herbert Road
    IRISH Bray
    Co Wichlon
    Ireland
    Director
    2 Killarney Glen
    Herbert Road
    IRISH Bray
    Co Wichlon
    Ireland
    IrelandIrishManager168997940001
    WILSON, Duncan
    Manor Drive
    Berrow
    TA8 2LL Burnham-On-Sea
    4
    Somerset
    United Kingdom
    Director
    Manor Drive
    Berrow
    TA8 2LL Burnham-On-Sea
    4
    Somerset
    United Kingdom
    United KingdomBritishGeneral Manager134441170001
    HALLMARK REGISTRARS LIMITED
    120 East Road
    N1 6AA London
    Director designado corporativo
    120 East Road
    N1 6AA London
    900004090001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de MEDISCOPE LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Resolution Road
    LE65 1HW Ashby-De-La-Zouch
    Ashfield House
    Leicestershire
    England
    06 abr 2016
    Resolution Road
    LE65 1HW Ashby-De-La-Zouch
    Ashfield House
    Leicestershire
    England
    No
    Forma jurídicaLimited
    País de registroEngland
    Autoridad legalCompanies Act 2006
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro3384213
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.

    ¿Tiene MEDISCOPE LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Debenture
    Creado el 16 jun 2005
    Entregado el 18 jun 2005
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 18 jun 2005Registro de un cargo (395)
    Debenture
    Creado el 01 nov 2000
    Entregado el 16 nov 2000
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Hsbc Bank PLC
    Transacciones
    • 16 nov 2000Registro de un cargo (395)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0