ENVIRONMENTAL SOLUTIONS NORTHERN LIMITED

ENVIRONMENTAL SOLUTIONS NORTHERN LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaENVIRONMENTAL SOLUTIONS NORTHERN LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 03792893
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de ENVIRONMENTAL SOLUTIONS NORTHERN LIMITED?

    • Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales

    ¿Dónde se encuentra ENVIRONMENTAL SOLUTIONS NORTHERN LIMITED?

    Dirección de la sede social
    4th Floor 24 Old Bond Street
    Mayfair
    W1S 4AW London
    United Kingdom
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de ENVIRONMENTAL SOLUTIONS NORTHERN LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    A S G MIDLANDS LIMITED21 jun 199921 jun 1999

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de ENVIRONMENTAL SOLUTIONS NORTHERN LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta30 abr 2021

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para ENVIRONMENTAL SOLUTIONS NORTHERN LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación obligatoria

    1 páginasGAZ2

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación obligatoria

    1 páginasGAZ1

    Modification des détails de Castlegate 796 Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 ene 2023

    2 páginasPSC05

    Modification des détails de Castlegate 796 Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 ene 2023

    2 páginasPSC05

    Cese del nombramiento de Rjp Secretaries Limited como secretario el 25 ene 2023

    1 páginasTM02

    Nombramiento de Cossey Cosec Services Limited como secretario el 25 ene 2023

    2 páginasAP04

    Domicilio social registrado cambiado de Ground Floor, Egerton House 68 Baker Street Weybridge Surrey KT13 8AL United Kingdom a 4th Floor 24 Old Bond Street Mayfair London W1S 4AW el 06 ene 2023

    1 páginasAD01

    Declaración de confirmación presentada el 21 jun 2022 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    Modification des détails de Gold Round Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 25 jul 2022

    2 páginasPSC05

    Cambio de datos del director Gold Round Limited el 25 jul 2022

    1 páginasCH02

    Modification des détails de Ansa Utilities Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 09 jun 2022

    2 páginasPSC05

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 abr 2021

    7 páginasAA

    Cambio de datos del director Mr Stuart Pace el 21 jul 2021

    2 páginasCH01

    Declaración de confirmación presentada el 21 jun 2021 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 abr 2020

    7 páginasAA

    Cese del nombramiento de Alan Albert Horton como director el 30 jun 2020

    1 páginasTM01

    Cambio de datos del director Mr Stuart Pace el 29 jun 2020

    2 páginasCH01

    Declaración de confirmación presentada el 21 jun 2020 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Modification des détails de Gold Round Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 18 abr 2016

    2 páginasPSC05

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 abr 2019

    7 páginasAA

    Modification des détails de Ansa Utilities Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 09 ago 2019

    2 páginasPSC05

    Domicilio social registrado cambiado de 2 a C Court High Street Thames Ditton Surrey KT7 0SR England a Ground Floor, Egerton House 68 Baker Street Weybridge Surrey KT13 8AL el 12 ago 2019

    1 páginasAD01

    Cambio de datos del secretario Rjp Secretaries Limited el 09 ago 2019

    1 páginasCH04

    Declaración de confirmación presentada el 21 jun 2019 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    Cancelación total de la carga 8

    1 páginasMR04

    ¿Quiénes son los directivos de ENVIRONMENTAL SOLUTIONS NORTHERN LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    COSSEY COSEC SERVICES LIMITED
    24 Old Bond Street
    Mayfair
    W1S 4AW London
    4th Floor
    United Kingdom
    Secretario corporativo
    24 Old Bond Street
    Mayfair
    W1S 4AW London
    4th Floor
    United Kingdom
    Tipo de identificaciónSociedad limitada del Reino Unido
    Número de registro14344691
    302964180001
    PACE, Stuart
    24 Old Bond Street
    Mayfair
    W1S 4AW London
    4th Floor
    United Kingdom
    Director
    24 Old Bond Street
    Mayfair
    W1S 4AW London
    4th Floor
    United Kingdom
    EnglandBritish207506130003
    GOLD ROUND LIMITED
    24 Old Bond Street
    Mayfair
    W1S 4AW London
    4th Floor
    United Kingdom
    Director corporativo
    24 Old Bond Street
    Mayfair
    W1S 4AW London
    4th Floor
    United Kingdom
    Tipo de identificaciónSociedad limitada del Reino Unido
    Número de registro05687325
    149588400001
    BOYES, Stephen
    Grassdale Cottage
    Valley Road, Houghton Bottoms
    PR5 0SD Preston
    Lancashire
    Secretario
    Grassdale Cottage
    Valley Road, Houghton Bottoms
    PR5 0SD Preston
    Lancashire
    British78387220001
    DAVIS, Peter Nicholas
    35 Chatsworth Road
    Eccles
    M30 9DZ Manchester
    Lancashire
    Secretario
    35 Chatsworth Road
    Eccles
    M30 9DZ Manchester
    Lancashire
    British29902470001
    DICKINSON, Louise
    Caxton Road
    Fulwood
    PR2 9NZ Preston
    6 Fulwood Park
    Lancashire
    Secretario
    Caxton Road
    Fulwood
    PR2 9NZ Preston
    6 Fulwood Park
    Lancashire
    British139480580001
    GRAEME, Dorothy May
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    Secretario designado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British900001330001
    MCINNES, Timothy Ian
    34 Cumberland Drive
    Bowdon
    WA14 3QP Altrincham
    Cheshire
    Secretario
    34 Cumberland Drive
    Bowdon
    WA14 3QP Altrincham
    Cheshire
    British108973030002
    PRILL, Robert David
    Moorfield, Roe Green
    Worsley
    M28 2FL Manchester
    8
    United Kingdom
    Secretario
    Moorfield, Roe Green
    Worsley
    M28 2FL Manchester
    8
    United Kingdom
    British131613520001
    WATKINS, Steven James
    Roscownans
    Old Kea
    TR3 6AX Truro
    Cornwall
    Secretario
    Roscownans
    Old Kea
    TR3 6AX Truro
    Cornwall
    British127928260001
    RJP SECRETARIES LIMITED
    68 Baker Street
    KT13 8AL Weybridge
    Ground Floor, Egerton House
    Surrey
    United Kingdom
    Secretario corporativo
    68 Baker Street
    KT13 8AL Weybridge
    Ground Floor, Egerton House
    Surrey
    United Kingdom
    Tipo de identificaciónSociedad limitada del Reino Unido
    Número de registro02989995
    61999120002
    BARRETT, John
    Caxton Road
    Fulwood
    PR2 9NZ Preston
    6 Fulwood Park
    Lancashire
    Director
    Caxton Road
    Fulwood
    PR2 9NZ Preston
    6 Fulwood Park
    Lancashire
    United KingdomBritish118475070001
    BROOK, Philip John
    8 Hillside Drive
    BH23 2RU Christchurch
    Dorset
    Director
    8 Hillside Drive
    BH23 2RU Christchurch
    Dorset
    British64789650001
    DAVIS, Peter Nicholas
    35 Chatsworth Road
    Eccles
    M30 9DZ Manchester
    Lancashire
    Director
    35 Chatsworth Road
    Eccles
    M30 9DZ Manchester
    Lancashire
    EnglandBritish29902470001
    DICKINSON, Louise
    Caxton Road
    Fulwood
    PR2 9NZ Preston
    6 Fulwood Park
    Lancashire
    Director
    Caxton Road
    Fulwood
    PR2 9NZ Preston
    6 Fulwood Park
    Lancashire
    EnglandBritish139480580001
    GRAEME, Lesley Joyce
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    Director designado
    61 Fairview Avenue
    ME8 0QP Gillingham
    Kent
    British900001320001
    HORTON, Alan Albert
    68 Baker Street
    KT13 8AL Weybridge
    Ground Floor, Egerton House
    Surrey
    United Kingdom
    Director
    68 Baker Street
    KT13 8AL Weybridge
    Ground Floor, Egerton House
    Surrey
    United Kingdom
    EnglandBritish182208240001
    LEE, Peter Francis
    Caxton Road
    Fulwood
    PR2 9NZ Preston
    6 Fulwood Park
    Lancashire
    Director
    Caxton Road
    Fulwood
    PR2 9NZ Preston
    6 Fulwood Park
    Lancashire
    EnglandBritish207608120001
    LEES, Stuart
    Caxton Road
    Fulwood
    PR2 9NZ Preston
    6 Fulwood Park
    Lancashire
    Director
    Caxton Road
    Fulwood
    PR2 9NZ Preston
    6 Fulwood Park
    Lancashire
    EnglandBritish70032700001
    LLOYD JONES, Andrew Mark
    Caxton Road
    Fulwood
    PR2 9NZ Preston
    6 Fulwood Park
    Lancashire
    Director
    Caxton Road
    Fulwood
    PR2 9NZ Preston
    6 Fulwood Park
    Lancashire
    EnglandBritish180809810001
    MAHONEY, Kevin David
    6 Ferrymans Quay
    William Morris Way
    SW6 2UT London
    Director
    6 Ferrymans Quay
    William Morris Way
    SW6 2UT London
    United KingdomBritish63238350002
    MAUDE, Simon David
    The Main Hall
    Rufford Park Lane Rufford
    L40 1XE Ormskirk
    1
    Lancashire
    Director
    The Main Hall
    Rufford Park Lane Rufford
    L40 1XE Ormskirk
    1
    Lancashire
    United KingdomBritish89719660003
    MCINNES, Timothy Ian
    34 Cumberland Drive
    Bowdon
    WA14 3QP Altrincham
    Cheshire
    Director
    34 Cumberland Drive
    Bowdon
    WA14 3QP Altrincham
    Cheshire
    United KingdomBritish108973030002
    POLLARD, Niall Mackinlay
    Caxton Road
    Fulwood
    PR2 9NZ Preston
    6 Fulwood Park
    Lancashire
    Director
    Caxton Road
    Fulwood
    PR2 9NZ Preston
    6 Fulwood Park
    Lancashire
    EnglandBritish176786520001
    SMITH, Andrew John
    High Street
    KT7 0SR Thames Ditton
    2 A C Court
    Surrey
    England
    Director
    High Street
    KT7 0SR Thames Ditton
    2 A C Court
    Surrey
    England
    United KingdomBritish207506140001
    TURNER, Paul Leslie
    Netherlaw
    Greendale Lane
    SK10 4AY Mottram St Andrew
    Cheshire
    Director
    Netherlaw
    Greendale Lane
    SK10 4AY Mottram St Andrew
    Cheshire
    British72964390004
    VINCENT, Michael
    23 Saint Aubyns's Avenue
    SW19 7BL London
    Director
    23 Saint Aubyns's Avenue
    SW19 7BL London
    EnglandBritish99258270001
    WATKINS, Steven James
    Park Crescent
    TR11 2DL Falmouth
    1
    Cornwall
    United Kingdom
    Director
    Park Crescent
    TR11 2DL Falmouth
    1
    Cornwall
    United Kingdom
    United KingdomBritish127928260002
    WATKINS, Steven James
    Roscownans
    Old Kea
    TR3 6AX Truro
    Cornwall
    Director
    Roscownans
    Old Kea
    TR3 6AX Truro
    Cornwall
    British127928260001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de ENVIRONMENTAL SOLUTIONS NORTHERN LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    24 Old Bond Street
    W1S 4AW Mayfair
    4th Floor
    London
    United Kingdom
    18 abr 2016
    24 Old Bond Street
    W1S 4AW Mayfair
    4th Floor
    London
    United Kingdom
    No
    Forma jurídicaLimited By Shares
    País de registroUnited Kingdom
    Autoridad legalUnited Kingdom
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro05687325
    Naturaleza del control
    • La persona tiene el derecho de ejercer, o ejerce realmente, una influencia o control significativo sobre la empresa.
    24 Old Bond Street
    Mayfair
    W1S 4AW London
    5th Floor
    United Kingdom
    06 abr 2016
    24 Old Bond Street
    Mayfair
    W1S 4AW London
    5th Floor
    United Kingdom
    Forma jurídicaLimited By Shares
    País de registroUnited Kingdom
    Autoridad legalUnited Kingdom
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro05687325
    Naturaleza del control
    • La persona tiene el derecho de ejercer, o ejerce realmente, una influencia o control significativo sobre la empresa.
    24 Old Bond Street
    Mayfair
    W1S 4AW London
    4th Floor
    United Kingdom
    06 abr 2016
    24 Old Bond Street
    Mayfair
    W1S 4AW London
    4th Floor
    United Kingdom
    No
    Forma jurídicaLimited By Shares
    País de registroEngland
    Autoridad legalUnited Kingdom (England And Wales)
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro03792812
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.

    ¿Tiene ENVIRONMENTAL SOLUTIONS NORTHERN LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    A registered charge
    Creado el 01 sept 2016
    Entregado el 13 sept 2016
    Pendiente
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Blackstar 2016 Limited
    Transacciones
    • 13 sept 2016Registro de una carga (MR01)
    A registered charge
    Creado el 03 jun 2016
    Entregado el 16 jun 2016
    Pendiente
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Secure Trust Bank PLC
    Transacciones
    • 16 jun 2016Registro de una carga (MR01)
    A composite guarantee and debenture
    Creado el 31 ene 2011
    Entregado el 08 feb 2011
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Andrew Lloyd-Jones
    Transacciones
    • 08 feb 2011Registro de un cargo (MG01)
    • 28 mar 2019Satisfacción de una carga (MR04)
    Composite guarantee and debenture
    Creado el 26 jun 2009
    Entregado el 02 jul 2009
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Development Capital Limited (Investor)
    Transacciones
    • 02 jul 2009Registro de un cargo (395)
    • 31 may 2016Satisfacción de una carga (MR04)
    Debenture
    Creado el 26 jun 2009
    Entregado el 30 jun 2009
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personas con derecho
    • Clydesdale Bank PLC (Trading as Yorkshire Bank)
    Transacciones
    • 30 jun 2009Registro de un cargo (395)
    Accession deed
    Creado el 30 jun 2005
    Entregado el 06 jul 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due of any chargor to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    The payment of the secured liabilities,any f/h or l/h property,its interest in present and future licences,fixed charge all othe present and future fittings,plant,equipment,machinery,tools,vehicles,furniture and other tangible movable property. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Allied Irish Banks PLC ("the Security Trustee")
    Transacciones
    • 06 jul 2005Registro de un cargo (395)
    • 09 jul 2009Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 29 jun 2004
    Entregado el 02 jul 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Barrington House Nominees Limited (Customer B) (the Security Trustee)
    Transacciones
    • 02 jul 2004Registro de un cargo (395)
    • 05 jul 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 12 sept 2002
    Entregado el 21 sept 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Fortis Commercial Finance Limited
    Transacciones
    • 21 sept 2002Registro de un cargo (395)
    • 30 abr 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 21 sept 2001
    Entregado el 27 sept 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Fortis Bank Sa-Nv
    Transacciones
    • 27 sept 2001Registro de un cargo (395)
    • 05 jul 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0