TELIRIS LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaTELIRIS LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 03796511
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de TELIRIS LIMITED?

    • Otras actividades de apoyo a los negocios n.c.p. (82990) / Actividades administrativas y de apoyo

    ¿Dónde se encuentra TELIRIS LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Laser House
    132 - 140 Goswell Road
    EC1V 7DY London
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de TELIRIS LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    GLOBAL INTERCASTING LIMITED05 jul 199905 jul 1999
    POINTCLAUSE LIMITED25 jun 199925 jun 1999

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de TELIRIS LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2015

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para TELIRIS LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    legacy

    2 páginasSH20

    Estado de capital el 24 jul 2017

    • Capital: GBP 0.02
    5 páginasSH19

    legacy

    2 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resoluciones

    Cancellation of share premium account 24/07/2017
    RES13
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06

    Declaración de confirmación presentada el 25 jun 2017 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    Notification de Dimension Data Holdings Plc en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 abr 2016

    1 páginasPSC02

    Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 31 dic 2015

    8 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 25 jun 2016 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital28 jun 2016

    Estado de capital el 28 jun 2016

    • Capital: GBP 102,000
    SH01

    Nombramiento de Mr Yang Li como director el 10 feb 2016

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr William Yong como director el 10 feb 2016

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr Barney Andrew Taylor como director el 10 feb 2016

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Ian Paul Heard como director el 10 feb 2016

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Scott Cornell Cruikshank como director el 10 feb 2016

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Jonathan Andrew Brock como director el 10 feb 2016

    1 páginasTM01

    Cancelación total de la carga 4

    1 páginasMR04

    Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 31 dic 2014

    8 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 25 jun 2015 avec liste complète des actionnaires

    7 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital29 jun 2015

    Estado de capital el 29 jun 2015

    • Capital: GBP 102,000
    SH01

    Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 31 dic 2013

    7 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 25 jun 2014 avec liste complète des actionnaires

    7 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital19 ago 2014

    Estado de capital el 19 ago 2014

    • Capital: GBP 102,000
    SH01

    Nombramiento de Jonathan Andrew Brock como director el 06 may 2014

    2 páginasAP01

    Domicilio social registrado cambiado de 1 Swan Lane London EC4R 3TN England a Laser House 132 - 140 Goswell Road London EC1V 7DY el 18 ago 2014

    1 páginasAD01

    Nombramiento de Scott Cornell Cruikshank como director el 06 may 2014

    2 páginasAP01

    ¿Quiénes son los directivos de TELIRIS LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    LI, Yang
    132 - 140 Goswell Road
    EC1V 7DY London
    Laser House
    Director
    132 - 140 Goswell Road
    EC1V 7DY London
    Laser House
    EnglandBritish205206330001
    TAYLOR, Barney Andrew
    132 - 140 Goswell Road
    EC1V 7DY London
    Laser House
    Director
    132 - 140 Goswell Road
    EC1V 7DY London
    Laser House
    EnglandBritish199377820001
    YONG, William
    132 - 140 Goswell Road
    EC1V 7DY London
    Laser House
    Director
    132 - 140 Goswell Road
    EC1V 7DY London
    Laser House
    SingaporeSingaporean205168510001
    GLICKMAN, Richard Alan
    William Street
    Suite 1825
    10038 New York
    100
    New York
    Usa
    Secretario
    William Street
    Suite 1825
    10038 New York
    100
    New York
    Usa
    162072400001
    THOMSON, James Stewart
    3 Mead Way
    KT10 9HG Esher
    Surrey
    Secretario
    3 Mead Way
    KT10 9HG Esher
    Surrey
    British55415050001
    TRACHTENBERG, Marc
    Broadway
    NY 10006 New York
    55
    Usa
    Secretario
    Broadway
    NY 10006 New York
    55
    Usa
    Other124986270001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secretario designado corporativo
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    BROCK, Jonathan Andrew
    Clarke Street
    2030 Vaulcuse
    21a
    Nsw
    Australia
    Director
    Clarke Street
    2030 Vaulcuse
    21a
    Nsw
    Australia
    AustraliaAustralian189089980001
    CRUIKSHANK, Scott Cornell
    Lake Boone Terrace
    Suite 200
    NC 27607 Raleigh
    4101
    Usa
    Director
    Lake Boone Terrace
    Suite 200
    NC 27607 Raleigh
    4101
    Usa
    United StatesAmerican190228040001
    GREY, Rupert Christopher
    Hampshire Cottage
    South Harting
    GU31 5LP Petersfield
    Hampshire
    Director
    Hampshire Cottage
    South Harting
    GU31 5LP Petersfield
    Hampshire
    EnglandBritish30429000001
    HEARD, Ian Paul
    Effra Road
    SW19 8PP London
    52
    United Kingdom
    Director
    Effra Road
    SW19 8PP London
    52
    United Kingdom
    United KingdomBritish190214290001
    HOBBS, John Neil
    William Street
    Suite 1825
    10038 New York
    100
    New York
    Usa
    Director
    William Street
    Suite 1825
    10038 New York
    100
    New York
    Usa
    United StatesAmerican162074130001
    INGLIS, John
    Minster Court
    Mincing Lane
    EC3R 7DD London
    3
    United Kingdom
    Director
    Minster Court
    Mincing Lane
    EC3R 7DD London
    3
    United Kingdom
    ScotlandBritish162072190001
    LEWIS, Martyn John Dudley
    Minster Court
    Mincing Lane
    EC3R 7DD London
    3
    United Kingdom
    Director
    Minster Court
    Mincing Lane
    EC3R 7DD London
    3
    United Kingdom
    EnglandBritish7277990003
    TENCH, Jeff
    William Street
    Suite 1825
    New York
    100
    New York 10038
    Usa
    Director
    William Street
    Suite 1825
    New York
    100
    New York 10038
    Usa
    Usa ColoradoAmerican179011240003
    THOMSON, James Anthony, Dr
    30 Paradise Walk
    SW3 4JL London
    Director
    30 Paradise Walk
    SW3 4JL London
    British63388730001
    THOMSON, James Stewart
    3 Mead Way
    KT10 9HG Esher
    Surrey
    Director
    3 Mead Way
    KT10 9HG Esher
    Surrey
    British55415050001
    TRACHTENBERG, Marc
    Broadway
    NY 10006 New York
    55
    Usa
    Director
    Broadway
    NY 10006 New York
    55
    Usa
    Other124986270001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Director designado corporativo
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de TELIRIS LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Dimension Data Holdings Plc
    Waterfront Business Park
    Fleet Road
    GU51 3QT Fleet
    Dimension Data House
    England
    06 abr 2016
    Waterfront Business Park
    Fleet Road
    GU51 3QT Fleet
    Dimension Data House
    England
    No
    Forma jurídicaPublic Limited Company
    País de registroEngland
    Autoridad legalCompanies Act 2006
    Lugar de registroRegistrar Of Companies, England & Wales
    Número de registro3704278
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.

    ¿Tiene TELIRIS LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Rent deposit deed
    Creado el 14 ene 2010
    Entregado el 26 ene 2010
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    The rent security deposit deed.
    Personas con derecho
    • Market Building Limited and the London Underwriting Centre Limited
    Transacciones
    • 26 ene 2010Registro de un cargo (MG01)
    • 15 abr 2016Satisfacción de una carga (MR04)
    Mortgage debenture
    Creado el 10 sept 2009
    Entregado el 30 sept 2009
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Silicon Valley Bank
    Transacciones
    • 30 sept 2009Registro de un cargo (395)
    • 04 feb 2014Satisfacción de una carga (MR04)
    Loan and security agreement
    Creado el 18 abr 2008
    Entregado el 01 may 2008
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from any credit party to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    The collateral meaning all of the right title and interest in and to all goods, accounts, equipment, see image for full details.
    Personas con derecho
    • Silicon Valley Bank
    Transacciones
    • 01 may 2008Registro de un cargo (395)
    • 04 feb 2014Satisfacción de una carga (MR04)
    Mortgage debenture
    Creado el 18 abr 2008
    Entregado el 01 may 2008
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Silicon Valley Bank
    Transacciones
    • 01 may 2008Registro de un cargo (395)
    • 04 feb 2014Satisfacción de una carga (MR04)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0