TYMEL WEST SCOTLAND

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración anual
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaTYMEL WEST SCOTLAND
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad privada sin límite de capital
    Número de empresa 03804532
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de TYMEL WEST SCOTLAND?

    • Compraventa de bienes inmobiliarios propios (68100) / Actividades inmobiliarias
    • Otro alquiler y explotación de bienes inmobiliarios propios o arrendados (68209) / Actividades inmobiliarias

    ¿Dónde se encuentra TYMEL WEST SCOTLAND?

    Dirección de la sede social
    3 Field Court
    Grays Inn
    WC1R 5EF London
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de TYMEL WEST SCOTLAND?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    HIGHCROSS WEST SCOTLAND LIMITED 13 dic 199913 dic 1999
    DMWSL 277 LIMITED09 jul 199909 jul 1999

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de TYMEL WEST SCOTLAND?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta21 jul 2013

    ¿Cuál es el estado de la última declaración anual para TYMEL WEST SCOTLAND?

    Declaración anual
    Última declaración anual

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para TYMEL WEST SCOTLAND?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de acreedores

    16 páginas4.72

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 17 mar 2015

    16 páginas4.68

    Domicilio social registrado cambiado de * C/O Clyne & Co. Plymouth Chambers Bartlett Street Caerphilly Mid Glamorgan CF83 1JS Wales* el 28 mar 2014

    1 páginasAD01

    Declaración de asuntos con el formulario adjunto 4.19

    6 páginas4.20

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    1 páginas600

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo extraordinario para la liquidación

    LRESEX

    Cuentas de exención total para empresas pequeñas preparadas hasta el 21 jul 2013

    9 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 31 may 2013 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital05 jun 2013

    Estado de capital el 05 jun 2013

    • Capital: GBP 1.05
    SH01

    Cuentas de exención total para empresas pequeñas preparadas hasta el 21 jul 2012

    4 páginasAA

    Domicilio social registrado cambiado de * 3 Mountain Road Caerphilly Mid Glamorgan CF83 1HG* el 19 abr 2013

    1 páginasAD01

    Domicilio social registrado cambiado de * Victoria House Southampton Row London WC1B 4DA* el 10 jul 2012

    2 páginasAD01

    Déclaration annuelle établie au 31 may 2012 avec liste complète des actionnaires

    14 páginasAR01

    Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 21 jul 2011

    11 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 31 may 2011 avec liste complète des actionnaires

    13 páginasAR01

    Déclaration annuelle établie au 31 may 2010 avec liste complète des actionnaires

    13 páginasAR01

    Déclaration annuelle établie au 31 may 2009 avec liste complète des actionnaires

    7 páginasAR01

    Déclaration annuelle établie au 31 may 2008 avec liste complète des actionnaires

    7 páginasAR01

    Cuentas completas preparadas hasta el 21 jul 2010

    15 páginasAA

    Cuentas completas preparadas hasta el 21 jul 2009

    15 páginasAA

    Cuentas completas preparadas hasta el 21 jul 2008

    16 páginasAA

    Cuentas completas preparadas hasta el 21 jul 2007

    17 páginasAA

    Solicitud de restauración administrativa

    3 páginasRT01

    Boletín oficial final disuelto por cancelación obligatoria

    1 páginasGAZ2

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación obligatoria

    1 páginasGAZ1

    ¿Quiénes son los directivos de TYMEL WEST SCOTLAND?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    ALLARD, Imelda
    3 The Spires
    BT18 9DY Holywood
    County Down
    N Ireland
    Secretario
    3 The Spires
    BT18 9DY Holywood
    County Down
    N Ireland
    British82441870001
    ALLARD, Tyrone James
    The Spires
    BT18 9DY Holywood
    3
    County Down
    Northern Ireland
    Director
    The Spires
    BT18 9DY Holywood
    3
    County Down
    Northern Ireland
    Northern IrelandIrishDirector2343150005
    MASSEY, Jill Elizabeth Ann
    15 Hatch Close
    Chapel Row
    RG7 6NZ Bucklebury
    Berkshire
    Secretario
    15 Hatch Close
    Chapel Row
    RG7 6NZ Bucklebury
    Berkshire
    British34436710001
    MEGAN, Michael Francis
    15 Blackthorn Drive
    RG18 4BP Thatcham
    Berkshire
    Secretario
    15 Blackthorn Drive
    RG18 4BP Thatcham
    Berkshire
    Irish46067860002
    DM COMPANY SERVICES LIMITED
    16 Charlotte Square
    EH2 4DF Edinburgh
    Midlothian
    Secretario designado corporativo
    16 Charlotte Square
    EH2 4DF Edinburgh
    Midlothian
    900000320001
    GUBB, Peter Griffiths
    Donnington Hurst
    Wantage Road Donnington
    RG14 3BE Newbury
    Berkshire
    Director
    Donnington Hurst
    Wantage Road Donnington
    RG14 3BE Newbury
    Berkshire
    United KingdomBritish Chartered Surveyor6163460002
    HUNTER, Iain Gordon
    Headshaw
    TD7 4NT Ashkirk
    Selkirkshire
    Director
    Headshaw
    TD7 4NT Ashkirk
    Selkirkshire
    United KingdomBritishChartered Surveyor34752600001
    MEGAN, Michael Francis
    15 Blackthorn Drive
    RG18 4BP Thatcham
    Berkshire
    Director
    15 Blackthorn Drive
    RG18 4BP Thatcham
    Berkshire
    IrishAccountant46067860002
    WOODS, Keith Desmond
    8 Walters Close
    Cold Ash
    RG18 9PU Newbury
    Berkshire
    Director
    8 Walters Close
    Cold Ash
    RG18 9PU Newbury
    Berkshire
    UkBritishArchitect87234820001
    WRIGHT, Helen Marjorie Elizabeth
    Merrilees Cottage
    Main Street
    RG20 7EW Chaddleworth
    Berkshire
    Director
    Merrilees Cottage
    Main Street
    RG20 7EW Chaddleworth
    Berkshire
    BritishSurveyor56779440004
    25 NOMINEES LIMITED
    Royal London House
    22-25 Finsbury Square
    EC2A 1DX London
    Director corporativo
    Royal London House
    22-25 Finsbury Square
    EC2A 1DX London
    42409900001

    ¿Tiene TYMEL WEST SCOTLAND alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Assignation of rent due under occupational leases
    Creado el 03 jul 2002
    Entregado el 18 jul 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due from highcross west scotland limited to the chargee
    Breve descripción
    All sums due and that may become due to the borrower whether by way of rent or otherwise by the tenants detailed. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Bank of Scotland (Ireland) Limited
    Transacciones
    • 18 jul 2002Registro de un cargo (395)
    • 23 oct 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 31 may 2002
    Entregado el 18 jun 2002
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Bank of Scotland (Ireland) Limited
    Transacciones
    • 18 jun 2002Registro de un cargo (395)
    • 23 oct 2004Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad de una carga flotante ha sido liberada (403b)
    Standard security which was presented for registration in scotland on 7 june 2002 and
    Creado el 31 may 2002
    Entregado el 13 jun 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due from the company (formerly known as highcross west scotland limited) to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Subjects known as crowngate centre,114-127 brook st,glasgow being the subjects at 117-127 brook st,glasgow and subjects on south west side of rimsdale st,glasgow; GLA113510 and GLA119195.
    Personas con derecho
    • Bank of Scotland (Ireland) Limited
    Transacciones
    • 13 jun 2002Registro de un cargo (395)
    • 23 oct 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Assignation of rent
    Creado el 31 may 2002
    Entregado el 13 jun 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due from the company (formerly known as highcross west scotland limited) to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    All sums due by way of rent in respect of their interest in the occupation leases as detailed in the schedule. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Bank of Scotland (Ireland) Limited
    Transacciones
    • 13 jun 2002Registro de un cargo (395)
    • 23 oct 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 21 dic 1999
    Entregado el 07 ene 2000
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 07 ene 2000Registro de un cargo (395)
    • 07 jun 2002Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    A standard security which was presented for registration in scotland on 29 december 1999 and
    Creado el 20 dic 1999
    Entregado el 15 ene 2000
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee in the terms of a facility agreement dated 17TH and 20TH december 1999 relating to a facility to make available £1,622,400 to the company
    Breve descripción
    Land at brook street glasgow t/n GLA113510 and land on the west south west side of rimsdale street glasgow t/n GLA119195.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 15 ene 2000Registro de un cargo (395)
    • 07 jun 2002Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    ¿Tiene TYMEL WEST SCOTLAND algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    08 ago 2015Fecha prevista de disolución
    18 mar 2014Inicio de la liquidación
    Liquidación voluntaria de acreedores
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    William Antony Batty
    3 Field Court
    Grays Inn
    WC1R 5EF London
    Profesional
    3 Field Court
    Grays Inn
    WC1R 5EF London

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0