FOOD PARTNERS LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaFOOD PARTNERS LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 03804549
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de FOOD PARTNERS LIMITED?

    • Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales

    ¿Dónde se encuentra FOOD PARTNERS LIMITED?

    Dirección de la sede social
    2 The Square
    Southall Lane
    UB2 5NH Heathrow
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de FOOD PARTNERS LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    DMWSL 270 LIMITED09 jul 199909 jul 1999

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de FOOD PARTNERS LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta30 sept 2018

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para FOOD PARTNERS LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación obligatoria

    1 páginasGAZ2

    Se ha suspendido la acción de cancelación obligatoria

    1 páginasDISS16(SOAS)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación obligatoria

    1 páginasGAZ1

    Cese del nombramiento de Martin Johnson como director el 03 jun 2020

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Diarmuid Brendan Conifrey como director el 24 jun 2020

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr Diarmuid Brendan Conifrey como director el 08 abr 2020

    2 páginasAP01

    Orden judicial

    S1096 Court Order to Rectify
    6 páginasOC

    Declaración de confirmación presentada el 30 ago 2019 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 sept 2018

    22 páginasAA

    Cancelación total de la carga 11

    4 páginasMR04

    legacy

    páginasANNOTATION

    Declaración de confirmación presentada el 30 ago 2018 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas de subsidiaria exentas de auditoría preparadas hasta el 30 sept 2017

    23 páginasAA

    legacy

    2 páginasAGREEMENT2

    legacy

    47 páginasPARENT_ACC

    legacy

    3 páginasGUARANTEE2

    Exercice comptable précédent prolongé du 31 mar 2017 au 30 sept 2017

    1 páginasAA01

    Declaración de confirmación presentada el 30 ago 2017 con actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2016

    31 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 30 ago 2016 con actualizaciones

    6 páginasCS01

    Cese del nombramiento de Mark Ian Tentori como director el 27 abr 2016

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Gavin Cox como secretario el 08 mar 2016

    1 páginasTM02

    Cese del nombramiento de Gavin Eliot Cox como director el 07 mar 2016

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr Martin Johnson como director el 25 feb 2016

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr Mark Ian Tentori como director el 06 oct 2015

    2 páginasAP01

    ¿Quiénes son los directivos de FOOD PARTNERS LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    COX, Gavin
    The Square
    Southall Lane
    UB2 5NH Heathrow
    2
    England
    Secretario
    The Square
    Southall Lane
    UB2 5NH Heathrow
    2
    England
    165756650001
    MOMEN, Julian Akhtar Karim
    Tanners Drive
    MK14 5BN Blakelands
    28
    Milton Keynes
    Secretario
    Tanners Drive
    MK14 5BN Blakelands
    28
    Milton Keynes
    British150500050001
    ROBERTSON, Neil Charles
    16 Barmstedt Drive
    LE15 6RG Oakham
    Rutland
    Secretario
    16 Barmstedt Drive
    LE15 6RG Oakham
    Rutland
    BritishChartered Accountant48323870001
    THORNE, Michael
    48 Station Road
    Woburn Sands
    MK17 8RU Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Secretario
    48 Station Road
    Woburn Sands
    MK17 8RU Milton Keynes
    Buckinghamshire
    British71735980002
    DM COMPANY SERVICES LIMITED
    16 Charlotte Square
    EH2 4DF Edinburgh
    Midlothian
    Secretario designado corporativo
    16 Charlotte Square
    EH2 4DF Edinburgh
    Midlothian
    900000320001
    MACLAY MURRAY & SPENS LLP
    St. Vincent Street
    G2 5NJ Glasgow
    151
    Secretario designado corporativo
    St. Vincent Street
    G2 5NJ Glasgow
    151
    900003400001
    CHREE, Ian Charles Gordon
    6 The Grange
    Perceton
    KA11 2EU Irvine
    Ayrshire
    Director
    6 The Grange
    Perceton
    KA11 2EU Irvine
    Ayrshire
    ScotlandBritishCompany Director65127980003
    CONIFREY, Diarmuid Brendan
    The Square
    Southall Lane
    UB2 5NH Heathrow
    2
    Director
    The Square
    Southall Lane
    UB2 5NH Heathrow
    2
    EnglandIrishChief Finance Officer268799160001
    COX, Gavin Eliot
    The Square
    Southall Lane
    UB2 5NH Heathrow
    2
    England
    Director
    The Square
    Southall Lane
    UB2 5NH Heathrow
    2
    England
    United KingdomBritishDirector153840250001
    EARL, Elizabeth Jane
    Waverley
    Burners Heath
    GU24 0DJ Pirbright Woking
    Surrey
    Director
    Waverley
    Burners Heath
    GU24 0DJ Pirbright Woking
    Surrey
    United KingdomBritishCompany Director202375770001
    HAZELDEAN, William James
    6a Balmoral Court
    Gleneagles Village
    PH3 1SH Auchterarder
    Perthshire
    Director
    6a Balmoral Court
    Gleneagles Village
    PH3 1SH Auchterarder
    Perthshire
    ScotlandBritishCompany Director83660790002
    HULBERT, David John
    St Michaels Way
    Steeple Claydon
    MK18 2QD Buckingham
    53
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Director
    St Michaels Way
    Steeple Claydon
    MK18 2QD Buckingham
    53
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    EnglandBritishOperational And Technical Dire136463020001
    JOHNSON, Martin
    The Square
    Southall Lane
    UB2 5NH Heathrow
    2
    Director
    The Square
    Southall Lane
    UB2 5NH Heathrow
    2
    EnglandBritishDirector140167360001
    KILSHAW, David Charles
    Drumallan
    283 North Deeside Road, Cults
    AB15 9PA Aberdeen
    Director
    Drumallan
    283 North Deeside Road, Cults
    AB15 9PA Aberdeen
    United KingdomBritishIndustrial Manager18455470002
    KINGSLEY BATES, Paul
    Tanners Drive
    Blakelands
    MK14 5BN Milton Keynes
    28
    United Kingdom
    Director
    Tanners Drive
    Blakelands
    MK14 5BN Milton Keynes
    28
    United Kingdom
    United KingdomBritishManaging Director132962170001
    MCLELLAND, Stewart
    36 East Craigs Rigg
    EH12 8JA Edinburgh
    Midlothian
    Director
    36 East Craigs Rigg
    EH12 8JA Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritishDirector157009150001
    MOMEN, Julian Akhtar Karim
    Tanners Drive
    Blakelands
    MK14 5BN Milton Keynes
    28
    United Kingdom
    Director
    Tanners Drive
    Blakelands
    MK14 5BN Milton Keynes
    28
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector51784930002
    POCOCK, Patrick William
    The Steadings
    Woodside Of Cloghill, Kingswells
    AB15 8SA Aberdeen
    Director
    The Steadings
    Woodside Of Cloghill, Kingswells
    AB15 8SA Aberdeen
    BritishCompany Director96978470001
    ROBERTSON, Neil Charles
    16 Barmstedt Drive
    LE15 6RG Oakham
    Rutland
    Director
    16 Barmstedt Drive
    LE15 6RG Oakham
    Rutland
    United KingdomBritishChartered Accountant48323870001
    ROBINSON, Stuart John
    Westfield House
    Harburn
    EH55 8RB West Calder
    West Lothian
    Director
    Westfield House
    Harburn
    EH55 8RB West Calder
    West Lothian
    BritishCompany Director63448390001
    TENTORI, Mark Ian
    The Square
    Southall Lane
    UB2 5NH Heathrow
    2
    Director
    The Square
    Southall Lane
    UB2 5NH Heathrow
    2
    EnglandBritishChief Finance Officer119564310001
    THOMAS, Christopher
    Poyle Road
    Colnbrook
    SL3 0QX Slough
    Food Partners House
    England
    Director
    Poyle Road
    Colnbrook
    SL3 0QX Slough
    Food Partners House
    England
    United KingdomBritishDirector63844650001
    THORNE, Michael
    48 Station Road
    Woburn Sands
    MK17 8RU Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Director
    48 Station Road
    Woburn Sands
    MK17 8RU Milton Keynes
    Buckinghamshire
    BritishCompany Director71735980002
    THORPE, Alan
    7 Oak Wynd
    Cambuslang
    G72 7GS Glasgow
    Director
    7 Oak Wynd
    Cambuslang
    G72 7GS Glasgow
    BritishDistribution Manager81775420001
    TRUELOVE, Amelia Anne
    Bentley Hall
    Fenny Bentley
    DE6 1LE Ashbourne
    Derbyshire
    Director
    Bentley Hall
    Fenny Bentley
    DE6 1LE Ashbourne
    Derbyshire
    BritishDirector37845970003
    WOOD, Steven John
    Poyle Road
    Colnbrook
    SL3 0QX Slough
    Food Partners House
    England
    Director
    Poyle Road
    Colnbrook
    SL3 0QX Slough
    Food Partners House
    England
    United KingdomBritishDirector232132390001
    25 NOMINEES LIMITED
    Royal London House
    22-25 Finsbury Square
    EC2A 1DX London
    Director corporativo
    Royal London House
    22-25 Finsbury Square
    EC2A 1DX London
    42409900001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de FOOD PARTNERS LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Adelie Foods Group Limited
    The Square, Southall Lane
    UB2 5NH Southall
    2
    England
    06 abr 2016
    The Square, Southall Lane
    UB2 5NH Southall
    2
    England
    No
    Forma jurídicaAdelie Foods Group Limited
    País de registroEngalnd & Wales
    Autoridad legalCompanies Act 2006
    Lugar de registroRegistrar Of Companies
    Número de registro07964277
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.

    ¿Tiene FOOD PARTNERS LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    A registered charge
    Creado el 05 mar 2015
    Entregado el 11 mar 2015
    Pendiente
    Breve descripción
    None.
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Trustee
    Transacciones
    • 11 mar 2015Registro de una carga (MR01)
    A registered charge
    Creado el 31 may 2013
    Entregado el 07 jun 2013
    Satisfecho en su totalidad
    Breve descripción
    A fixed charge over all land (I.E. any interest in heritable, freehold or leasehold land) vested in or charged to food partners limited, owned now or in the future. This includes all fixtures and fittings attached to the land and all rents receivable from any lease granted out of the land.. A fixed charge, subject to third party consents, over all intellectual property of food partners limited, owned now or in the future.. Notification of addition to or amendment of charge.
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Rbs Invoice Finance Limited
    Transacciones
    • 07 jun 2013Registro de una carga (MR01)
    • 10 mar 2015Satisfacción de una carga (MR04)
    A registered charge
    Creado el 31 may 2013
    Entregado el 05 jun 2013
    Satisfecho en su totalidad
    Breve descripción
    Notification of addition to or amendment of charge.
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Punjab National Bank (International) Limited
    Transacciones
    • 05 jun 2013Registro de una carga (MR01)
    • 06 feb 2015Satisfacción de una carga (MR04)
    Debenture
    Creado el 11 abr 2012
    Entregado el 14 abr 2012
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each obligor or any future obligor and each grantor of security to the secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 14 abr 2012Registro de un cargo (MG01)
    • 07 jun 2013Satisfacción de una carga (MR04)
    Composite guarantee and debenture
    Creado el 11 abr 2012
    Entregado el 14 abr 2012
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from any member of the group to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Pnc Business Credit, a Trading Style of Pnc Financial Services UK LTD
    Transacciones
    • 14 abr 2012Registro de un cargo (MG01)
    • 07 jun 2013Satisfacción de una carga (MR04)
    Rent deposit deed
    Creado el 20 oct 2011
    Entregado el 01 nov 2011
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    £56,000 due or to become due
    Breve descripción
    The deposit amount see image for full details.
    Personas con derecho
    • Trw Pensions Trust Limited
    Transacciones
    • 01 nov 2011Registro de un cargo (MG01)
    Rent deposit deed
    Creado el 20 oct 2011
    Entregado el 01 nov 2011
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    £18,066.80 due or to become due
    Breve descripción
    The deposit amount see image for full details.
    Personas con derecho
    • Trw Pensions Trust Limited
    Transacciones
    • 01 nov 2011Registro de un cargo (MG01)
    Rent deposit deed
    Creado el 23 feb 2009
    Entregado el 04 mar 2009
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    All monies standing to the credit of the deposit account see image for full details.
    Personas con derecho
    • Brixton (Unit 6 Horton Road Poyle) Limited
    Transacciones
    • 04 mar 2009Registro de un cargo (395)
    Rent deposit deed
    Creado el 24 abr 2008
    Entregado el 10 may 2008
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £43,505.00 and all other monies due or to become due from the company to the chargee
    Breve descripción
    £43,505.00 or the amount of the credit in the account from time to time.
    Personas con derecho
    • Microsoft Limited
    Transacciones
    • 10 may 2008Registro de un cargo (395)
    • 22 mar 2019Satisfacción de una carga (MR04)
    Debenture
    Creado el 21 abr 2008
    Entregado el 02 may 2008
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each present or future member of the group to the chargee and/or the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Duke Street Capital General Partner Limited (As Security Agent for the Secured Parties)
    Transacciones
    • 02 may 2008Registro de un cargo (395)
    • 15 jun 2012Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Rent deposit deed
    Creado el 01 mar 2007
    Entregado el 10 mar 2007
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Premium of £56,000 plus vat deposited by the company with the chargee and all other sums from time to time.
    Personas con derecho
    • Trw Pensions Trust Limited
    Transacciones
    • 10 mar 2007Registro de un cargo (395)
    Debenture accession deed
    Creado el 04 abr 2006
    Entregado el 13 abr 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each member of the group to the security agent and/or the other secured parties or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (As Security Agent for the Secured Parties)
    Transacciones
    • 13 abr 2006Registro de un cargo (395)
    • 15 jun 2012Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Standard security which was presented for registration in scotland on 8 may 2006 and
    Creado el 02 abr 2006
    Entregado el 27 may 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each present or future member of the group to the security agent and/or the other security parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Rowallan business park, southcraig avenue, kilmarnock t/no. AYR3588.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (As Security Agent for the Security Parties)
    Transacciones
    • 27 may 2006Registro de un cargo (395)
    • 15 jun 2012Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Share pledge
    Creado el 02 abr 2006
    Entregado el 20 abr 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each present or future member of the group to the chargee and/or the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Any additional shares and related rights, additional shares means any shares in the company including any such shares comprised in related rights meaning all dividends, interest. The comapany and the existing shares being food partners kilmarnock limited reg no:SC140577, ordinary shares of £1. see the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland 'Security Agent'
    Transacciones
    • 20 abr 2006Registro de un cargo (395)
    • 15 jun 2012Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    A standard security which was presented for registration in scotland on the 26TH september 2005 and
    Creado el 31 may 2005
    Entregado el 07 oct 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Breve descripción
    The property k/a rowallan business park, kilmarnock.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 07 oct 2005Registro de un cargo (395)
    • 26 abr 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Rent deposit deed
    Creado el 07 ago 2003
    Entregado el 13 ago 2003
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    The sum of £62,500 or such greater sum as is equal to one half of the current annual rental as defined in the lease.
    Personas con derecho
    • Cockspur Property (General Partner) Limited and Cockspur Property (Nominee No.1) Limited
    Transacciones
    • 13 ago 2003Registro de un cargo (395)
    Composite corporate guarantee
    Creado el 31 oct 2001
    Entregado el 17 nov 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    To exercise a right of set-off or retention in respect of all money at any time standing to the credit of the guarantor's accounts whatsoever. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 17 nov 2001Registro de un cargo (395)
    • 26 abr 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 31 oct 2001
    Entregado el 14 nov 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 14 nov 2001Registro de un cargo (395)
    • 26 abr 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 09 oct 2000
    Entregado el 19 oct 2000
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 19 oct 2000Registro de un cargo (395)
    • 30 nov 2001Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0