REC ASBESTOS (SOUTH) LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | REC ASBESTOS (SOUTH) LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 03830216 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de REC ASBESTOS (SOUTH) LIMITED?
- Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p. (74909) / Actividades profesionales, científicas y técnicas
¿Dónde se encuentra REC ASBESTOS (SOUTH) LIMITED?
| Dirección de la sede social | 2 Browns Road NN11 4NS Daventry England |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de REC ASBESTOS (SOUTH) LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| NOBLE HEALTH & SAFETY CONSULTANCY LIMITED | 23 ago 1999 | 23 ago 1999 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de REC ASBESTOS (SOUTH) LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 mar 2022 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para REC ASBESTOS (SOUTH) LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 2 páginas | DS01 | ||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 mar 2022 | 6 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 20 jun 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2021 | 6 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 20 jun 2021 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2020 | 6 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 20 jun 2020 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Domicilio social registrado cambiado de The Forge Blisworth Hill Farm Stoke Road Blisworth Northampton NN7 3DB England a 2 Browns Road Daventry NN11 4NS el 17 jul 2020 | 1 páginas | AD01 | ||
Exercice comptable précédent prolongé du 31 dic 2019 au 31 mar 2020 | 1 páginas | AA01 | ||
Cese del nombramiento de Mark Carnegie-Brown como director el 10 oct 2019 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de Paul Mccluskey como director el 10 oct 2019 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de Paul Mcclusky como director el 10 oct 2019 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de Matthew James Hanson como director el 10 oct 2019 | 1 páginas | TM01 | ||
Nombramiento de Mr Jonathan Matthew Clements como director el 10 oct 2019 | 2 páginas | AP01 | ||
Nombramiento de Mr Gregory John Kirkman como director el 10 oct 2019 | 2 páginas | AP01 | ||
Nombramiento de Mr Richard Allen Assenheim como director el 10 oct 2019 | 2 páginas | AP01 | ||
Domicilio social registrado cambiado de One St Peter's Square Manchester M2 3DE United Kingdom a The Forge Blisworth Hill Farm Stoke Road Blisworth Northampton NN7 3DB el 15 oct 2019 | 1 páginas | AD01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2018 | 5 páginas | AA | ||
Nombramiento de Dr Mark Carnegie-Brown como director el 05 ago 2019 | 2 páginas | AP01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 20 jun 2019 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||
Nombramiento de Matthew James Hanson como director el 03 jun 2019 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Mark Calderbank como director el 14 jun 2019 | 1 páginas | TM01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2017 | 10 páginas | AA | ||
¿Quiénes son los directivos de REC ASBESTOS (SOUTH) LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASSENHEIM, Richard Allen | Director | Kettering Road NN2 7DU Northampton 263 England | United Kingdom | British | 107134790001 | |||||
| CLEMENTS, Jonathan Matthew | Director | Carrs Way Harpole NN7 4DA Northampton 66 England | England | British | 148425870001 | |||||
| KIRKMAN, Gregory John | Director | Duston Wildes NN5 6NR Northampton 73 England | United Kingdom | British | 43067380003 | |||||
| ELLIS, Andrew Clive | Secretario | 34 Merafield Drive Plympton PL7 1TP Plymouth Devon | British | 83349650001 | ||||||
| MCCLUSKEY, Paul | Secretario | Barbirolli Square M2 3AB Manchester 100 United Kingdom | 191004950001 | |||||||
| MOSS, Karl Alan | Secretario | 9 Hadfield Street Cornbrook M16 9FE Old Trafford Hadfield House Manchester United Kingdom | 148196340001 | |||||||
| SUTHERLAND, Ronald Macnoughton | Secretario | Flat 9 67 Cambridge Road PR9 9NG Southport | British | 67412270002 | ||||||
| SECRETARIAL APPOINTMENTS LIMITED | Secretario designado corporativo | 16 Churchill Way CF10 2DX Cardiff | 900017270001 | |||||||
| CALDERBANK, Mark | Director | 19 Spring Gardens M2 1FB Manchester C/O 1st Floor United Kingdom | United Kingdom | British | 250111160001 | |||||
| CARNEGIE-BROWN, Mark, Dr | Director | Block 35s Alderley Park SK10 4TG Cheshire C/O Concept Life Sciences United Kingdom | United Kingdom | British | 224430380001 | |||||
| COLL, David Daniel | Director | Barbirolli Square M2 3AB Manchester 100 United Kingdom | Scotland | British | 146924840001 | |||||
| ELLIS, Andrew Clive | Director | 9 Hadfield Street Cornbrook M16 9FE Old Trafford Hadfield House Manchester United Kingdom | England | British | 83349650001 | |||||
| ELLIS, Andrew Clive | Director | 34 Merafield Drive Plympton PL7 1TP Plymouth Devon | England | British | 83349650001 | |||||
| FORT, Michael John | Director | M2 3DE Manchester One St Peter's Square United Kingdom | United Kingdom | British | 189303790003 | |||||
| HANSON, Matthew James | Director | Stoke Road Blisworth NN7 3DB Northampton The Forge Blisworth Hill Farm England | United Kingdom | British | 276583410001 | |||||
| JENKINS, Daniel | Director | M2 3DE Manchester One St Peter's Square United Kingdom | United Kingdom | British | 170241030001 | |||||
| MCCLUSKEY, Paul | Director | Stoke Road Blisworth NN7 3DB Northampton The Forge Blisworth Hill Farm England | United Kingdom | British | 156519370001 | |||||
| MORGAN, Alan Stuart | Director | Barbirolli Square M2 3AB Manchester 100 United Kingdom | England | British | 72916280001 | |||||
| SUTHERLAND, Bruce | Director | The Hilt Clobells TQ10 9JW South Brent Devon | United Kingdom | British | 67642630001 | |||||
| WOOD, David | Director | Barbirolli Square M2 3AB Manchester 100 United Kingdom | England | British | 24194630001 | |||||
| CORPORATE APPOINTMENTS LIMITED | Director designado corporativo | 16 Churchill Way CF10 2DX Cardiff | 900017260001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de REC ASBESTOS (SOUTH) LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noble Health & Safety Training Limited | 01 ago 2016 | St. Peters Square M2 3DE Manchester One England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Tiene REC ASBESTOS (SOUTH) LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| All assets debenture | Creado el 27 ene 2012 Entregado el 31 ene 2012 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. See image for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Mortgage debenture deed | Creado el 07 jun 2010 Entregado el 11 jun 2010 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción By way of fixed equitable charge all purchased debts; all other debts and all associated rights; by way of floating charge all the undertaking and all the rights and assets of the company. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 18 jun 2004 Entregado el 22 jun 2004 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0