CLIPABILITY LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaCLIPABILITY LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 03835785
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de CLIPABILITY LIMITED?

    • Actividades de agencias de noticias (63910) / Información y comunicación

    ¿Dónde se encuentra CLIPABILITY LIMITED?

    Dirección de la sede social
    1 Broadgate
    EC2M 2QS London
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de CLIPABILITY LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2017

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para CLIPABILITY LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    legacy

    1 páginasSH20

    Estado de capital el 28 dic 2018

    • Capital: GBP 2
    3 páginasSH19

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resoluciones

    Reduction of share premium 28/12/2018
    RES13
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06

    Declaración de confirmación presentada el 03 sept 2018 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2017

    8 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 03 sept 2017 con actualizaciones

    5 páginasCS01

    Notification de Precise Media Group Holdings Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 abr 2016

    1 páginasPSC02

    Cessation de Knight Banner Information Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 04 sept 2016

    1 páginasPSC07

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2016

    6 páginasAA

    Cese del nombramiento de Peter Low como director el 27 ene 2017

    2 páginasTM01

    Nombramiento de Mr Giles Harvey Roberts Richardson como director el 10 feb 2017

    3 páginasAP01

    Declaración de confirmación presentada el 03 sept 2016 con actualizaciones

    5 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2015

    6 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 03 sept 2015 avec liste complète des actionnaires

    3 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital27 nov 2015

    Estado de capital el 27 nov 2015

    • Capital: GBP 200
    SH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2014

    6 páginasAA

    Cese del nombramiento de Kier Murray Fawcus como director el 14 jul 2015

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de John Roger Haworth como director el 14 jul 2015

    1 páginasTM01

    Se ha descontinuado la acción de cancelación obligatoria

    1 páginasDISS40

    Déclaration annuelle établie au 03 sept 2014 avec liste complète des actionnaires

    3 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital11 may 2015

    Estado de capital el 11 may 2015

    • Capital: GBP 200
    SH01

    Cese del nombramiento de Stephen Lacey como secretario el 06 jun 2014

    1 páginasTM02

    Cese del nombramiento de Stephen Lacey como director el 06 jun 2014

    1 páginasTM01

    ¿Quiénes son los directivos de CLIPABILITY LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    WPP GROUP (NOMINEES) LIMITED
    Farm Street
    W1J 5RJ London
    27
    England
    Secretario corporativo
    Farm Street
    W1J 5RJ London
    27
    England
    Tipo de identificaciónEEE
    Número de registro2757919
    80143770001
    RICHARDSON, Giles Harvey Roberts
    Broadgate
    EC2M 2QS London
    1
    Director
    Broadgate
    EC2M 2QS London
    1
    EnglandBritish224284590001
    BANNER, Christopher
    86 Lexington Apartments
    40 City Road
    EC1Y 2AN London
    Secretario
    86 Lexington Apartments
    40 City Road
    EC1Y 2AN London
    British76044030002
    BANNER, Christopher John
    31 Wontner Road
    SW17 7QT London
    Secretario
    31 Wontner Road
    SW17 7QT London
    British76044030001
    CROMACK, Andrew Michael
    23 Knole Road
    ME5 8PJ Chatham
    Kent
    Secretario
    23 Knole Road
    ME5 8PJ Chatham
    Kent
    British78040930001
    DAVISON, Wayne Mark
    8 Plane Tree Close
    Shadwell
    LS17 8UF Leeds
    West Yorkshire
    Secretario
    8 Plane Tree Close
    Shadwell
    LS17 8UF Leeds
    West Yorkshire
    British70726990001
    GULLIVER, John Keith
    The Registry
    Royal Mint Court
    EC3N 4QN London
    Secretario
    The Registry
    Royal Mint Court
    EC3N 4QN London
    British147777590001
    HUTCHINSON, Robert William
    5 Old Mill Close
    Burley In Wharfedale
    LS29 7RU Ilkley
    West Yorkshire
    Secretario
    5 Old Mill Close
    Burley In Wharfedale
    LS29 7RU Ilkley
    West Yorkshire
    British49635190001
    LACEY, Stephen
    Broadgate
    EC2M 2QS London
    1
    England
    Secretario
    Broadgate
    EC2M 2QS London
    1
    England
    164063300001
    LOW, Peter
    The Registry
    Royal Mint Court
    EC3N 4QN London
    Secretario
    The Registry
    Royal Mint Court
    EC3N 4QN London
    148715640001
    LOW, Peter
    10 Union Square
    Islington
    N1 7DH London
    Secretario
    10 Union Square
    Islington
    N1 7DH London
    British65476890001
    STANNETT, Robert William
    Shalford
    GU4 8JN Guildford
    Northfield
    Surrey
    Secretario
    Shalford
    GU4 8JN Guildford
    Northfield
    Surrey
    British141063520001
    THOMSON, Alastair Iain Lindsay
    30 Roehampton Close
    SW15 5LU London
    Secretario
    30 Roehampton Close
    SW15 5LU London
    British60638430002
    BANNER, Christopher
    86 Lexington Apartments
    40 City Road
    EC1Y 2AN London
    Director
    86 Lexington Apartments
    40 City Road
    EC1Y 2AN London
    British76044030002
    DOLTON, Stephen
    99 Cumnor Hill
    OX2 9JR Oxford
    Director
    99 Cumnor Hill
    OX2 9JR Oxford
    British70990450005
    FAWCUS, Kier Murray
    Broadgate
    EC2M 2QS London
    1
    England
    Director
    Broadgate
    EC2M 2QS London
    1
    England
    EnglandBritish84594470002
    GULLIVER, John Keith
    The Registry
    Royal Mint Court
    EC3N 4QN London
    Director
    The Registry
    Royal Mint Court
    EC3N 4QN London
    United KingdomBritish147777590001
    HARKNESS, Peter Martin
    19 Horsley Court
    Montaigne Close Regency Street
    SW1 4BF London
    Director
    19 Horsley Court
    Montaigne Close Regency Street
    SW1 4BF London
    United KingdomBritish146757430001
    HAWORTH, John Roger
    Broadgate
    EC2M 2QS London
    1
    England
    Director
    Broadgate
    EC2M 2QS London
    1
    England
    EnglandBritish91354480002
    HILLIARD, Charles Stephen
    18 Albion Works Studios
    63 Sigdon Road
    E8 1AW London
    Director
    18 Albion Works Studios
    63 Sigdon Road
    E8 1AW London
    British104848990001
    JONES, Malcolm Richard
    Crossways Scotland Lane
    Horsforth
    LS18 5SF Leeds
    West Yorkshire
    Director
    Crossways Scotland Lane
    Horsforth
    LS18 5SF Leeds
    West Yorkshire
    British4700740001
    KINNEAR, James Broomfield
    2 Woodliffe Court
    LS7 3RF Leeds
    West Yorkshire
    Director
    2 Woodliffe Court
    LS7 3RF Leeds
    West Yorkshire
    British68573880002
    KNIGHT, Martin
    The Cuttings 57 Cheam Road
    East Ewell
    KT17 3EB Epsom
    Surrey
    Director
    The Cuttings 57 Cheam Road
    East Ewell
    KT17 3EB Epsom
    Surrey
    EnglandBritish13326400003
    LACEY, Stephen
    Broadgate
    EC2M 2QS London
    1
    England
    Director
    Broadgate
    EC2M 2QS London
    1
    England
    EnglandBritish88368490002
    LOW, Peter
    Broadgate
    EC2M 2QS London
    1
    England
    Director
    Broadgate
    EC2M 2QS London
    1
    England
    EnglandBritish65476890002
    MORRIS, Alec Malcolm, Mr.
    Bat Barn Morganhayes
    Southleigh
    EX24 6RY Colyton
    Devon
    Director
    Bat Barn Morganhayes
    Southleigh
    EX24 6RY Colyton
    Devon
    United KingdomBritish52256040002
    MORRIS, Pauline Ann
    Bat Barn Morganhayes
    Southleigh
    EX24 6RY Colyton
    Devon
    Director
    Bat Barn Morganhayes
    Southleigh
    EX24 6RY Colyton
    Devon
    British52256170002
    MORRISON, Deborah
    43c Mount Ephraim Road
    SW16 1LP London
    Director
    43c Mount Ephraim Road
    SW16 1LP London
    United KingdomBritish91218120001
    SHEPHERD, Jonathan Paul
    7 Hatton Close
    Chafford Hundred
    RM16 6RP Grays
    Essex
    Director
    7 Hatton Close
    Chafford Hundred
    RM16 6RP Grays
    Essex
    United KingdomBritish104848170001
    STANNETT, Robert William
    Shalford
    GU4 8JN Guildford
    Northfield
    Surrey
    Director
    Shalford
    GU4 8JN Guildford
    Northfield
    Surrey
    EnglandBritish141063520001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de CLIPABILITY LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Broadgate
    EC2M 2QS London
    1 Broadgate
    England
    03 sept 2016
    Broadgate
    EC2M 2QS London
    1 Broadgate
    England
    Forma jurídicaLimited Company
    País de registroEngland
    Autoridad legalCompanies Act 2006
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro4152862
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    Precise Media Group Holdings Limited
    Broadgate
    EC2M 2QS London
    1
    England
    06 abr 2016
    Broadgate
    EC2M 2QS London
    1
    England
    No
    Forma jurídicaPrivate Limited Company
    Autoridad legalCompanies Act 2006
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.

    ¿Tiene CLIPABILITY LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Fixed and floating charge
    Creado el 01 abr 2005
    Entregado el 20 abr 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland Commercial Services Limited
    Transacciones
    • 20 abr 2005Registro de un cargo (395)
    • 22 dic 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 01 abr 2005
    Entregado el 15 abr 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All present and future indebtedness liabilities and obligations due or to become due from any chargor or other member of the group to the chargee (the "security trustee") as agent and trustee for itself and each of the secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 15 abr 2005Registro de un cargo (395)
    • 22 dic 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    An omnibus guarantee and set-off agreement
    Creado el 02 jul 2003
    Entregado el 05 jul 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with the bank.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 05 jul 2003Registro de un cargo (395)
    • 23 abr 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    All assets debenture
    Creado el 30 sept 2002
    Entregado el 02 oct 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited Trading as Alex. Lawrie Factors
    Transacciones
    • 02 oct 2002Registro de un cargo (395)
    • 23 abr 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 14 may 2001
    Entregado el 17 may 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 17 may 2001Registro de un cargo (395)
    • 23 abr 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0